ECODRILL VENTURES

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéECODRILL VENTURES
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité illimitée
    Numéro de société SC096792
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ECODRILL VENTURES ?

    • (7415) /

    Où se situe ECODRILL VENTURES ?

    Adresse du siège social
    Lion House
    Dyce Avenue
    AB21 0LQ Aberdeen
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ECODRILL VENTURES ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EXAL SAMPLING SERVICES LIMITED19 févr. 198719 févr. 1987
    MERCURY SAMPLING SERVICES LIMITED20 févr. 198620 févr. 1986
    HADLARCH LIMITED15 janv. 198615 janv. 1986

    Quels sont les derniers comptes de ECODRILL VENTURES ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ECODRILL VENTURES ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ECODRILL VENTURES ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    11 pages4.26(Scot)

    Cessation de la nomination de Mark Collis en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Re-enregistrement de l'assentiment

    1 pagesFOA-RR

    Certificat de réimmatriculation de société à responsabilité limitée à société de personnes à responsabilité illimitée

    1 pagesCERT3

    Réenregistrement des statuts

    31 pagesMAR

    Re-enregistrement d'une société à responsabilité limitée privée en société à responsabilité illimitée privée

    2 pagesRR05

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 juin 2011

    État du capital au 28 juin 2011

    • Capital: GBP 55,003
    SH01

    Nomination de Mark Russell Collis en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Crump en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Gavin Prise en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mark Leslie Crump en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2009 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Résolutions

    Resolutions
    29 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    legacy

    1 pages288c

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    15 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Conflict of interest 10/10/2008
    RES13

    legacy

    4 pages363a

    Qui sont les dirigeants de ECODRILL VENTURES ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COX, Melanie Rachel
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    British96139050001
    MCALISTER, Lewis John Woodburn
    Woodburn House
    School Road, Ardington
    OX12 8PE Wantage
    Oxfordshire
    Administrateur
    Woodburn House
    School Road, Ardington
    OX12 8PE Wantage
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector114352170001
    AINGER, Colin Peter
    Cardwell House
    Pangbourne Road
    RG8 8LN Upper Basildon
    Berkshire
    Secrétaire
    Cardwell House
    Pangbourne Road
    RG8 8LN Upper Basildon
    Berkshire
    British40854710003
    DAND, Anthony Michael
    12 Branksome Court
    Prospect Street
    RG1 7XR Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    12 Branksome Court
    Prospect Street
    RG1 7XR Reading
    Berkshire
    British64623710001
    MCALISTER, Lewis John Woodburn
    Woodburn House
    School Road, Ardington
    OX12 8PE Wantage
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Woodburn House
    School Road, Ardington
    OX12 8PE Wantage
    Oxfordshire
    BritishCompany Director114352170001
    SCOTT, Sandra
    40 The Grove
    Ealing
    W5 5LH London
    Secrétaire
    40 The Grove
    Ealing
    W5 5LH London
    British75631110001
    WALTON, John
    9 Withy Close
    Tilehurst
    RG31 5SQ Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    9 Withy Close
    Tilehurst
    RG31 5SQ Reading
    Berkshire
    British10741000002
    PAULL & WILLIAMSONS
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Secrétaire
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    24280001
    PAULL & WILLIAMSONS
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Secrétaire
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    24280001
    AINGER, Colin Peter
    Cardwell House
    Pangbourne Road
    RG8 8LN Upper Basildon
    Berkshire
    Administrateur
    Cardwell House
    Pangbourne Road
    RG8 8LN Upper Basildon
    Berkshire
    BritishDirector40854710003
    COLLIS, Mark Russell
    Wallis Road
    RG21 3DW Basingstoke
    7
    Hants
    United Kingdom
    Administrateur
    Wallis Road
    RG21 3DW Basingstoke
    7
    Hants
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director157584200001
    CRUMP, Mark Leslie
    9 Birch Grove
    KT20 6QU Kingswood
    Oaklands
    England
    England
    Administrateur
    9 Birch Grove
    KT20 6QU Kingswood
    Oaklands
    England
    England
    EnglandBritishCompany Director104070730002
    DAWSON, John Hennessey
    Lawn Woodlands Road
    Shiplake
    RG9 4AA Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Lawn Woodlands Road
    Shiplake
    RG9 4AA Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    BritishCompany Director3107500001
    FEARNLEY, Kevan Walter
    Inverusk
    Strachan
    AB31 6NL Banchory
    Administrateur
    Inverusk
    Strachan
    AB31 6NL Banchory
    BritishCompany Director74050002
    HAITES, Binnert Ruerd
    32 Cairn Road
    Bieldside
    AB15 9AL Aberdeen
    Administrateur
    32 Cairn Road
    Bieldside
    AB15 9AL Aberdeen
    CanadaCompany Director74060001
    HENDERSON, Jeremy Neil
    Tillyfour House
    Tough
    AB33 8DX Alford
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Tillyfour House
    Tough
    AB33 8DX Alford
    Aberdeenshire
    BritishCompany Director73430001
    LUARD, Roger David Eckford
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    Administrateur
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    BritishCompany Director28242190001
    MARTINDALE, Michael John
    15 Sandown Avenue
    KT10 9NT Esher
    Surrey
    Administrateur
    15 Sandown Avenue
    KT10 9NT Esher
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director84743190001
    MASSIE, Keith James
    42 Thomson Street
    AB2 4QP Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    42 Thomson Street
    AB2 4QP Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishField Analysis Engineer907610001
    MAYNE, James Edward Mosley
    18 North Street
    LE13 1NL Melton Mowbray
    Leicestershire
    Administrateur
    18 North Street
    LE13 1NL Melton Mowbray
    Leicestershire
    United KingdomBritishCompany Director6403900001
    PRISE, Gavin Jonathan
    East Brotherfield
    Kingswell
    AB1 8QN Aberdeen
    Administrateur
    East Brotherfield
    Kingswell
    AB1 8QN Aberdeen
    BritishCompany Director76047030002
    TORRINGTON, Timothy Howard St George, The Viscount
    Great Hunts Place
    Owslebury
    SO21 1JL Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    Great Hunts Place
    Owslebury
    SO21 1JL Winchester
    Hampshire
    BritishCompany Director3107510001
    WILKINS, Ian Clive
    10 Holmemoor Drive
    Sonning
    RG4 0TE
    Berkshire
    Administrateur
    10 Holmemoor Drive
    Sonning
    RG4 0TE
    Berkshire
    BritishCompany Director3107520001
    WOOLLEY, Eric Rhys
    6 Breedons Hill
    RG8 7AT Pangbourne
    Berkshire
    Administrateur
    6 Breedons Hill
    RG8 7AT Pangbourne
    Berkshire
    BritishFinance Director98676700001

    ECODRILL VENTURES a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 10 avr. 2000
    Livré le 20 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee
    Transactions
    • 20 avr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 14 août 1998
    Livré le 21 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 août 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 10 mars 1995
    Livré le 28 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 mars 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 30 juil. 1992
    Livré le 19 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All freehold and leasehold property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 19 août 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 30 juil. 1992
    Livré le 19 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 19 août 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 30 juin 1988
    Livré le 20 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 20 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 29 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 08 mai 1986
    Livré le 14 mai 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 mai 1986Enregistrement d'une charge
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 29 avr. 1986
    Livré le 14 mai 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC
    Transactions
    • 14 mai 1986Enregistrement d'une charge
    • 04 août 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • 07 août 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • 08 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui

    ECODRILL VENTURES a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 janv. 2016Dissolved on
    30 mars 2012Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0