ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED

ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social
    Numéro de société SC096855
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED ?

    • Autres travaux de construction spécialisés n.d.a. (43999) / Construction

    Où se situe ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    11th Floor, Room 1110 Clockwise Offices, Savoy Tower
    77 Renfrew Street
    G2 3BZ Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 juil. 2018
    Date d'échéance des prochains comptes30 avr. 2019
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2017

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au25 nov. 2019
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation09 déc. 2019
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au25 nov. 2018
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Ordonnance du tribunal

    Order of court - dissolution void
    1 pagesOC-DV

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans CVL

    21 pagesLIQ14(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de 11th Floor, Room 1110, Clockwise Offices Savoy Tower 77 Renfrew Street Glasgow G3 3BZ à 11th Floor, Room 1110 Clockwise Offices, Savoy Tower 77 Renfrew Street Glasgow G2 3BZ le 30 sept. 2022

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de 4/2, 100 West Regent Street Glasgow G2 2QD à 11th Floor, Room 1110, Clockwise Offices Savoy Tower 77 Renfrew Street Glasgow G3 3BZ le 07 juin 2022

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de 50 Melville Street Edinburgh EH3 7HF Scotland à 4/2, 100 West Regent Street Glasgow G2 2QD le 01 juil. 2019

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 23 avr. 2019

    LRESEX

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Carol Dora Brodie en tant que directeur le 25 mars 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Peter Trevor Reid en tant que directeur le 25 mars 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Alexander Mckinney en tant que directeur le 22 mars 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Graeme Leslie Hadden en tant que directeur le 22 mars 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Bruce Dickson en tant que directeur le 22 mars 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Patrick Robertson Gammell en tant que directeur le 25 janv. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 25 nov. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Sarah Jane Spurgeon Grotrian en tant que directeur le 02 nov. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Graeme Leslie Hadden en tant qu'administrateur le 02 nov. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Sarah Jane Spurgeon Grotrian en tant qu'administrateur le 15 sept. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Dr Peter Trevor Reid en tant qu'administrateur le 15 sept. 2017

    2 pagesAP01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 juil. 2017

    31 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 25 nov. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr David Bruce Dickson en tant qu'administrateur le 15 sept. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr John Arthur Conway en tant qu'administrateur le 15 sept. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Neil Woodcock en tant qu'administrateur le 01 oct. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Graham John Thomson Forbes en tant que directeur le 15 sept. 2017

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JEFFCOAT, David Charles Elessing
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    77 Renfrew Street
    G2 3BZ Glasgow
    11th Floor, Room 1110
    Secrétaire
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    77 Renfrew Street
    G2 3BZ Glasgow
    11th Floor, Room 1110
    238863640001
    CONWAY, John Arthur, The Very Reverend
    Lansdowne Crescent
    EH12 5EQ Edinburgh
    8
    Scotland
    Administrateur
    Lansdowne Crescent
    EH12 5EQ Edinburgh
    8
    Scotland
    ScotlandBritish239459530001
    WOODCOCK, Neil
    Lennox Row
    EH5 3HL Edinburgh
    3
    Scotland
    Administrateur
    Lennox Row
    EH5 3HL Edinburgh
    3
    Scotland
    ScotlandBritish1198420001
    BEBER, Sheila Hemingway
    12 Buckingham Terrace
    EH4 3AA Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    12 Buckingham Terrace
    EH4 3AA Edinburgh
    Midlothian
    British56580001
    BRUCE, Alexander James Arbuthnot
    4 Great Stuart Street
    EH3 6AW Edinburgh
    Secrétaire
    4 Great Stuart Street
    EH3 6AW Edinburgh
    British1286720002
    JEFFCOAT, Marilyn Annette
    Mill Wynd
    KY15 7BU Falkland
    Stag House
    Fife
    United Kingdom
    Secrétaire
    Mill Wynd
    KY15 7BU Falkland
    Stag House
    Fife
    United Kingdom
    British63483550003
    BARBER, Joe Millar
    Bridgelands
    TD7 4PT Selkirk
    Administrateur
    Bridgelands
    TD7 4PT Selkirk
    British781870001
    BRODIE, Carol Dora, Lady
    Cobden Crescent
    EH9 2BG Edinburgh
    21
    Administrateur
    Cobden Crescent
    EH9 2BG Edinburgh
    21
    United KingdomBritish133066050001
    BRUCE, Mary Hope
    4 Great Stuart Street
    EH3 6AW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    4 Great Stuart Street
    EH3 6AW Edinburgh
    Midlothian
    British56640001
    CROSFIELD, George Philip Chorley
    8 Lansdowne Crescent
    EH12 5EQ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    8 Lansdowne Crescent
    EH12 5EQ Edinburgh
    Midlothian
    British132990001
    DICKSON, David Bruce
    Millbank
    EH17 7GA Balerno
    13
    Scotland
    Administrateur
    Millbank
    EH17 7GA Balerno
    13
    Scotland
    ScotlandBritish215033080001
    FORBES, Donald James
    33 Coates Gardens
    EH12 5LG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    33 Coates Gardens
    EH12 5LG Edinburgh
    Midlothian
    British56600001
    FORBES, Graham John Thomson, The Very Reverend Dr
    8 Lansdowne Crescent
    EH12 5EQ Edinburgh
    Administrateur
    8 Lansdowne Crescent
    EH12 5EQ Edinburgh
    United KingdomBritish37943660001
    GAMMELL, Patrick Robertson
    The Old Manse
    Morham
    EH41 4LQ Haddington
    East Lothian
    Administrateur
    The Old Manse
    Morham
    EH41 4LQ Haddington
    East Lothian
    ScotlandBritish285170001
    GROTRIAN, Sara Jane Spurgeon
    Castleview
    Hawthornden
    EH18 1EJ Lasswade
    Midlothian
    Administrateur
    Castleview
    Hawthornden
    EH18 1EJ Lasswade
    Midlothian
    British125519150001
    GROTRIAN, Sarah Jane Spurgeon
    Hawthornden
    EH18 1EJ Lasswade
    Castleview
    Scotland
    Administrateur
    Hawthornden
    EH18 1EJ Lasswade
    Castleview
    Scotland
    ScotlandBritish128914330001
    GUILD, Ivor Reginald
    The New Club
    86 Princes Street
    EH2 2BB Edinburgh
    Administrateur
    The New Club
    86 Princes Street
    EH2 2BB Edinburgh
    United KingdomBritish41504740001
    HADDEN, Graeme Leslie
    Melville Street
    EH3 7HF Edinburgh
    50
    Scotland
    Administrateur
    Melville Street
    EH3 7HF Edinburgh
    50
    Scotland
    ScotlandBritish222881990001
    JEFFCOAT, Marilyn Annette
    Mill Wynd
    KY15 7BU Falkland
    Stag House
    Fife
    Administrateur
    Mill Wynd
    KY15 7BU Falkland
    Stag House
    Fife
    ScotlandBritish63483550005
    MARKS, Frederick Charles
    Dunkeld 33 Townhill Road
    KY12 0JD Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    Dunkeld 33 Townhill Road
    KY12 0JD Dunfermline
    Fife
    British135790001
    MCKINLAY, Peter, Cbe
    Braemoray
    11 Alexander Third Street
    HY3 9SD Kinghorn
    Fife
    Administrateur
    Braemoray
    11 Alexander Third Street
    HY3 9SD Kinghorn
    Fife
    British60892980001
    MCKINNEY, John Alexander
    Edderston Ridge
    EH45 9NA Peebles
    9
    Scotland
    Administrateur
    Edderston Ridge
    EH45 9NA Peebles
    9
    Scotland
    ScotlandBritish118061190002
    REID, Peter Trevor, Dr
    Cumin Place
    EH9 2JX Edinburgh
    19
    Scotland
    Administrateur
    Cumin Place
    EH9 2JX Edinburgh
    19
    Scotland
    ScotlandBritish166999500002
    TUDOR, James Brian
    15 Midmar Gardens
    EH10 6DY Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    15 Midmar Gardens
    EH10 6DY Edinburgh
    Midlothian
    Great BritainBritish56630001
    WALKER, William Alexander
    40 Cherry Tree Gardens
    EH14 5SP Balerno
    Midlothian
    Administrateur
    40 Cherry Tree Gardens
    EH14 5SP Balerno
    Midlothian
    British56610001
    YOUNG, David Tod
    4 High Street
    Auchtermuchty
    KY14 7AT Cupar
    Fife
    Administrateur
    4 High Street
    Auchtermuchty
    KY14 7AT Cupar
    Fife
    British56650001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    25 nov. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    ST MARY'S CATHEDRAL WORKSHOP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 avr. 2019Commencement of winding up
    03 févr. 2024Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0