THE ABERCROMBY MOTOR GROUP LIMITED

THE ABERCROMBY MOTOR GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE ABERCROMBY MOTOR GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC097271
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE ABERCROMBY MOTOR GROUP LIMITED ?

    • Vente de voitures neuves et de véhicules légers (45111) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Vente de voitures d'occasion et de véhicules légers (45112) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe THE ABERCROMBY MOTOR GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5th Floor Quartermile Two
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    Midlothian
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE ABERCROMBY MOTOR GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    STIRLING & WILSON LIMITED21 août 198621 août 1986
    COUNTY GARAGES (SCOTLAND) LIMITED13 mars 198613 mars 1986
    TONEHURST LIMITED12 févr. 198612 févr. 1986

    Quels sont les derniers comptes de THE ABERCROMBY MOTOR GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour THE ABERCROMBY MOTOR GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Satisfaction de la charge 16 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 15 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 25 en totalité

    4 pagesMR04

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 24 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 22 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 20 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 17 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 21 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    4 pagesMR04

    État du capital après une attribution d'actions au 22 mars 2013

    • Capital: GBP 4,014,102.05
    4 pagesSH01

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    État du capital au 20 mars 2013

    • Capital: GBP 4,103,992.00
    6 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital au 26 févr. 2013

    • Capital: GBP 4,150,000.00
    7 pagesSH19

    Deuxième dépôt de AR01 précédemment soumis à Companies House mis à jour jusqu'au 31 déc. 2012

    16 pagesRP04

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    2 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Qui sont les dirigeants de THE ABERCROMBY MOTOR GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MORTON FRASER SECRETARIES LIMITED
    Floor, Quartermile Two
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    5th
    Midlothian
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor, Quartermile Two
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    5th
    Midlothian
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC262093
    95512800001
    CUNNINGHAM, Alaster Patrick
    40 Barnton Avenue
    EH4 6JL Edinburgh
    Administrateur
    40 Barnton Avenue
    EH4 6JL Edinburgh
    ScotlandBritish491740001
    BIGGART, David Robert Reid
    122 Parkneuk Street
    ML1 1BY Motherwell
    North Lanarkshire
    Secrétaire
    122 Parkneuk Street
    ML1 1BY Motherwell
    North Lanarkshire
    British56426600001
    HILL, Elaine Janet
    13 Beresford Avenue
    EH5 3EU Edinburgh
    Secrétaire
    13 Beresford Avenue
    EH5 3EU Edinburgh
    British58727030001
    OLIVER, Richard Alan
    81 Aller Place
    Eliburn
    EH54 6RG Livingston
    West Lothian
    Secrétaire
    81 Aller Place
    Eliburn
    EH54 6RG Livingston
    West Lothian
    British66588090001
    PURSLOW, Ian William
    69 North Meggetland
    EH14 1XQ Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    69 North Meggetland
    EH14 1XQ Edinburgh
    Midlothian
    British985950001
    SCRIMGEOUR, Alan
    146 Echline Drive
    EH30 9XG South Queensferry
    West Lothian
    Secrétaire
    146 Echline Drive
    EH30 9XG South Queensferry
    West Lothian
    British782490001
    MORTON FRASER
    30/31 Queen Street
    EH2 1JX Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    30/31 Queen Street
    EH2 1JX Edinburgh
    Midlothian
    61803790002
    CLYNE, Alexander Thomas
    8 Glen View
    EH51 0PQ Boness
    West Lothian
    Uk
    Administrateur
    8 Glen View
    EH51 0PQ Boness
    West Lothian
    Uk
    ScotlandBritish52096290002
    DRY, Lewis Graham
    19/2 Great King Street
    EH3 6QW Edinburgh
    Administrateur
    19/2 Great King Street
    EH3 6QW Edinburgh
    British56426420002
    OLIVER, Richard Alan
    81 Aller Place
    Eliburn
    EH54 6RG Livingston
    West Lothian
    Administrateur
    81 Aller Place
    Eliburn
    EH54 6RG Livingston
    West Lothian
    British66588090001
    PRINGLE, Heather
    5 Allan Park Loan
    EH14 1LG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    5 Allan Park Loan
    EH14 1LG Edinburgh
    Midlothian
    British492620001
    PURSLOW, Ian William
    69 North Meggetland
    EH14 1XQ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    69 North Meggetland
    EH14 1XQ Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish985950001
    SCRIMGEOUR, Alan
    146 Echline Drive
    EH30 9XG South Queensferry
    West Lothian
    Administrateur
    146 Echline Drive
    EH30 9XG South Queensferry
    West Lothian
    British782490001
    SMITH, Rodney Philip
    5 The Paddock
    Sandyloan
    EH31 2BW Gullane
    East Lothian
    Administrateur
    5 The Paddock
    Sandyloan
    EH31 2BW Gullane
    East Lothian
    British34802220002

    THE ABERCROMBY MOTOR GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 18 mai 2010
    Livré le 04 juin 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 juin 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 10 mai 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 10 févr. 1997
    Livré le 13 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Garage premises at 152 west marketgait,dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 févr. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 mai 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 22 juil. 1996
    Livré le 06 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All motor vehicles....... See ch microfiche for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 06 août 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 oct. 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 31 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 12 juin 1996
    Livré le 18 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Kerse road,stirling.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 juin 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 mai 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 13 avr. 1995
    Livré le 20 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1.148 acres on the north east side of seafield road, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 avr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 mai 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 31 mars 1995
    Livré le 11 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Units 1, 2, 3, 4, 5 & 6 abercromby court, halbeath.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 avr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 mai 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 28 mars 1995
    Livré le 06 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All stock of motor vehicles.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 06 avr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 juin 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Assignation
    Créé le 10 août 1994
    Livré le 15 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All those monies which from time to time be owing to abercromby motor group limited by V.A.g(united kingdom)limited in respect of refunds of monies paid by or by the direction of abercromby motor group limited to V.A.g(unit kingdom)limited by way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a cosignment basis.the assignation provides that abercromby motor group limited shall not without prior written consent of volkswagen financial services (UK) LTD. Create or permit to come into being any mortgage charge or assigment in respect of the monies assigned by the assignation.
    Personnes ayant droit
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    Transactions
    • 15 août 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 06 déc. 1993
    Livré le 20 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Abercromby court, 20 seafield road east, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 déc. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 mai 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 01 déc. 1993
    Livré le 06 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 déc. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 avr. 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 juin 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 juin 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 09 oct. 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 10 mai 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 27 août 1993
    Livré le 08 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 sept. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 avr. 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 juin 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 juin 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 09 oct. 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 10 mai 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 29 mars 1993
    Livré le 14 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due to a maximum of £215,000
    Brèves mentions
    All stocks of used motor vehicles owned or to be owned by the company in connection with their rover dealership carried on at their seafield road east depot, edinburgh or at any other depot to which that dealership may be transferred.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 14 avr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 sept. 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 avr. 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 avr. 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 28 avr. 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 19 déc. 1991
    Livré le 06 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Marine works seafield road east edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The British Linen Bank Limited
    Transactions
    • 06 janv. 1992Enregistrement d'une charge
    • 13 janv. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 16 juil. 1991
    Livré le 23 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    33/39 west savile terrace, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 02 mai 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 16 juil. 1991
    Livré le 23 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.377 hq to the south west of kerse road broadleys 2ND estate kerse road, stirling.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 27 avr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • 02 mai 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignation in security
    Créé le 25 avr. 1991
    Livré le 29 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All refunds of monies by way of a deposit on the acquisition of motor vehicles supplied by v a g and m a n.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 29 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 17 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 16 mars 1991
    Livré le 23 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Belston garage belston.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 02 mai 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 31 juil. 1990
    Acquis le 16 juil. 1991
    Livré le 06 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground at graigentinny avenue, north,edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The British Linen Bank Limited
    Transactions
    • 06 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 02 mai 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 31 juil. 1990
    Acquis le 16 juil. 1991
    Livré le 06 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.605 acres at 69 marionville road,edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The British Linen Bank Limited
    Transactions
    • 06 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 13 janv. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignation in security
    Créé le 27 févr. 1989
    Livré le 07 mars 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The company's whole right to receive payment or return of all monies at present due or which may at any time be or become due as in master agreement dated 1/10/86.
    Personnes ayant droit
    • N W S Trust LTD
    Transactions
    • 07 mars 1989Enregistrement d'une charge
    • 17 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 22 déc. 1988
    Livré le 29 déc. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • N W S Trust LTD
    Transactions
    • 29 déc. 1988Enregistrement d'une charge
    • 17 août 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 sept. 1994Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 19 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 26 août 1986
    Livré le 28 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 août 1986Enregistrement d'une charge
    • 13 mars 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • 19 mars 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0