J. & A.L. KING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJ. & A.L. KING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC100092
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de J. & A.L. KING LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe J. & A.L. KING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ritson Smith
    16 Carden Place
    AB10 1FX Aberdeen
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de J. & A.L. KING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BUE INTERNATIONAL MARINE LIMITED11 sept. 198611 sept. 1986
    RONARD LIMITED16 juil. 198616 juil. 1986

    Quels sont les derniers comptes de J. & A.L. KING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour J. & A.L. KING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Hugh Angus Selden Berridge en tant que secrétaire le 17 janv. 2012

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2011

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 juin 2011

    État du capital au 29 juin 2011

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2010

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes établis au 31 mars 2009

    6 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 mars 2008

    7 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 mars 2007

    5 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 31 mars 2006

    6 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    Comptes établis au 31 mars 2005

    4 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de J. & A.L. KING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KING, Andrew William
    38 Campden Street
    W8 7ET London
    Administrateur
    38 Campden Street
    W8 7ET London
    EnglandBritishSurveyor111007640003
    KING, Edward Joseph
    Cringleford Hall
    Intwood Road Cringleford
    NR4 6TH Norwich
    Administrateur
    Cringleford Hall
    Intwood Road Cringleford
    NR4 6TH Norwich
    EnglandBritishSurveyor38461070004
    BERRIDGE, Hugh Angus Selden
    48 Bishopgate
    NR1 4AA Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    48 Bishopgate
    NR1 4AA Norwich
    Norfolk
    BritishSolicitor43283310001
    DAVIS, Richard Paul
    Ambersham House
    Estuary Crescent Shotley Gate
    IP9 2QA Ipswich
    Suffolk
    Secrétaire
    Ambersham House
    Estuary Crescent Shotley Gate
    IP9 2QA Ipswich
    Suffolk
    British9506230001
    KING, Alison Lindsay
    Cringleford Hall
    Intwood Road
    NR4 6TH Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    Cringleford Hall
    Intwood Road
    NR4 6TH Norwich
    Norfolk
    British3635760003
    TAYLOR, George Alastair
    1 Hillpark Crescent
    EH4 7BG Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    1 Hillpark Crescent
    EH4 7BG Edinburgh
    Midlothian
    British200330002
    DAVIS, Richard Paul
    Ambersham House
    Estuary Crescent Shotley Gate
    IP9 2QA Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    Ambersham House
    Estuary Crescent Shotley Gate
    IP9 2QA Ipswich
    Suffolk
    BritishChartered Secretary9506230001
    EDE, David
    53 St Ternans Road
    Newtonhill
    AB3 2PF Stonehaven
    Kincardineshire
    Administrateur
    53 St Ternans Road
    Newtonhill
    AB3 2PF Stonehaven
    Kincardineshire
    BritishCompany Director200360001
    HENDRIE, Paul William
    70 Marine Parade
    Gorleston
    NR31 6EZ Great Yarmouth
    Norfolk
    Administrateur
    70 Marine Parade
    Gorleston
    NR31 6EZ Great Yarmouth
    Norfolk
    BritishCompany Director330100001
    KING, Alison Lindsay
    Cringleford Hall
    Intwood Road
    NR4 6TH Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Cringleford Hall
    Intwood Road
    NR4 6TH Norwich
    Norfolk
    British3635760003
    KING, Joseph
    Cringleford Hall
    Intwood Road
    NR4 6TH Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Cringleford Hall
    Intwood Road
    NR4 6TH Norwich
    Norfolk
    SwitzerlandBritishCompany Director141443630001
    KING, Lindsay Jane
    34 Arundel Gardens
    W11 2LB London
    Administrateur
    34 Arundel Gardens
    W11 2LB London
    BritishSales Consultant92531890001
    LINDSELL, Philip Edmund
    Southside Cottage
    Stone Lane Axford
    SN8 2EY Marlborough
    Wiltshire
    Administrateur
    Southside Cottage
    Stone Lane Axford
    SN8 2EY Marlborough
    Wiltshire
    BritishExecutive101775640001
    MILLER, James Galbraith
    Lauder House
    EH40 3 East Linton
    East Lothian
    Administrateur
    Lauder House
    EH40 3 East Linton
    East Lothian
    BritishCompany Director200350001
    PARKER, Philip Hull
    1 Quarry Lane
    Lower Shiplake
    RG9 3JW Henley
    Oxfordshire
    Administrateur
    1 Quarry Lane
    Lower Shiplake
    RG9 3JW Henley
    Oxfordshire
    BritishCompany Director99496350001
    ROLASTON, Carl Geoffrey
    36 Kinellan Road
    EH12 6ES Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    36 Kinellan Road
    EH12 6ES Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishCompany Director65165500001
    TAYLOR, George Alastair
    1 Hillpark Crescent
    EH4 7BG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    1 Hillpark Crescent
    EH4 7BG Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishAccountant200330002

    J. & A.L. KING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of covenants
    Créé le 20 août 1987
    Livré le 09 sept. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    M.V. "british fulmar" reg leith 800532. the earnings of the ship.
    Personnes ayant droit
    • See P. 3 Continuation Sheet
    Transactions
    • 09 sept. 1987Enregistrement d'une charge
    Security agreement
    Créé le 20 août 1987
    Livré le 09 sept. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All amounts credited to or standing to the credit of the earnings account.
    Personnes ayant droit
    • See P. 3 Continuation Sheet
    Transactions
    • 09 sept. 1987Enregistrement d'une charge
    First statutory mortgage
    Créé le 20 août 1987
    Livré le 09 sept. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    M.V. "british fulmar" regd leith no. 800532.
    Personnes ayant droit
    • See P. 3 Continuation Sheet
    Transactions
    • 09 sept. 1987Enregistrement d'une charge
    Deed of covenants
    Créé le 06 juil. 1987
    Livré le 15 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due see page 1 of doc
    Brèves mentions
    M.V. "british heather" and earnings.
    Personnes ayant droit
    • See Continuation Sheets of Doc
    Transactions
    • 15 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    First statutory mortgage
    Créé le 06 juil. 1987
    Livré le 15 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due see page 1 of doc
    Brèves mentions
    M.V. "british heather" regd. Leith.
    Personnes ayant droit
    • See Continuation Sheets of Doc
    Transactions
    • 15 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    1ST statutory mortgage
    Créé le 08 mai 1987
    Livré le 14 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    M.V. british tartan regd. Leith 800510.
    Personnes ayant droit
    • Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale and Others
    Transactions
    • 14 mai 1987Enregistrement d'une charge
    Deed of covenants
    Créé le 01 mai 1987
    Livré le 14 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    M.V. british tartan regd leith no 800510.
    Personnes ayant droit
    • Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale and Others
    Transactions
    • 14 mai 1987Enregistrement d'une charge
    Security agreement
    Créé le 01 mai 1987
    Livré le 14 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All amounts credited to or standing to the credit of the earnings account.
    Personnes ayant droit
    • Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale and Others
    Transactions
    • 14 mai 1987Enregistrement d'une charge
    Deed of covenants
    Créé le 05 mars 1987
    Livré le 13 mars 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The above ship earnings requisition compensation.
    Personnes ayant droit
    • Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale and Others
    Transactions
    • 13 mars 1987Enregistrement d'une charge
    1ST statutory mortgage
    Créé le 05 mars 1987
    Livré le 13 mars 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    M.V. "british emerald" regd leith no 704631.
    Personnes ayant droit
    • Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale and Others
    Transactions
    • 13 mars 1987Enregistrement d'une charge
    Security agreement
    Créé le 26 janv. 1987
    Livré le 12 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All amounts credited to standing to the credit of the earnings account.
    Personnes ayant droit
    • Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale and Others
    Transactions
    • 12 févr. 1987Enregistrement d'une charge
    Deed of covenants
    Créé le 26 janv. 1987
    Livré le 12 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    M.V. "british piper" regd 704630.
    Personnes ayant droit
    • Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale and Others
    Transactions
    • 12 févr. 1987Enregistrement d'une charge
    First statutory mortgage
    Créé le 26 janv. 1987
    Livré le 12 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Mv "british piper" regd 704630.
    Personnes ayant droit
    • Landeshank Schleswig-Holstein Girozentrale and Others
    Transactions
    • 12 févr. 1987Enregistrement d'une charge
    Security agreement
    Créé le 26 janv. 1987
    Livré le 10 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All amounts due to or outstanding to the credit of the earnings account.
    Personnes ayant droit
    • Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale and Others
    Transactions
    • 10 févr. 1987Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0