WEST MINCH SALMON LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWEST MINCH SALMON LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC100097
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WEST MINCH SALMON LIMITED ?

    • Pêche en eau douce (03120) / Agriculture, sylviculture et pêche

    Où se situe WEST MINCH SALMON LIMITED ?

    Adresse du siège social
    30 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WEST MINCH SALMON LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour WEST MINCH SALMON LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Changement d'adresse du siège social de 8 Melville Crescent Edinburgh EH3 7JA Scotland à 30 Semple Street Edinburgh EH3 8BL le 01 avr. 2021

    1 pagesAD01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 oct. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 28 oct. 2020

    • Capital: GBP 1.75
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Craig Anderson en tant que directeur le 23 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Jóhan Regin Jacobsen en tant qu'administrateur le 13 déc. 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Odd Eliasen en tant qu'administrateur le 13 déc. 2019

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 28 oct. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    6 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 8 Melville Crescent Edinburgh EH3 7LU Scotland à 8 Melville Crescent Edinburgh EH3 7JA le 13 mai 2019

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Excel House, 30 Semple Street Edinburgh EH3 8BL Scotland à 8 Melville Crescent Edinburgh EH3 7LU le 13 mai 2019

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Morisons Secretaries Limited en tant que secrétaire le 30 avr. 2019

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de C/O Morisons Llp 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8AN à Excel House, 30 Semple Street Edinburgh EH3 8BL le 30 avr. 2019

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 28 oct. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 oct. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 oct. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    18 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de WEST MINCH SALMON LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COX, Susan Margaret
    Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    30
    Scotland
    Administrateur
    Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    30
    Scotland
    ScotlandBritish98112250001
    ELIASEN, Odd
    Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    30
    Scotland
    Administrateur
    Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    30
    Scotland
    Faroe IslandsDanish265284660001
    JACOBSEN, Jóhan Regin
    Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    30
    Scotland
    Administrateur
    Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    30
    Scotland
    Faroe IslandsDanish265284920001
    MACMILLAN, Angus Andrew
    Ardmore
    Iochdar
    HS8 5QY South Uist
    Secrétaire
    Ardmore
    Iochdar
    HS8 5QY South Uist
    British187640001
    MORISONS SECRETARIES LIMITED
    c/o Morisons Llp
    Exchange Crescent
    Conference Square
    EH3 8AN Edinburgh
    1
    Scotland
    Secrétaire
    c/o Morisons Llp
    Exchange Crescent
    Conference Square
    EH3 8AN Edinburgh
    1
    Scotland
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC234409
    83549280002
    ANDERSON, Craig
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    Scotland
    Administrateur
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    Scotland
    ScotlandBritish179195860001
    CORBETT, Michael
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    United Kingdom
    United KingdomIrish155490350001
    MACMILLAN, Angus Andrew
    Ardmore
    Iochdar
    HS8 5QY South Uist
    Administrateur
    Ardmore
    Iochdar
    HS8 5QY South Uist
    United KingdomBritish187640001
    MACMILLAN, Elizabeth Julia
    1 Ardmore
    South Uist
    HS8 5QY Iochdar
    Western Isles
    Administrateur
    1 Ardmore
    South Uist
    HS8 5QY Iochdar
    Western Isles
    United KingdomBritish93049130001
    MCLELLAND, Stewart
    c/o Morisons Llp
    68
    Queen Street
    EH2 4NN Edinburgh
    Erskine House
    Scotland
    Administrateur
    c/o Morisons Llp
    68
    Queen Street
    EH2 4NN Edinburgh
    Erskine House
    Scotland
    ScotlandBritish157009150001
    WHITE, Clare
    c/o Morisons Llp
    68
    Queen Street
    EH2 4NN Edinburgh
    Erskine House
    Administrateur
    c/o Morisons Llp
    68
    Queen Street
    EH2 4NN Edinburgh
    Erskine House
    ScotlandBritish184592190001
    WILSON, Robert
    c/o Morisons Llp
    68
    Queen Street
    EH2 4NN Edinburgh
    Erskine House
    Scotland
    Administrateur
    c/o Morisons Llp
    68
    Queen Street
    EH2 4NN Edinburgh
    Erskine House
    Scotland
    ScotlandBritish84079420001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WEST MINCH SALMON LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    Scotland
    06 avr. 2016
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueCompany Limited By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc107275
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    WEST MINCH SALMON LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 29 mars 2012
    Livré le 04 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Dnb Bank Asa
    Transactions
    • 04 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 10 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 29 oct. 2009
    Livré le 04 nov. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 04 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 20 nov. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 23 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 30 mars 2004
    Livré le 07 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Crooked river hatchery, lochboisdale, south uist (title number INV5474).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 avr. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 09 sept. 2003
    Livré le 30 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £120,000
    Brèves mentions
    Area of ground extending to 0.128 gectares at daliburgh, county of inverness.
    Personnes ayant droit
    • S & S Smolts Limited
    Transactions
    • 30 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Ship mortgage
    Créé le 17 mai 2001
    Livré le 07 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    64 shares on vessel lochvisgebhagh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 juin 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 22 nov. 1996
    Livré le 03 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The property known as gramsdale factory,isle of south uist,inverness.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 déc. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 08 nov. 1996
    Livré le 14 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land at carnan,south uist.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 nov. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Bond & floating charge
    Créé le 18 nov. 1995
    Livré le 01 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 déc. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 nov. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 09 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 01 avr. 1993
    Livré le 16 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    4.5 acres of land at carnan, eochar, south uist as relative to disposition by trustees of the deceased dame emily e s g cathcart in favour of john maclean recorded G.R.S. 09/11/35.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 avr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 01 août 1988
    Livré le 10 août 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 août 1988Enregistrement d'une charge
    • 16 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Instrument of charge
    Créé le 16 juil. 1986
    Livré le 25 juil. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Highlands and Islands Development Board
    Transactions
    • 25 juil. 1986Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0