AMBION HOMES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAMBION HOMES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC100104
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AMBION HOMES LIMITED ?

    • Construction d'autres ouvrages de génie civil n.d.a. (42990) / Construction

    Où se situe AMBION HOMES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Peregrine House, Mosscroft Avenue Westhill Business Park
    Westhill
    AB32 6JQ Aberdeen
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AMBION HOMES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LOVELL HOMES (SCOTLAND) LIMITED 30 sept. 198830 sept. 1988
    LOVELL LAWRENCE LIMITED03 oct. 198603 oct. 1986
    DRAUF LIMITED17 juil. 198617 juil. 1986

    Quels sont les derniers comptes de AMBION HOMES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour AMBION HOMES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01
    XCY82M23

    Changement d'adresse du siège social de Peregrine House Mosscroft Avenue Westhill Business Park Aberdeenshire AB32 6TQ à Peregrine House, Mosscroft Avenue Westhill Business Park Westhill Aberdeen AB32 6JQ le 01 août 2023

    1 pagesAD01
    XC8ZICDU

    Déclaration de confirmation établie le 22 mars 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XC0UZKSI

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2022

    4 pagesAA
    SBZBJJVF

    Déclaration de confirmation établie le 22 mars 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XB17TGGH

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2021

    4 pagesAA
    SB0EZQBU

    Déclaration de confirmation établie le 22 mars 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XA1J4U6W

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020

    4 pagesAA
    S9ZKFHLV

    Nomination de Robert Fraser Pearson Park en tant que secrétaire le 03 sept. 2020

    2 pagesAP03
    X9DD7H4G

    Cessation de la nomination de Michael Sinclair Medine en tant que secrétaire le 03 sept. 2020

    1 pagesTM02
    X9CUP1X4

    Cessation de la nomination de James Crawford en tant que directeur le 31 juil. 2020

    1 pagesTM01
    X9AFMWIQ

    Nomination de Mr Gerald Campbell More en tant qu'administrateur le 26 juin 2020

    2 pagesAP01
    X987VXJ5

    Déclaration de confirmation établie le 22 mars 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X91LJSFC

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019

    4 pagesAA
    S8YD4N5K

    Nomination de Mr Robert Fraser Pearson Park en tant qu'administrateur le 23 avr. 2019

    2 pagesAP01
    X89FGHIG

    Déclaration de confirmation établie le 22 mars 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01
    X827YM1F

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018

    4 pagesAA
    S7ZX7VA3

    Nomination de Mr Michael Sinclair Medine en tant que secrétaire le 12 juil. 2018

    2 pagesAP03
    X7AGHU2I

    Cessation de la nomination de Scott Craig Martin en tant que secrétaire le 12 juil. 2018

    1 pagesTM02
    X7AE01AG

    Déclaration de confirmation établie le 22 mars 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01
    X75533Q3

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2017

    4 pagesAA
    S72Q8E5L

    Déclaration de confirmation établie le 22 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01
    X656BGM1

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016

    4 pagesAA
    S63B11UJ

    Qui sont les dirigeants de AMBION HOMES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PARK, Robert Fraser Pearson
    Westhill Business Park
    Westhill
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House, Mosscroft Avenue
    United Kingdom
    Secrétaire
    Westhill Business Park
    Westhill
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House, Mosscroft Avenue
    United Kingdom
    274118000001
    MACGREGOR, Stuart Alastair
    Westhill Business Park
    Westhill
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House, Mosscroft Avenue
    Scotland
    Administrateur
    Westhill Business Park
    Westhill
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House, Mosscroft Avenue
    Scotland
    ScotlandBritishFinance Director330152850001
    MILNE, Stewart
    Dalhebity House
    Baillieswells Road, Bieldside
    AB15 9BQ Aberdeen
    Administrateur
    Dalhebity House
    Baillieswells Road, Bieldside
    AB15 9BQ Aberdeen
    ScotlandBritishCompany Director190960001
    MORE, Gerald Campbell
    Westhill Business Park
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House
    Scotland
    Administrateur
    Westhill Business Park
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House
    Scotland
    ScotlandBritishCompany Director211208700001
    PARK, Robert Fraser Pearson
    Westhill Business Park
    Westhill
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House, Mosscroft Avenue
    United Kingdom
    Administrateur
    Westhill Business Park
    Westhill
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House, Mosscroft Avenue
    United Kingdom
    ScotlandBritishGroup Finance Director241939100001
    ALLISON, Glenn Fraser Whyte
    Linden Beeches
    442 North Deeside Road
    AB15 9ET Cults
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    Linden Beeches
    442 North Deeside Road
    AB15 9ET Cults
    Aberdeenshire
    British63687770002
    ANDERSON, Lesley
    70 Woodend Crescent
    AB15 6YQ Aberdeen
    Secrétaire
    70 Woodend Crescent
    AB15 6YQ Aberdeen
    British83529270002
    BAILEY, Peter Clifford
    Woodwinds
    Henley Road
    SL7 2BZ Marlow
    Buckingamshire
    Secrétaire
    Woodwinds
    Henley Road
    SL7 2BZ Marlow
    Buckingamshire
    British270220001
    CORRAY, Pamela Jane
    146 Hamilton Place
    AB15 5BB Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    146 Hamilton Place
    AB15 5BB Aberdeen
    Aberdeenshire
    British83551930001
    CRAWFORD, James
    30 Davieland Road
    Giffnock
    G46 7LL Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    30 Davieland Road
    Giffnock
    G46 7LL Glasgow
    Lanarkshire
    British811700001
    FERGUSON, William Clark
    1-33 Turnberry Road
    G11 5AL Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    1-33 Turnberry Road
    G11 5AL Glasgow
    Lanarkshire
    British36664570001
    MARTIN, Scott Craig
    Mosscroft Avenue
    Westhill Business Park Westhill
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House
    Scotland
    Secrétaire
    Mosscroft Avenue
    Westhill Business Park Westhill
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House
    Scotland
    178780340001
    MEDINE, Michael Sinclair
    Peregrine House
    Mosscroft Avenue
    AB32 6TQ Westhill Business Park
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    Peregrine House
    Mosscroft Avenue
    AB32 6TQ Westhill Business Park
    Aberdeenshire
    248568490001
    MITCHELL, Paul Watt
    2 Kingswood Avenue
    Kingswells
    AB15 8AE Aberdeen
    Secrétaire
    2 Kingswood Avenue
    Kingswells
    AB15 8AE Aberdeen
    British86499970002
    OAG, Stuart Charles
    Woodlands Crescent
    Cults
    AB15 9DH Aberdeen
    7
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    Woodlands Crescent
    Cults
    AB15 9DH Aberdeen
    7
    Aberdeenshire
    British129503880001
    BAILEY, Peter Clifford
    Woodwinds
    Henley Road
    SL7 2BZ Marlow
    Buckingamshire
    Administrateur
    Woodwinds
    Henley Road
    SL7 2BZ Marlow
    Buckingamshire
    United KingdomBritishCompany Director270220001
    BOAL, Marlyn Louise
    Strathmar Craigmillar Avenue
    Milngavie
    G62 8AX Glasgow
    Administrateur
    Strathmar Craigmillar Avenue
    Milngavie
    G62 8AX Glasgow
    BritishCompany Director8685050003
    BROCKES, John Bernard
    3 Dobbins Lane
    Wendover
    HP22 6BU Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    3 Dobbins Lane
    Wendover
    HP22 6BU Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director10590190001
    BRUCE, William Henry
    Logie House
    AB41 8LH Ellon
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Logie House
    AB41 8LH Ellon
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishDirector121480001
    COCHRANE, Gordon
    Beaconhill Den
    AB13 0HT Milltimber
    Aberdeen
    Administrateur
    Beaconhill Den
    AB13 0HT Milltimber
    Aberdeen
    ScotlandBritishCompany Director545540005
    CRAWFORD, James
    30 Davieland Road
    Giffnock
    G46 7LL Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    30 Davieland Road
    Giffnock
    G46 7LL Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritishFinancial Director811700001
    DUNSMORE, James
    6 Glebe Avenue
    KA1 3DX Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    6 Glebe Avenue
    KA1 3DX Kilmarnock
    Ayrshire
    BritishCompany Director33416520001
    FERGUSON, William Clark
    1-33 Turnberry Road
    G11 5AL Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    1-33 Turnberry Road
    G11 5AL Glasgow
    Lanarkshire
    BritishDirector/Secretary36664570001
    IRVINE, John Christopher
    Forestside Road
    AB31 5ZH Banchory
    38
    Kincardineshire
    Administrateur
    Forestside Road
    AB31 5ZH Banchory
    38
    Kincardineshire
    ScotlandUnited KingdomFinance Director38442060003
    LOUDON, Gavin Cameron
    37 Craigmillar Avenue
    Milngavie
    G62 8AX Glasgow
    Strathclyde
    Administrateur
    37 Craigmillar Avenue
    Milngavie
    G62 8AX Glasgow
    Strathclyde
    ScotlandBritishCompany Director72871180001
    MACKAY, Hugh James
    The Oaks
    Abergeldie Road
    AB35 5RR Ballater
    Aberdeenshire
    Administrateur
    The Oaks
    Abergeldie Road
    AB35 5RR Ballater
    Aberdeenshire
    United KingdomBritishCompany Director189730001
    MACKINTOSH, Alistair
    58 Blairderry Road
    SW2 4SB London
    Administrateur
    58 Blairderry Road
    SW2 4SB London
    BritishInvestment Manager77057990002
    MILNE, Hamish
    Alt Na Braigh
    265 North Deeside Road
    AB13 0HD Milltimber,Aberdeen
    Administrateur
    Alt Na Braigh
    265 North Deeside Road
    AB13 0HD Milltimber,Aberdeen
    United KingdomBritishCompany Director189710004
    TIERNEY, Kenneth Hobson
    15 Speirs Avenue
    KA15 1JD Beith
    Ayrshire
    Administrateur
    15 Speirs Avenue
    KA15 1JD Beith
    Ayrshire
    BritishInvestment Manager43725260001
    TOLSON, Steven Harry
    8 Princes Street
    Rutherglen
    G73 1LG Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    8 Princes Street
    Rutherglen
    G73 1LG Glasgow
    Lanarkshire
    BritishCompany Director63920800001
    WILTSHIRE, Paul David
    4 Lawrence Grove
    HP16 0SN Prestwood
    Buckinghamshire
    Administrateur
    4 Lawrence Grove
    HP16 0SN Prestwood
    Buckinghamshire
    BritishChairman23145230001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AMBION HOMES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Westhill Business Park
    Westhill
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House, Mosscroft Avenue
    Scotland
    06 avr. 2016
    Westhill Business Park
    Westhill
    AB32 6JQ Aberdeen
    Peregrine House, Mosscroft Avenue
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom (Scotland)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc132524
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    AMBION HOMES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 09 avr. 1998
    Livré le 23 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The whole obligations undertaken in terms of the minute of agreement
    Brèves mentions
    Ground forming part of mearnskirk hospital,newton mearns,glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for Scotland
    Transactions
    • 23 avr. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 09 févr. 1996
    Livré le 12 févr. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The subjects at phase ii, westerlands, newton mearns, glasgow, registered under title number ren 82453.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 févr. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 09 févr. 1996
    Livré le 12 févr. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The subjects at phase I, westerlands, newton mearns, glasgow, registered under title number ren 82425.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 févr. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 09 févr. 1996
    Livré le 12 févr. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The subjects at trinity square, pollokshields, glasgow, registered under title number gla 85966.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 févr. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 09 févr. 1996
    Livré le 12 févr. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The subjects at hungry hill, bearsden, registered under title number dmb 5821.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 févr. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 20 déc. 1995
    Livré le 20 déc. 1995
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The subjects at mearnskirk hospital, newton mearns, glasgow, registered under title number ren 85645.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 déc. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 15 déc. 1995
    Livré le 05 janv. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Mearnskirk hospital,newton mearns,glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for Scotland
    Transactions
    • 05 janv. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 10 nov. 1995
    Livré le 17 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot 131, st andrews rise, 1 burncrooks avenue, bearsden, dumbartonshire.
    Personnes ayant droit
    • Birmingham Midshires Building Society
    Transactions
    • 17 nov. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 10 nov. 1995
    Livré le 17 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot 132, st andrews rise, 3 burncrooks avenue, bearsden, dumbartonshire.
    Personnes ayant droit
    • Birmingham Midshires Building Society
    Transactions
    • 17 nov. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 juil. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 10 nov. 1995
    Livré le 17 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot 3, 2 westerlands place, westerlands, newton mearns, renfrewshire.
    Personnes ayant droit
    • Birmingham Midshires Building Society
    Transactions
    • 17 nov. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 10 nov. 1995
    Livré le 17 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot 2, 3 westerlands place, westerlands, newton mearns, renfrewshire.
    Personnes ayant droit
    • Birmingham Midshires Building Society
    Transactions
    • 17 nov. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 10 nov. 1995
    Livré le 17 nov. 1995
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot 1, 4 westerlands place, westerlands, newton mearns, renfrewshire.
    Personnes ayant droit
    • Birmingham Midshires Building Society
    Transactions
    • 17 nov. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 23 août 1995
    Livré le 29 août 1995
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due in respect of an advance of £99,400
    Brèves mentions
    Plot 98 phase 7 mains estate, milngavie, registered under title number dmb 19507.
    Personnes ayant droit
    • Dunfermline Building Society
    Transactions
    • 29 août 1995Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 23 août 1995
    Livré le 29 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due in respect of an advance of £73,500
    Brèves mentions
    Plot 99 phase 7 mains estate milngavie, registered under title number dmb 19507.
    Personnes ayant droit
    • Dunfermline Building Society
    Transactions
    • 29 août 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 18 août 1995
    Livré le 29 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The flatted dwellinghouse known as 34 nasmyth avenue, bearsden, being plot no. 36 silverknowes gate, bearsden.
    Personnes ayant droit
    • Birmingham Midshires Building Society
    Transactions
    • 29 août 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 18 août 1995
    Livré le 29 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The flatted dwellinghouse known as 36 nasmyth avenue, bearsden, being plot no. 33 silverknowes gate, bearsden.
    Personnes ayant droit
    • Birmingham Midshires Building Society
    Transactions
    • 29 août 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 20 mars 1995
    Livré le 27 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,127,500
    Brèves mentions
    6.5 acres on the south side of grampian way, bearsden, and on th west side of stockiemuir road, bearsden, registered under title number dmb 5821.
    Personnes ayant droit
    • The Most Reverend Thomas Joseph Cardinal Winning and Others as Trustees
    Transactions
    • 27 mars 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 févr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 20 févr. 1995
    Livré le 24 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,000,000
    Brèves mentions
    5.44 acres lying adjacent to barrhead road, newton mearns.
    Personnes ayant droit
    • S. L. Homes Limited
    Transactions
    • 24 févr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 févr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 02 nov. 1994
    Livré le 11 nov. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due and that become due in respect of an advance of £58,800 and any re-advance or any further or other advance or payment or any other monies whatsoever which may become due
    Brèves mentions
    Area of ground forming part of the development known as moor park, prestwick.
    Personnes ayant droit
    • Dunfermline Building Society
    Transactions
    • 11 nov. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 juin 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 27 mai 1994
    Livré le 02 juin 1994
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Whole area of ground on the west side of east road,prestwick.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 juin 1994Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 26 avr. 1994
    Livré le 28 avr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £62,300 and all further sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground forming plot 5 mains estate,phase 2B,milngavie - DMB19507 togetherwith dwelling house known as 5 drumbeg terrace,milngavie.
    Personnes ayant droit
    • Dunfermline Building Society
    Transactions
    • 28 avr. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 25 avr. 1994
    Livré le 28 avr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £65,100 and all further sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground forming plot 4 mains estate, PHASE2B,milngavie - dmb 19507 together with dwelling house known as 4 drumbeg terrace,milngavie.
    Personnes ayant droit
    • Dunfermline Building Society
    Transactions
    • 28 avr. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 10 mars 1994
    Livré le 18 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £70,000 and all further sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot 45 silverknowes wynd, bearsden registered under title number dmb 19508.
    Personnes ayant droit
    • Dunfermline Building Society
    Transactions
    • 18 mars 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 10 mars 1994
    Livré le 18 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £91,000 and all further sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot 46 silverknowes wynd, bearsden registered under title number dmb 19508.
    Personnes ayant droit
    • Dunfermline Building Society
    Transactions
    • 18 mars 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 07 janv. 1994
    Livré le 13 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £51,100 and all further sums due or to become due
    Brèves mentions
    664.8 square yards at barony court, ardrossan, ayrshire as relative to feu disposition by ailsa homes LTD ifo william david gillespie dated 12TH july and recorded grs ayr 7TH aug 1967 (14 barony court, ardrossan).
    Personnes ayant droit
    • Dunfermline Building Society
    Transactions
    • 13 janv. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0