GRANITE COUNTRY GROUP LIMITED

GRANITE COUNTRY GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGRANITE COUNTRY GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC100976
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GRANITE COUNTRY GROUP LIMITED ?

    • Élevage de bovins laitiers (01410) / Agriculture, sylviculture et pêche
    • Élevage de volailles (01470) / Agriculture, sylviculture et pêche

    Où se situe GRANITE COUNTRY GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GRANITE COUNTRY GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GRAMPIAN COUNTRY FOOD GROUP LIMITED22 sept. 198622 sept. 1986

    Quels sont les derniers comptes de GRANITE COUNTRY GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 nov. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour GRANITE COUNTRY GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    legacy

    4 pagesMG05s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 déc. 2011

    État du capital au 28 déc. 2011

    • Capital: GBP 58,381,015
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2010

    8 pagesAA

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2009

    20 pagesAA

    Divers

    Section 519
    1 pagesMISC

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Divers

    AA03
    2 pagesMISC

    Divers

    Auditors resignation
    1 pagesMISC

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2008

    24 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes consolidés établis au 31 mai 2007

    37 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Qui sont les dirigeants de GRANITE COUNTRY GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    Secrétaire
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    119967690001
    DUNCAN, Alfred John
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish402690001
    IAIN SMITH AND COMPANY
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    Secrétaire
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    93547510001
    BARNES, Richard Garth
    Whistler House Green North
    Warborough
    OX10 7DW Wallingford
    Oxfordshire
    Administrateur
    Whistler House Green North
    Warborough
    OX10 7DW Wallingford
    Oxfordshire
    British46366230001
    BENNET, Gordon Iain
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Administrateur
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    British119604660001
    BENZIE, Alan Athol Emslie
    Oakbarn, Higher House Farm
    Hocker Lane
    SK10 4SD Over Alderley
    Cheshire
    Administrateur
    Oakbarn, Higher House Farm
    Hocker Lane
    SK10 4SD Over Alderley
    Cheshire
    EnglandBritish83412170001
    CARNEY, Joseph Gerard
    18 Devonshire Road
    HA1 4LR Harrow
    Middlesex
    Administrateur
    18 Devonshire Road
    HA1 4LR Harrow
    Middlesex
    United KingdomIrish89273480001
    FYFE, Archibald
    8 Turin Way
    Foveran
    AB41 6HG Ellon
    Aberdeenshire
    Administrateur
    8 Turin Way
    Foveran
    AB41 6HG Ellon
    Aberdeenshire
    British957330003
    GILBERT, Martin James
    17 Rubislaw Den North
    AB15 4AL Aberdeen
    Administrateur
    17 Rubislaw Den North
    AB15 4AL Aberdeen
    ScotlandBritish48820002
    HOPLEY, Philip Thomas
    Greenmoss Farmhouse
    Castle Fraser
    AB51 7LB Aberdeenshire
    Administrateur
    Greenmoss Farmhouse
    Castle Fraser
    AB51 7LB Aberdeenshire
    British957150007
    IMRAY, Iain Murray
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish63444910001
    JOHNSON, Peter George
    41 Lingfield Road
    Wimbledon
    SW19 4PZ London
    Administrateur
    41 Lingfield Road
    Wimbledon
    SW19 4PZ London
    British34190650001
    LIND, John
    Overton Of Keithfield
    AB41 0EU Methlick
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Overton Of Keithfield
    AB41 0EU Methlick
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish515220001
    MACKIE, Grant Stephen
    First Floor
    15 Leven Terrace
    AB3 9LW Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    First Floor
    15 Leven Terrace
    AB3 9LW Edinburgh
    Lothian
    British143161970001
    MILNE, Kevin Dawson
    Heathcot
    1 Culter House Road
    AB13 0EN Milltimber
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Heathcot
    1 Culter House Road
    AB13 0EN Milltimber
    Aberdeenshire
    ScotlandScottish66083160001
    MONK, Paul John
    White Place
    River Road Taplow
    SL6 0BG Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    White Place
    River Road Taplow
    SL6 0BG Maidenhead
    Berkshire
    British71562530002
    PARIS, Walter Walker
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    Administrateur
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    British338220001
    PARTINGTON, Roger Evans
    The Peppers
    Mustard Lane
    RG4 6GH Sonning On Thames
    Berkshire
    Administrateur
    The Peppers
    Mustard Lane
    RG4 6GH Sonning On Thames
    Berkshire
    United KingdomBritish14091850003
    PEARCE, Anthony Michael
    Timbers Combe
    Carlton Road, South Godstone
    RH9 8LG Godstone
    Surrey
    Administrateur
    Timbers Combe
    Carlton Road, South Godstone
    RH9 8LG Godstone
    Surrey
    British15241750002
    POWER, Eddie
    Kincora Lodge
    Brennanston Road
    IRISH Carrackmines
    County Dublin 18
    Ireland
    Administrateur
    Kincora Lodge
    Brennanston Road
    IRISH Carrackmines
    County Dublin 18
    Ireland
    IrelandIrish98491380001
    SALKELD, David John
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish111995510001
    SMITH, Malcolm
    Old Hall
    Rockcliffe
    CA6 4BL Carlisle
    Cumbria
    Administrateur
    Old Hall
    Rockcliffe
    CA6 4BL Carlisle
    Cumbria
    United KingdomBritish93227360001
    STEPHEN, Andrew Michael Duthie
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    Administrateur
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    ScotlandBritish338210001
    TOCHER, Henry John
    17 Cliff Park
    Cults
    AB15 9JT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    17 Cliff Park
    Cults
    AB15 9JT Aberdeen
    Aberdeenshire
    British2581920001
    WALLIS, David William
    Low Garth Church Lane
    Collingham
    LS22 5AU Wetherby
    England
    Administrateur
    Low Garth Church Lane
    Collingham
    LS22 5AU Wetherby
    England
    EnglandBritish48299920002
    WHITTAKER, Thomas Geoffrey
    6 Beresford House
    Palace Terrace
    IM2 4NE Douglas
    Isle Of Man
    Administrateur
    6 Beresford House
    Palace Terrace
    IM2 4NE Douglas
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish43919360002
    WITHAM, David Peter
    6 Heatherside Gardens
    SL2 3RR Farnham Common
    Buckinghamshire
    Administrateur
    6 Heatherside Gardens
    SL2 3RR Farnham Common
    Buckinghamshire
    EnglandBritish97409950001

    GRANITE COUNTRY GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 09 juin 2008
    Livré le 17 juin 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land and buildings at old hall farm, attleborough, norfolk.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 juin 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Legal charge
    Créé le 30 mai 2008
    Livré le 10 juin 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land and buildings on east side of old buckenham road, attleborough, norfolk.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 juin 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 07 mai 2008
    Livré le 14 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at badentoy, portlethen KNC2009.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 mai 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 07 mai 2008
    Livré le 14 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land at burnhouse industrial estate, whitburn.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 mai 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 07 mai 2008
    Livré le 14 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground at main street kinglassie.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 mai 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 07 mai 2008
    Livré le 14 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects to the southside of oakbank road, east calder in the county of midlothian.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 mai 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 07 mai 2008
    Livré le 14 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at tannery street, banff.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 mai 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 07 mai 2008
    Livré le 14 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at mugiemoss road, bucksburn, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 mai 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Legal charge
    Créé le 02 mai 2008
    Livré le 08 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due all sums due or to become due
    Brèves mentions
    Hendall wood, lying to the west side of the A26 road, buxted east sussex ESX202801.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 mai 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Legal charge
    Créé le 02 mai 2008
    Livré le 08 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    North east side of dewsbury road, ossett & land at warneford avenue, ossett WYK703096 WYK226999 WYK218832.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 mai 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 mai 2008
    • 04 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Floating charge
    Créé le 29 mai 2007
    Livré le 13 juin 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 juin 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 juin 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 août 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (MG05s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 29 mai 2007
    Livré le 13 juin 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 juin 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 juin 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 07 déc. 1998
    Livré le 24 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 déc. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 28 juil. 1998
    Livré le 14 août 1998
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transactions
    • 14 août 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 août 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 juin 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Shares mortgage
    Créé le 31 oct. 1997
    Livré le 14 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transactions
    • 14 nov. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Shares pledge
    Créé le 31 oct. 1997
    Livré le 14 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transactions
    • 14 nov. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 31 oct. 1997
    Livré le 14 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transactions
    • 14 nov. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignation in security
    Créé le 29 avr. 1997
    Livré le 08 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    (Assignation of book debt) policies of assurance.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and the Banks
    Transactions
    • 08 mai 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Shares mortgage
    Créé le 23 août 1996
    Livré le 06 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All shares and dividends.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent and Trustee for Others
    Transactions
    • 06 sept. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 05 oct. 1990
    Livré le 22 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Canadian Imperial Bank of Commerce for Itself and as Agent and Trustee
    Transactions
    • 22 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 21 oct. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 01 juil. 1988
    Livré le 13 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Canadian Imperial Bank of Commerce as Agent and Trustee for Itself & Others
    Transactions
    • 13 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 08 juin 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 01 juil. 1988
    Livré le 12 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Canadian Imperial Bank of Commerce as Agent and Trustee for Itself & Others
    Transactions
    • 12 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0