CLARK RETAIL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCLARK RETAIL LIMITED
    Statut de la sociétéEn administration
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC101099
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CLARK RETAIL LIMITED ?

    • Vente au détail de pain, pâtisseries, pâtisserie fine et confiserie en magasin spécialisé (47240) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Vente au détail de produits du tabac en magasin spécialisé (47260) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Vente au détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé (47620) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe CLARK RETAIL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Pricewaterhousecoopersllp
    144 Morrison Street
    EH3 8EB Edinburgh
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CLARK RETAIL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PACIFIC SHELF (SIXTY-EIGHT) LIMITED29 sept. 198629 sept. 1986

    Quels sont les derniers comptes de CLARK RETAIL LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 nov. 2021
    Date d'échéance des prochains comptes31 août 2022
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 nov. 2020

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CLARK RETAIL LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au31 déc. 2022
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation14 janv. 2023
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au31 déc. 2021
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour CLARK RETAIL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    43 pagesAM10(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    40 pagesAM10(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    4 pagesAM19(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    47 pagesAM10(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    31 pagesAM10(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    4 pagesAM19(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    28 pagesAM10(Scot)

    Déclaration des affaires AM02SOASCOT

    25 pagesAM02(Scot)

    Approbation des propositions de l'administrateur

    4 pagesAM06(Scot)

    Avis de proposition de l'administrateur

    85 pagesAM03(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de Pricewaterhousecoopersllp 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EB United Kingdom à Pricewaterhousecoopersllp 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EB le 17 mai 2022

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de 72 Carfin Road Motherwell ML1 5JZ Scotland à Pricewaterhousecoopersllp 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EB le 17 mai 2022

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    4 pagesAM01(Scot)

    Cessation de la nomination de Simon Jonathan Miller en tant que directeur le 24 mars 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Indigo Corporate Secretary Limited en tant que secrétaire le 14 mars 2022

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Rachel Peat en tant que secrétaire le 14 mars 2022

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Richard Mark James Crampton en tant que directeur le 14 janv. 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 29 nov. 2020

    41 pagesAA

    legacy

    140 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Modification des détails de Price Smashers Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC05

    Inscription de la charge SC1010990047, créée le 26 févr. 2021

    80 pagesMR01

    Modification des détails de Price Smashers Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 déc. 2020

    2 pagesPSC05

    Qui sont les dirigeants de CLARK RETAIL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    INDIGO CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Rectory Grove
    SS9 2HL Leigh On Sea
    Monometer House
    Essex
    United Kingdom
    Secrétaire
    Rectory Grove
    SS9 2HL Leigh On Sea
    Monometer House
    Essex
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement13253973
    281695990002
    BUTLER, Stuart Clive
    144 Morrison Street
    EH3 8EB Edinburgh
    Pricewaterhousecoopersllp
    United Kingdom
    Administrateur
    144 Morrison Street
    EH3 8EB Edinburgh
    Pricewaterhousecoopersllp
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director127794710001
    DAVID, Giles Matthew Oliver
    144 Morrison Street
    EH3 8EB Edinburgh
    Pricewaterhousecoopersllp
    United Kingdom
    Administrateur
    144 Morrison Street
    EH3 8EB Edinburgh
    Pricewaterhousecoopersllp
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Financial Officer187907210001
    MCEWAN, Karen Anita
    144 Morrison Street
    EH3 8EB Edinburgh
    Pricewaterhousecoopersllp
    United Kingdom
    Administrateur
    144 Morrison Street
    EH3 8EB Edinburgh
    Pricewaterhousecoopersllp
    United Kingdom
    EnglandBritishColleague And Operations Director272054760001
    BARNES, Christopher Howard
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    British25597650001
    DALY, Gerald
    10 Brierie Lane
    Crosslee
    PA6 7LS Johnstone
    Renfrewshire
    Secrétaire
    10 Brierie Lane
    Crosslee
    PA6 7LS Johnstone
    Renfrewshire
    BritishFinance Director120471160001
    FORD, Laurence Henry
    123 Eastern Avenue East
    RM1 4SH Romford
    Essex
    Secrétaire
    123 Eastern Avenue East
    RM1 4SH Romford
    Essex
    British49930060001
    MILLER, Simon Jonathan
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Martin Mccoll House
    Essex
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Martin Mccoll House
    Essex
    United Kingdom
    British88269280005
    PEAT, Rachel
    Carfin Road
    ML1 5JZ Motherwell
    72
    Scotland
    Secrétaire
    Carfin Road
    ML1 5JZ Motherwell
    72
    Scotland
    256015380001
    READER, Colin Graham
    51 Arlington Road
    NW1 7ES London
    Secrétaire
    51 Arlington Road
    NW1 7ES London
    BritishDirector3037660001
    REES, John Michael
    102 Pollards Green
    Chelmer Village
    CM2 6UL Chelmsford
    Secrétaire
    102 Pollards Green
    Chelmer Village
    CM2 6UL Chelmsford
    British44816940001
    TEDDER, Kingsley John
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Martin Mccoll House
    Essex
    Secrétaire
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Martin Mccoll House
    Essex
    British101631010002
    YOUNG, Bernadette Clare
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Secrétaire
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    237611420001
    BLP SECRETARIES LIMITED
    130 St Vincent Street
    G2 5SE Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    130 St Vincent Street
    G2 5SE Glasgow
    Lanarkshire
    78293470001
    AGUSS, Martyn James
    Unit 11,The Avenue
    Newton Mearns
    G77 6AA Glasgow
    Administrateur
    Unit 11,The Avenue
    Newton Mearns
    G77 6AA Glasgow
    EnglandBritishDirector107991420002
    BELL, Robbie Ian
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    England
    Administrateur
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer97384120002
    CAMPBELL, Mary Theresa
    13 Campbell Avenue
    Murrayfield
    EH12 6DP Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    13 Campbell Avenue
    Murrayfield
    EH12 6DP Edinburgh
    Midlothian
    BritishCa1322300001
    CLARK, Wighton Paterson
    57 Larchfield Avenue
    Newton Mearns
    G77 5QN Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    57 Larchfield Avenue
    Newton Mearns
    G77 5QN Glasgow
    Lanarkshire
    BritishManaging Director886180001
    COX, Allister Russell
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    Administrateur
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    EnglandBritishFinancial Director31500810002
    CRAIG, Frederick John Robert
    Gateside
    KY14 7SX Cupar
    Freeland
    Fife
    United Kingdom
    Administrateur
    Gateside
    KY14 7SX Cupar
    Freeland
    Fife
    United Kingdom
    ScotlandBritishManagement Consultant133316040001
    CRAMPTON, Richard Mark James
    Carfin Road
    ML1 5JZ Motherwell
    72
    Scotland
    Administrateur
    Carfin Road
    ML1 5JZ Motherwell
    72
    Scotland
    United KingdomBritishChief Commercial Officer270535630001
    DALY, Gerald
    10 Brierie Lane
    Crosslee
    PA6 7LS Johnstone
    Renfrewshire
    Administrateur
    10 Brierie Lane
    Crosslee
    PA6 7LS Johnstone
    Renfrewshire
    United KingdomBritishFinance Director120471160001
    FULLER, Simon Jeremy Ian
    Unit 11,The Avenue
    Newton Mearns
    G77 6AA Glasgow
    Administrateur
    Unit 11,The Avenue
    Newton Mearns
    G77 6AA Glasgow
    EnglandBritishDirector181763320002
    GREEN, Steven
    Unit 11,The Avenue
    Newton Mearns
    G77 6AA Glasgow
    Administrateur
    Unit 11,The Avenue
    Newton Mearns
    G77 6AA Glasgow
    EnglandBritishDirector209348880001
    JACKSON, Brian
    9 The Grazings
    Highfield Lane
    HP2 5JN Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Administrateur
    9 The Grazings
    Highfield Lane
    HP2 5JN Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector776110002
    LANCASTER, James
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Martin Mccoll House
    Essex
    Administrateur
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Martin Mccoll House
    Essex
    EnglandBritishChairman147052660001
    LEAK, Robert
    17 Manor Road
    EN5 2LH Barnet
    Hertfordshire
    Administrateur
    17 Manor Road
    EN5 2LH Barnet
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector769220001
    MACNAB, Peter William
    18 Hawthorn Avenue
    PA8 7BU Erskine
    Renfrewshire
    Administrateur
    18 Hawthorn Avenue
    PA8 7BU Erskine
    Renfrewshire
    BritishSales Manager59335890001
    MILLER, Simon Jonathan
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Martin Mccoll House
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Martin Mccoll House
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector88269280005
    PEARSON, John Black
    22 Glencairn Road
    Langbank
    PA14 6XL Port Glasgow
    Renfrewshire
    Administrateur
    22 Glencairn Road
    Langbank
    PA14 6XL Port Glasgow
    Renfrewshire
    BritishMerchandise Director886160001
    READER, Colin Graham
    51 Arlington Road
    NW1 7ES London
    Administrateur
    51 Arlington Road
    NW1 7ES London
    United KingdomBritishDirector3037660001
    REES, John Michael
    6 Nelson Crescent
    CM9 6WE Maldon
    Essex
    Administrateur
    6 Nelson Crescent
    CM9 6WE Maldon
    Essex
    BritishDirector44816940002
    TALBOT, John Richard
    14 The Coppens
    Stotfold
    SG5 4PJ Hitchin
    Hertfordshire
    Administrateur
    14 The Coppens
    Stotfold
    SG5 4PJ Hitchin
    Hertfordshire
    BritishDirector74755840001
    WILKINSON, Stephen William
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Martin Mccoll House
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Martin Mccoll House
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector101631100002
    WOOLDRIDGE, Stephen Howard
    Sanibel
    Wrabness Road
    CO12 5NJ Ramsey
    Essex
    Administrateur
    Sanibel
    Wrabness Road
    CO12 5NJ Ramsey
    Essex
    EnglandBritishDirector117179210001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CLARK RETAIL LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03063211
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    CLARK RETAIL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 26 févr. 2021
    Livré le 10 mars 2021
    En cours
    Brève description
    All current and future land (except for any restricted land) and intellectual property (except for any restricted ip) owned by the company, in each case as specified (and defined) in the debenture registered by this form MR01 (the "debenture"). For more details please refer to the debenture.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transactions
    • 10 mars 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 27 févr. 2020
    Livré le 04 mars 2020
    En cours
    Brève description
    N/A.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited as Security Agent
    Transactions
    • 04 mars 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 13 juil. 2016
    Livré le 22 juil. 2016
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transactions
    • 22 juil. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 13 juil. 2016
    Livré le 20 juil. 2016
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent for the Secured Parties (Each as Defined in the Instrument))
    Transactions
    • 20 juil. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    Group debenture
    Créé le 15 mars 2013
    Livré le 28 mars 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cavendish Security Trustee Limited
    Transactions
    • 28 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 02 avr. 2013Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 20 nov. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Group debenture
    Créé le 15 mars 2013
    Livré le 22 mars 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 22 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 27 mars 2013Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 06 avr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 14 mars 2013
    Livré le 28 mars 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cavendish Security Trustee Limited
    Transactions
    • 28 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 02 avr. 2013Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 20 nov. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 14 mars 2013
    Livré le 27 mars 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 27 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 27 mars 2013Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 06 avr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 17 oct. 2005
    Livré le 27 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage all freehold and leasehold property, fixed charges and floating charges.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transactions
    • 27 oct. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Floating charge
    Créé le 17 juil. 2002
    Livré le 24 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under or pursuant to the bos documents
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 juil. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 28 nov. 1998
    Livré le 10 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC as Agent and Trustee for Th Secured Parties
    Transactions
    • 10 déc. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 30 sept. 1994
    Livré le 18 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    106 high street, ayr.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transactions
    • 18 oct. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 12 août 1994
    Livré le 29 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Sub-lease between gernaium properties limited and the company dated 3RD and 9TH sept 1991 of shop unit known as unit 6 of the development by the said geranium properties limited at the regent centre, kirkintilloch which sub-lease is registered under title number dmb 43487 in the land register of scotland.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transactions
    • 29 août 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 28 janv. 1993
    Livré le 08 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All and whole a sublease between ravenseft properties LTD and clark retail LTD dated 31ST july and 15TH sept 1987 and recorded grs midlothian 4TH march 1988 (as amended by minute of amendment of sublease between ravenseft properties LTD and clark retail LTD dated 13TH nov and 10TH dec and recorded grs 280193) of all and whole the ground floor shop premises known as 16 newkirkgate, leith, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transactions
    • 08 févr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 19 oct. 1992
    Livré le 28 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Lease of 8 ormiston terrace, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transactions
    • 28 oct. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 26 août 1992
    Livré le 08 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The lease between co-operative wholesale society limited and clark retail limited dated 24/03/92 and 21/04/92 all and whole that shop unit known as unit 6 of the co-operative wholesale society limiteds development at princes street/church street/ king street, port glasgow, renfrew.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transactions
    • 08 sept. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 26 août 1992
    Livré le 03 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    19 brandon parade south, motherwell.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transactions
    • 03 sept. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 25 août 1992
    Livré le 03 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Unit 7, shandwick square shopping centre, easterhouse, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transactions
    • 03 sept. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 25 août 1992
    Livré le 03 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    75 renfield street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transactions
    • 03 sept. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 24 août 1992
    Livré le 07 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    3 west street, penicuik.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transactions
    • 07 sept. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 mai 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 22 août 1991
    Livré le 04 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Lease over 74 sylvania way, clydebank title no dmb 23218.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transactions
    • 04 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 04 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 22 juil. 1991
    Livré le 02 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    439 victoria road glasgow gla 72788.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transactions
    • 02 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 04 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 18 juil. 1991
    Livré le 29 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Shop premises known as 38 nicolson street, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transactions
    • 29 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 04 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 18 juil. 1991
    Livré le 29 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Shop premises known as 95 south bridge, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transactions
    • 29 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 04 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 18 juil. 1991
    Livré le 29 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Shop premises known as 126 and 128 gorgie road, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transactions
    • 29 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 04 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    CLARK RETAIL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 mai 2022Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark James Tobias Banfield
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Robert Nicholas Lewis
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Rachael Wilkinson
    3 Forbury Place 23 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    Berkshire
    practitioner
    3 Forbury Place 23 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    Berkshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0