ANDERGAUGE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéANDERGAUGE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC101482
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ANDERGAUGE LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe ANDERGAUGE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    National Oilwell Varco Badentoy Crescent
    Badentoy Park
    AB12 4YD Portlethen
    Aberdeen
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ANDERGAUGE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour ANDERGAUGE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2022

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2021

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Nov Downhole Eurasia Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 juin 2021

    2 pagesPSC05

    Nomination de Christopher Paul O'neil en tant qu'administrateur le 31 déc. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Simon Scott Reid en tant que directeur le 31 déc. 2020

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des détails de Nov Downhole Eurasia Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 mai 2019

    2 pagesPSC05

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Alastair James Fleming en tant que directeur le 31 août 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Simon Scott Reid en tant qu'administrateur le 09 juil. 2018

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2017

    5 pagesAA

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 16 août 2017

    2 pagesPSC09

    Notification de Nov Downhole Eurasia Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de ANDERGAUGE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SLOAN, Alison May
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Secrétaire
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    180812090001
    O'NEIL, Christopher Paul
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Administrateur
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    United KingdomBritish162062160001
    OUDENDIJK, Robbert
    2806 Hh Gouda
    Tobias Asserstraat 1
    Netherlands
    Administrateur
    2806 Hh Gouda
    Tobias Asserstraat 1
    Netherlands
    NetherlandsDutch201609020001
    CLARKSON, Susan Jacqueline
    8 Moor Place
    Portlethen
    AB12 4TF Aberdeen
    Secrétaire
    8 Moor Place
    Portlethen
    AB12 4TF Aberdeen
    British59264190001
    FLEMING, Alastair James
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Secrétaire
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    163563710001
    KNIGHT, Kevin John
    10046 Bayou Glen Road
    Houston
    Texas 77042
    Usa
    Secrétaire
    10046 Bayou Glen Road
    Houston
    Texas 77042
    Usa
    British41387560011
    LEIGHTON, Katherine Jennifer
    Kirk House
    Victoria Terrace, Kemnay
    AB51 5RL Inverurie
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    Kirk House
    Victoria Terrace, Kemnay
    AB51 5RL Inverurie
    Aberdeenshire
    British110703040002
    O'NEIL, Christopher Paul
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    Secrétaire
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    British145997590001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secrétaire désigné
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    Secrétaire
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    119967690001
    STORIE CRUDEN & SIMPSON
    2 Bon Accord Crescent
    AB11 6DH Aberdeen
    Grampian
    Secrétaire
    2 Bon Accord Crescent
    AB11 6DH Aberdeen
    Grampian
    131121520001
    ANDERSON, Charles Abernethy
    Cruachan House
    Banchory Devenick
    AB1 5YD Aberdeen
    Administrateur
    Cruachan House
    Banchory Devenick
    AB1 5YD Aberdeen
    British1204870003
    BOYLE, Thomas Douglas
    Lanark
    Old Inn Road, Findon Portlethen
    AB12 3RT Aberdeen
    Administrateur
    Lanark
    Old Inn Road, Findon Portlethen
    AB12 3RT Aberdeen
    UkBritish61611910001
    COOPER, Ruairidh Andrew
    345 Great Western Road
    AB1 6NW Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    345 Great Western Road
    AB1 6NW Aberdeen
    Aberdeenshire
    British437530001
    EDDISON, Alan
    Stanley Cottage
    Drumlithie
    AB39 3YS Stonehaven
    Grampian
    Administrateur
    Stanley Cottage
    Drumlithie
    AB39 3YS Stonehaven
    Grampian
    British59572720001
    FLEMING, Alastair James
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Administrateur
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    ScotlandBritish180854890001
    GREENER, Malcolm
    Muirside Of Craigo
    DD10 9LA Montrose
    Administrateur
    Muirside Of Craigo
    DD10 9LA Montrose
    British59264260004
    KEENER, David James
    4819 Xp
    Rijsbergen
    Oranjestraat 33
    Netherlands
    Administrateur
    4819 Xp
    Rijsbergen
    Oranjestraat 33
    Netherlands
    NetherlandsUsa161469350001
    KNIGHT, Kevin John
    10046 Bayou Glen Road
    Houston
    Texas 77042
    Usa
    Administrateur
    10046 Bayou Glen Road
    Houston
    Texas 77042
    Usa
    British41387560011
    O'NEIL, Christopher Paul
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish162062160001
    REID, Simon Scott
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Administrateur
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    ScotlandBritish248254430001
    RITCHIE, Gregor
    The Beeches
    Dr Crouchs Road
    GL6 7EA Eastcombe
    Gloucestershire
    Administrateur
    The Beeches
    Dr Crouchs Road
    GL6 7EA Eastcombe
    Gloucestershire
    EnglandBritish89385880001
    TAYLOR, Malcolm Roy
    Mirfield House
    The Avenue
    GL3 2HB Churchdown
    Gloucestershire
    Administrateur
    Mirfield House
    The Avenue
    GL3 2HB Churchdown
    Gloucestershire
    EnglandBritish159659620001
    TOOLEY, Mark
    Acacia Lodge
    Holly Green
    WR8 0PG Upton-Upon-Severn
    Worcester
    Administrateur
    Acacia Lodge
    Holly Green
    WR8 0PG Upton-Upon-Severn
    Worcester
    British127197030001
    VALENTINE, Steven Grenville
    4 Barnes Close
    Haslington
    CW1 5ZG Crewe
    Administrateur
    4 Barnes Close
    Haslington
    CW1 5ZG Crewe
    EnglandBritish92773870002
    WAITE, Andrew
    Knollwood
    Houston
    Texas 77019
    Usa
    Administrateur
    Knollwood
    Houston
    Texas 77019
    Usa
    British106380220001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ANDERGAUGE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Unit 10 Oldends Lane Industrial Estate
    GL10 3RQ Stonehouse
    Stonedale Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Unit 10 Oldends Lane Industrial Estate
    GL10 3RQ Stonehouse
    Stonedale Road
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueCompany Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement04514250
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour ANDERGAUGE LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    05 juil. 201605 juil. 2017La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société.

    ANDERGAUGE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 15 juil. 2005
    Livré le 29 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Piece of ground extending to 0.98 acres comprising part of badentoy industrial estate, portlethen, kincardineshire and subjects on the south side of hareness road, altens industrial estate, aberdeen (title number knc 1435).
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 31 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 08 juil. 2005
    Livré le 16 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 31 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 05 juin 2003
    Livré le 10 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects on south side of hareness road, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 juin 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 25 oct. 1989
    Livré le 02 nov. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 nov. 1989Enregistrement d'une charge
    • 16 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 16 févr. 1989
    Livré le 28 févr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 28 févr. 1989Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0