ANDERGAUGE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ANDERGAUGE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC101482 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ANDERGAUGE LIMITED ?
| Adresse du siège social | National Oilwell Varco Badentoy Crescent Badentoy Park AB12 4YD Portlethen Aberdeen |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ANDERGAUGE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour ANDERGAUGE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2022 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2021 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des détails de Nov Downhole Eurasia Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 juin 2021 | 2 pages | PSC05 | ||
Nomination de Christopher Paul O'neil en tant qu'administrateur le 31 déc. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Simon Scott Reid en tant que directeur le 31 déc. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Modification des détails de Nov Downhole Eurasia Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 mai 2019 | 2 pages | PSC05 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018 | 5 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Alastair James Fleming en tant que directeur le 31 août 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Simon Scott Reid en tant qu'administrateur le 09 juil. 2018 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2017 | 5 pages | AA | ||
Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 16 août 2017 | 2 pages | PSC09 | ||
Notification de Nov Downhole Eurasia Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
Qui sont les dirigeants de ANDERGAUGE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLOAN, Alison May | Secrétaire | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | 180812090001 | |||||||
| O'NEIL, Christopher Paul | Administrateur | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | United Kingdom | British | 162062160001 | |||||
| OUDENDIJK, Robbert | Administrateur | 2806 Hh Gouda Tobias Asserstraat 1 Netherlands | Netherlands | Dutch | 201609020001 | |||||
| CLARKSON, Susan Jacqueline | Secrétaire | 8 Moor Place Portlethen AB12 4TF Aberdeen | British | 59264190001 | ||||||
| FLEMING, Alastair James | Secrétaire | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | 163563710001 | |||||||
| KNIGHT, Kevin John | Secrétaire | 10046 Bayou Glen Road Houston Texas 77042 Usa | British | 41387560011 | ||||||
| LEIGHTON, Katherine Jennifer | Secrétaire | Kirk House Victoria Terrace, Kemnay AB51 5RL Inverurie Aberdeenshire | British | 110703040002 | ||||||
| O'NEIL, Christopher Paul | Secrétaire | Forest Park AB39 2GF Stonehaven 69 Kincardineshire | British | 145997590001 | ||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Secrétaire désigné | St. Vincent Street G2 5NJ Glasgow 151 | 900003400001 | |||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Secrétaire | 66 Queen's Road AB15 4YE Aberdeen | 119967690001 | |||||||
| STORIE CRUDEN & SIMPSON | Secrétaire | 2 Bon Accord Crescent AB11 6DH Aberdeen Grampian | 131121520001 | |||||||
| ANDERSON, Charles Abernethy | Administrateur | Cruachan House Banchory Devenick AB1 5YD Aberdeen | British | 1204870003 | ||||||
| BOYLE, Thomas Douglas | Administrateur | Lanark Old Inn Road, Findon Portlethen AB12 3RT Aberdeen | Uk | British | 61611910001 | |||||
| COOPER, Ruairidh Andrew | Administrateur | 345 Great Western Road AB1 6NW Aberdeen Aberdeenshire | British | 437530001 | ||||||
| EDDISON, Alan | Administrateur | Stanley Cottage Drumlithie AB39 3YS Stonehaven Grampian | British | 59572720001 | ||||||
| FLEMING, Alastair James | Administrateur | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | Scotland | British | 180854890001 | |||||
| GREENER, Malcolm | Administrateur | Muirside Of Craigo DD10 9LA Montrose | British | 59264260004 | ||||||
| KEENER, David James | Administrateur | 4819 Xp Rijsbergen Oranjestraat 33 Netherlands | Netherlands | Usa | 161469350001 | |||||
| KNIGHT, Kevin John | Administrateur | 10046 Bayou Glen Road Houston Texas 77042 Usa | British | 41387560011 | ||||||
| O'NEIL, Christopher Paul | Administrateur | Forest Park AB39 2GF Stonehaven 69 Kincardineshire United Kingdom | United Kingdom | British | 162062160001 | |||||
| REID, Simon Scott | Administrateur | Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park Portlethen AB12 4YD Aberdeen C/O National Oilwell Varco United Kingdom | Scotland | British | 248254430001 | |||||
| RITCHIE, Gregor | Administrateur | The Beeches Dr Crouchs Road GL6 7EA Eastcombe Gloucestershire | England | British | 89385880001 | |||||
| TAYLOR, Malcolm Roy | Administrateur | Mirfield House The Avenue GL3 2HB Churchdown Gloucestershire | England | British | 159659620001 | |||||
| TOOLEY, Mark | Administrateur | Acacia Lodge Holly Green WR8 0PG Upton-Upon-Severn Worcester | British | 127197030001 | ||||||
| VALENTINE, Steven Grenville | Administrateur | 4 Barnes Close Haslington CW1 5ZG Crewe | England | British | 92773870002 | |||||
| WAITE, Andrew | Administrateur | Knollwood Houston Texas 77019 Usa | British | 106380220001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ANDERGAUGE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov Downhole Eurasia Limited | 06 avr. 2016 | Unit 10 Oldends Lane Industrial Estate GL10 3RQ Stonehouse Stonedale Road Gloucestershire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour ANDERGAUGE LIMITED ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 05 juil. 2016 | 05 juil. 2017 | La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société. |
ANDERGAUGE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Créé le 15 juil. 2005 Livré le 29 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Piece of ground extending to 0.98 acres comprising part of badentoy industrial estate, portlethen, kincardineshire and subjects on the south side of hareness road, altens industrial estate, aberdeen (title number knc 1435). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 08 juil. 2005 Livré le 16 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 05 juin 2003 Livré le 10 juin 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Subjects on south side of hareness road, aberdeen. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 25 oct. 1989 Livré le 02 nov. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 16 févr. 1989 Livré le 28 févr. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0