AC199 REALISATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAC199 REALISATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC102977
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AC199 REALISATIONS LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe AC199 REALISATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Grant Thornton Uk Llp
    95 Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AC199 REALISATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AIRCHANNEL LIMITED29 mai 198729 mai 1987
    PACIFIC SHELF (NINETY) LIMITED30 janv. 198730 janv. 1987

    Quels sont les derniers comptes de AC199 REALISATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour AC199 REALISATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de passage de l'administration à la dissolution

    14 pages2.26B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    14 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    11 pages2.20B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    1 pages2.22B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    9 pages2.20B(Scot)

    Proposition révisée de l'administrateur

    5 pages2.17B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    8 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    8 pages2.20B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    1 pages2.22B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    9 pages2.20B(Scot)

    legacy

    15 pages2.18B(Scot)

    Nomination d'un administrateur

    3 pages2.11B(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de Stirling Road Industrial Estate Dykehead Road Airdrie Lanarkshire ML6 7UJ le 12 avr. 2010

    2 pagesAD01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed airchannel LIMITED\certificate issued on 29/03/10
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name29 mars 2010

    Avis de changement de nom"

    CONNOT

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    legacy

    7 pages363a

    legacy

    3 pages410(Scot)

    legacy

    8 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2007

    33 pagesAA

    legacy

    3 pages410(Scot)

    Qui sont les dirigeants de AC199 REALISATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHELDON, James
    69 Clober Road
    Milngavie
    G62 7SU Glasgow
    Secrétaire
    69 Clober Road
    Milngavie
    G62 7SU Glasgow
    British79738990001
    GLASSEY, Colin
    Greenwood Grove
    Highwoods
    CO4 4EF Colchester
    11
    Administrateur
    Greenwood Grove
    Highwoods
    CO4 4EF Colchester
    11
    British129944180001
    HOLMAN, Steve
    Spixworth Road
    Old Catton
    NR6 7NE Norwich
    25
    Norfolk
    Administrateur
    Spixworth Road
    Old Catton
    NR6 7NE Norwich
    25
    Norfolk
    British129944190001
    SHANKS, Alastair Paul Henry
    Alde House
    Polstead Street
    CO6 4SA Stoke By Nayland
    Administrateur
    Alde House
    Polstead Street
    CO6 4SA Stoke By Nayland
    BritainBritish101167430002
    SHANKS, Alexander Gavin
    Waterside House
    G76 9HN Glasgow
    Administrateur
    Waterside House
    G76 9HN Glasgow
    ScotlandBritish21890001
    SHELDON, James
    69 Clober Road
    Milngavie
    G62 7SU Glasgow
    Administrateur
    69 Clober Road
    Milngavie
    G62 7SU Glasgow
    British79738990001
    GEMMELL, Donald Johnson
    Fairdale Glen Road
    FK15 0DJ Dunblane
    Perthshire
    Secrétaire
    Fairdale Glen Road
    FK15 0DJ Dunblane
    Perthshire
    British14320230002
    GEMMELL, Donald Johnson
    Fairdale Glen Road
    FK15 0DJ Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    Fairdale Glen Road
    FK15 0DJ Dunblane
    Perthshire
    British14320230002
    HOUSTON, William
    10 Springwood
    Masterton
    KY11 5TT Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    10 Springwood
    Masterton
    KY11 5TT Dunfermline
    Fife
    British21910002
    HOWITT, Thomas Slater
    40 High Street
    Stanion
    NN14 1DF Kettering
    Northamptonshire
    Administrateur
    40 High Street
    Stanion
    NN14 1DF Kettering
    Northamptonshire
    British22910001
    KEARNEY, Douglas Richard
    11 Eastwoodmains Road
    G46 6QB Glasgow
    Administrateur
    11 Eastwoodmains Road
    G46 6QB Glasgow
    ScotlandBritish93762430001
    MACNAIR, Neil Smith
    36 Gartconnell Road
    Bearsden
    G61 3BZ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    36 Gartconnell Road
    Bearsden
    G61 3BZ Glasgow
    Lanarkshire
    British21900001
    MURRAY, Norman Loch
    40 Braid Farm Road
    EH10 6LF Edinburgh
    Administrateur
    40 Braid Farm Road
    EH10 6LF Edinburgh
    British22920001
    SHANKS, Ronald Stewart Cuthbertson
    6 Back Dean
    EH4 3UA Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    6 Back Dean
    EH4 3UA Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish22930001
    URQUHART, Robert Todd
    24 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    24 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    British56397610002
    WILD, Ian Nicholas
    Hilcott
    23 South Road
    BS23 2HD Weston Super Mare
    Avon
    Administrateur
    Hilcott
    23 South Road
    BS23 2HD Weston Super Mare
    Avon
    British74467270001

    AC199 REALISATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 15 juil. 2009
    Livré le 22 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage all legal interest in 16 hurworth road, aycliffe industrial estate, newton, aycliffe DU160800.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 juil. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    Rent deposit deed
    Créé le 05 oct. 2007
    Livré le 26 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    The observance and performance of the covenants and conditions
    Brèves mentions
    Fourteen thousand eight hundred and seventy five pounds (£14,875) plus 17.5% value added tax.
    Personnes ayant droit
    • Glasgow City Council
    Transactions
    • 26 oct. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 23 déc. 2005
    Livré le 29 déc. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 29 déc. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 mars 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 16 janv. 2004
    Livré le 24 janv. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 24 janv. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 14 févr. 1989
    Livré le 03 mars 1989
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Lease over piece of ground at stirling road industrial estate, in airdrie lanark extending to 2.19 acres.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 mars 1989Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 13 janv. 1989
    Livré le 16 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold property on north side of sotherby road middlesborough.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 09 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 15 sept. 1988
    Livré le 27 sept. 1988
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold property containing .325 of an acre situate in fengate, peterborough CB91625.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 sept. 1988Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 12 avr. 1988
    Livré le 28 avr. 1988
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Factory at geddingon road, corby nn 107497.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 12 avr. 1988
    Livré le 28 avr. 1988
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Factory at nab lane, bushall, WYK411445.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    Bond & floating charge
    Créé le 02 juin 1987
    Livré le 09 juil. 1987
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    • 01 mars 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    AC199 REALISATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 mars 2013Administration ended
    23 mars 2010Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Robert Caven
    1-4 Atholl Crescent
    EH3 8LQ Edinburgh
    practitioner
    1-4 Atholl Crescent
    EH3 8LQ Edinburgh
    John Gerard Montague
    1/4 Atholl Crescent
    EH19 3LW Edinburgh
    practitioner
    1/4 Atholl Crescent
    EH19 3LW Edinburgh

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0