LIVINGWIND LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLIVINGWIND LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC104583
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LIVINGWIND LIMITED ?

    • (3320) /

    Où se situe LIVINGWIND LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 Michaelson Square
    Livingston
    EH54 7DP West Lothian
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LIVINGWIND LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SKF CONDITION MONITORING CENTRE (LIVINGSTON) LIMITED22 sept. 200622 sept. 2006
    DIAGNOSTIC INSTRUMENTS LIMITED11 mai 198711 mai 1987

    Quels sont les derniers comptes de LIVINGWIND LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour LIVINGWIND LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed skf condition monitoring centre (livingston) LIMITED\certificate issued on 23/03/10
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name23 mars 2010

    Avis de changement de nom"

    CONNOT

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Cessation de la nomination de Bengt Hansson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Paula Jane Owen en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Sharon Linda Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Bengt Olof Hansson le 01 mai 2009

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de John Mcglone en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    17 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    17 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    2 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    16 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    16 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    30 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed diagnostic instruments LIMITED\certificate issued on 22/09/06
    2 pagesCERTNM

    legacy

    2 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2004

    17 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de LIVINGWIND LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SMITH, Sharon Linda
    86a Dunstable Road
    LU5 6DR Toddington
    The Brick House
    Bedfordshire
    Secrétaire
    86a Dunstable Road
    LU5 6DR Toddington
    The Brick House
    Bedfordshire
    British58530190003
    OWEN, Paula Jane
    Laburnum Grove
    LU3 2DW Luton
    2
    Bedfordshire
    England
    Administrateur
    Laburnum Grove
    LU3 2DW Luton
    2
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritishAccountant86211040004
    SMITH, Sharon Linda
    86a
    Dunstable Road Toddington
    LU5 6DR Dunstable
    The Brick House
    Bedfordshire
    England
    Administrateur
    86a
    Dunstable Road Toddington
    LU5 6DR Dunstable
    The Brick House
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritishAccountant58530190003
    HANCOCK, Antony William Martin
    Hiltoun Lodge Turnerhall
    AB41 8EG Ellon
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    Hiltoun Lodge Turnerhall
    AB41 8EG Ellon
    Aberdeenshire
    BritishAccountant662850004
    MEIKLEJOHN, Iain Maury Campbell
    14 Dalrymple Crescent
    EH9 2NX Edinburgh
    Secrétaire désigné
    14 Dalrymple Crescent
    EH9 2NX Edinburgh
    British900003350001
    SMITH, Sharon Linda
    9 Byfield Close
    Toddington
    LU5 6BH Dunstable
    Bedfordshire
    Secrétaire
    9 Byfield Close
    Toddington
    LU5 6BH Dunstable
    Bedfordshire
    British58530190002
    SNODGRASS, Matthew
    7 North Gyle Avenue
    EH12 8JS Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    7 North Gyle Avenue
    EH12 8JS Edinburgh
    Midlothian
    British651160001
    BALFOUR, Ian
    Sharleigh
    Denvale Gardens
    KY8 5UB Kevnoway
    Fife
    Administrateur
    Sharleigh
    Denvale Gardens
    KY8 5UB Kevnoway
    Fife
    BritishManaging Director36486160001
    BRADLEY, Dan
    5271 Viewridge Court
    San Diego
    Ca
    92123
    Usa
    Administrateur
    5271 Viewridge Court
    San Diego
    Ca
    92123
    Usa
    AmericanManager105556330001
    BRADLEY, Daniel Harton
    3220 Dumas Street
    CA 92106 Sandiego
    California
    Usa
    Administrateur
    3220 Dumas Street
    CA 92106 Sandiego
    California
    Usa
    AmericanCompany Manager71114770001
    DUNSMORE, David Strong
    23 The Loan
    Torphichen
    EH48 4NF Bathgate
    West Lothian
    Administrateur
    23 The Loan
    Torphichen
    EH48 4NF Bathgate
    West Lothian
    BritishChartered Accountant260160001
    EDGAR, James Paul
    4 Barnton Avenue
    EH4 6AP Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    4 Barnton Avenue
    EH4 6AP Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishElectronics Engineer651150001
    FORSBERG, Anders Eric Rune
    Avenue Des Cedres 54
    Be-1640
    Rhode St Genese
    Belgium
    Administrateur
    Avenue Des Cedres 54
    Be-1640
    Rhode St Genese
    Belgium
    SwedishDirector89148310001
    HANSSON, Bengt Olof
    43543 Pixbo
    Heymans Vag 20
    Administrateur
    43543 Pixbo
    Heymans Vag 20
    SwedishDirector98245200006
    JOHNSTON, James Neill
    16 Spylaw Bank Road
    EH13 0JW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    16 Spylaw Bank Road
    EH13 0JW Edinburgh
    Midlothian
    BritishChairman876380001
    LEADBETTER, Derek Robert
    Fairwinds
    Copthorne Bank, Copthorne
    RH10 3QZ Crawley
    West Sussex
    Administrateur
    Fairwinds
    Copthorne Bank, Copthorne
    RH10 3QZ Crawley
    West Sussex
    BritishGeneral Manager67842100001
    MCGLONE, John Patrick
    22 Davies Acre
    G74 5BZ East Kilbride
    Lanarkshire
    Administrateur
    22 Davies Acre
    G74 5BZ East Kilbride
    Lanarkshire
    BritishCmp Division Director49366950003
    MCMAHON, Stephen William
    87 Beechwood
    EH49 6SE Linlithgow
    West Lothian
    Administrateur
    87 Beechwood
    EH49 6SE Linlithgow
    West Lothian
    United KingdomBritishProduction Test Division Dir32218950001
    MURRAY, Brian Gilchrist
    Eastview
    19 Woodside Road
    AB31 5XD Torphins Banchory
    Kincardineshire
    Administrateur
    Eastview
    19 Woodside Road
    AB31 5XD Torphins Banchory
    Kincardineshire
    BritishEngineer/Company Director65820002
    SIMPSON, David, Dr
    Elvingston House
    Gladsmuir
    EH33 1EH Tranent
    East Lothian
    Administrateur
    Elvingston House
    Gladsmuir
    EH33 1EH Tranent
    East Lothian
    ScotlandBritishCompany Director74991870001
    SNODGRASS, Matthew
    7 North Gyle Avenue
    EH12 8JS Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    7 North Gyle Avenue
    EH12 8JS Edinburgh
    Midlothian
    BritishCorporate Development Director651160001
    TROTMAN, Christopher Frank
    Ashleigh Cottage
    2 High Street Maxey
    PE6 9EB Peterborough
    Administrateur
    Ashleigh Cottage
    2 High Street Maxey
    PE6 9EB Peterborough
    EnglandBritishDirector36238850001

    LIVINGWIND LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 22 juil. 1988
    Livré le 29 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    • 3I PLC
    Transactions
    • 29 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 23 août 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 04 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Floating charge
    Créé le 22 juil. 1988
    Livré le 29 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Scottish Development Agency
    Transactions
    • 29 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 23 août 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 04 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 03 déc. 1987
    Livré le 17 déc. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 déc. 1987Enregistrement d'une charge
    • 23 août 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 20 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0