LIVINGWIND LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | LIVINGWIND LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | SC104583 |
Juridiction | Écosse |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LIVINGWIND LIMITED ?
Adresse du siège social | 2 Michaelson Square Livingston EH54 7DP West Lothian |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LIVINGWIND LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2008 |
Quels sont les derniers dépôts pour LIVINGWIND LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed skf condition monitoring centre (livingston) LIMITED\certificate issued on 23/03/10 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Bengt Hansson en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Paula Jane Owen en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Sharon Linda Smith en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Bengt Olof Hansson le 01 mai 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Mcglone en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2008 | 17 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2007 | 17 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288c | ||||||||||
legacy | 2 pages | 363a | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2006 | 16 pages | AA | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2005 | 16 pages | AA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 30 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed diagnostic instruments LIMITED\certificate issued on 22/09/06 | 2 pages | CERTNM | ||||||||||
legacy | 2 pages | 363a | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2004 | 17 pages | AA |
Qui sont les dirigeants de LIVINGWIND LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMITH, Sharon Linda | Secrétaire | 86a Dunstable Road LU5 6DR Toddington The Brick House Bedfordshire | British | 58530190003 | ||||||
OWEN, Paula Jane | Administrateur | Laburnum Grove LU3 2DW Luton 2 Bedfordshire England | England | British | Accountant | 86211040004 | ||||
SMITH, Sharon Linda | Administrateur | 86a Dunstable Road Toddington LU5 6DR Dunstable The Brick House Bedfordshire England | England | British | Accountant | 58530190003 | ||||
HANCOCK, Antony William Martin | Secrétaire | Hiltoun Lodge Turnerhall AB41 8EG Ellon Aberdeenshire | British | Accountant | 662850004 | |||||
MEIKLEJOHN, Iain Maury Campbell | Secrétaire désigné | 14 Dalrymple Crescent EH9 2NX Edinburgh | British | 900003350001 | ||||||
SMITH, Sharon Linda | Secrétaire | 9 Byfield Close Toddington LU5 6BH Dunstable Bedfordshire | British | 58530190002 | ||||||
SNODGRASS, Matthew | Secrétaire | 7 North Gyle Avenue EH12 8JS Edinburgh Midlothian | British | 651160001 | ||||||
BALFOUR, Ian | Administrateur | Sharleigh Denvale Gardens KY8 5UB Kevnoway Fife | British | Managing Director | 36486160001 | |||||
BRADLEY, Dan | Administrateur | 5271 Viewridge Court San Diego Ca 92123 Usa | American | Manager | 105556330001 | |||||
BRADLEY, Daniel Harton | Administrateur | 3220 Dumas Street CA 92106 Sandiego California Usa | American | Company Manager | 71114770001 | |||||
DUNSMORE, David Strong | Administrateur | 23 The Loan Torphichen EH48 4NF Bathgate West Lothian | British | Chartered Accountant | 260160001 | |||||
EDGAR, James Paul | Administrateur | 4 Barnton Avenue EH4 6AP Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Electronics Engineer | 651150001 | ||||
FORSBERG, Anders Eric Rune | Administrateur | Avenue Des Cedres 54 Be-1640 Rhode St Genese Belgium | Swedish | Director | 89148310001 | |||||
HANSSON, Bengt Olof | Administrateur | 43543 Pixbo Heymans Vag 20 | Swedish | Director | 98245200006 | |||||
JOHNSTON, James Neill | Administrateur | 16 Spylaw Bank Road EH13 0JW Edinburgh Midlothian | British | Chairman | 876380001 | |||||
LEADBETTER, Derek Robert | Administrateur | Fairwinds Copthorne Bank, Copthorne RH10 3QZ Crawley West Sussex | British | General Manager | 67842100001 | |||||
MCGLONE, John Patrick | Administrateur | 22 Davies Acre G74 5BZ East Kilbride Lanarkshire | British | Cmp Division Director | 49366950003 | |||||
MCMAHON, Stephen William | Administrateur | 87 Beechwood EH49 6SE Linlithgow West Lothian | United Kingdom | British | Production Test Division Dir | 32218950001 | ||||
MURRAY, Brian Gilchrist | Administrateur | Eastview 19 Woodside Road AB31 5XD Torphins Banchory Kincardineshire | British | Engineer/Company Director | 65820002 | |||||
SIMPSON, David, Dr | Administrateur | Elvingston House Gladsmuir EH33 1EH Tranent East Lothian | Scotland | British | Company Director | 74991870001 | ||||
SNODGRASS, Matthew | Administrateur | 7 North Gyle Avenue EH12 8JS Edinburgh Midlothian | British | Corporate Development Director | 651160001 | |||||
TROTMAN, Christopher Frank | Administrateur | Ashleigh Cottage 2 High Street Maxey PE6 9EB Peterborough | England | British | Director | 36238850001 |
LIVINGWIND LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Bond & floating charge | Créé le 22 juil. 1988 Livré le 29 juil. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
Floating charge | Créé le 22 juil. 1988 Livré le 29 juil. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
Bond & floating charge | Créé le 03 déc. 1987 Livré le 17 déc. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0