GUSTURN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGUSTURN LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC106072
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GUSTURN LIMITED ?

    • (7012) /

    Où se situe GUSTURN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Tracey Gray Ftv Proclad (Uk) Ltd
    Viewfield Industrial Estate
    KY6 2RD Glenrothes
    Fife
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de GUSTURN LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour GUSTURN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 janv. 2010

    État du capital au 28 janv. 2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Alan Mcintosh Rodger le 28 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Duncan Dargie Mcdougall le 28 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur John Edward Douglas Gordon le 28 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2008

    6 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2007

    6 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    10 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    11 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2004

    11 pagesAA

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    1 pages287

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de GUSTURN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GORDON, John Edward Douglas
    Tracey Gray Ftv Proclad (Uk) Ltd
    Viewfield Industrial Estate
    KY6 2RD Glenrothes
    Fife
    Administrateur
    Tracey Gray Ftv Proclad (Uk) Ltd
    Viewfield Industrial Estate
    KY6 2RD Glenrothes
    Fife
    United KingdomBritish65426370002
    MCDOUGALL, Duncan Dargie
    Tracey Gray Ftv Proclad (Uk) Ltd
    Viewfield Industrial Estate
    KY6 2RD Glenrothes
    Fife
    Administrateur
    Tracey Gray Ftv Proclad (Uk) Ltd
    Viewfield Industrial Estate
    KY6 2RD Glenrothes
    Fife
    ScotlandBritish161556820001
    MOHSEN, Yaseen Mohamed Jaafar Mohamed
    Jebel Ali Village, Road D,
    Villa No. 66, PO BOX 25567
    FOREIGN Dubai
    United Arab Emirates
    Administrateur
    Jebel Ali Village, Road D,
    Villa No. 66, PO BOX 25567
    FOREIGN Dubai
    United Arab Emirates
    DubaiBahraini97750510001
    RODGER, Alan Mcintosh
    Tracey Gray Ftv Proclad (Uk) Ltd
    Viewfield Industrial Estate
    KY6 2RD Glenrothes
    Fife
    Administrateur
    Tracey Gray Ftv Proclad (Uk) Ltd
    Viewfield Industrial Estate
    KY6 2RD Glenrothes
    Fife
    ScotlandBritish27210340001
    GRAY, Tracey Louise
    Flat 12
    68 Waverley Crescent
    EH54 8JP Livingston
    West Lothian
    Secrétaire
    Flat 12
    68 Waverley Crescent
    EH54 8JP Livingston
    West Lothian
    British104916340001
    MILES, Tracy
    28 Teasel Way
    Claines
    WR3 7LD Worcester
    Worcestershire
    Secrétaire
    28 Teasel Way
    Claines
    WR3 7LD Worcester
    Worcestershire
    British67263360002
    NIGHTINGALE, Roger
    Sheephousehill
    EH47 9EL Fauldhouse
    132
    West Lothian
    Secrétaire
    Sheephousehill
    EH47 9EL Fauldhouse
    132
    West Lothian
    British134903410001
    RAMSAY, Martin William
    Ardgarth,
    4 Bellenden Grove
    FK15 0FD Dunblane
    Perthshire
    Secrétaire
    Ardgarth,
    4 Bellenden Grove
    FK15 0FD Dunblane
    Perthshire
    British79312760001
    AYRES, Jared
    Orchard House
    Vicarage Lane
    ST12 9AG Barlaston
    Staffordshire
    Administrateur
    Orchard House
    Vicarage Lane
    ST12 9AG Barlaston
    Staffordshire
    United KingdomBritish40171280002
    BELL, Duncan Anderson
    7 Arbuthnot Road
    EH20 9RS Loanhead
    Midlothian
    Administrateur
    7 Arbuthnot Road
    EH20 9RS Loanhead
    Midlothian
    ScotlandBritish45180001
    HAYES, Stephen Hedley
    1 Hodgetts Drive
    Hayley Green
    B63 1ET Halesowen
    West Midlands
    Administrateur
    1 Hodgetts Drive
    Hayley Green
    B63 1ET Halesowen
    West Midlands
    British16415620002
    JACKSON, Hugh Galloway
    1 Victoria Avenue
    Barrhead
    G78 1GD Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    1 Victoria Avenue
    Barrhead
    G78 1GD Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish105826150001
    MACPHERSON, Duncan Campbell Neil
    Glendunning House
    Dunning Glen
    FK14 7LB Dollar
    Clackmannanshire
    Administrateur
    Glendunning House
    Dunning Glen
    FK14 7LB Dollar
    Clackmannanshire
    ScotlandBritish277190003
    NEILL, William
    3 Whitehill Terrace
    ML11 9HQ Lanark
    Administrateur
    3 Whitehill Terrace
    ML11 9HQ Lanark
    British90735820001
    NIGHTINGALE, Roger
    Sheephousehill
    EH47 9EL Fauldhouse
    132
    West Lothian
    Administrateur
    Sheephousehill
    EH47 9EL Fauldhouse
    132
    West Lothian
    British134903410001
    RAMSAY, Martin William
    Ardgarth,
    4 Bellenden Grove
    FK15 0FD Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    Ardgarth,
    4 Bellenden Grove
    FK15 0FD Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish79312760001
    SMITHSON, John Richard Temple
    Whitsome Lea
    Whitsome
    TD11 3NG Duns
    Berwickshire
    Administrateur
    Whitsome Lea
    Whitsome
    TD11 3NG Duns
    Berwickshire
    United KingdomBritish45200001
    WHITTLE, William Allan
    43 West Main Street
    EH52 5RQ Broxburn
    West Lothian
    Administrateur
    43 West Main Street
    EH52 5RQ Broxburn
    West Lothian
    ScotlandBritish45190001
    WHITTLE, William Allan
    43 West Main Street
    EH52 5RQ Broxburn
    West Lothian
    Administrateur
    43 West Main Street
    EH52 5RQ Broxburn
    West Lothian
    ScotlandBritish45190001

    GUSTURN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 30 nov. 2001
    Livré le 06 déc. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground at nettlehill road, houstoun industrial estate, livin gston, ) 1.16 hectares at nettlehill road, livingston, subjects located at telford square, houstoun industrial estate, livingston.
    Personnes ayant droit
    • Bi Group PLC
    Transactions
    • 06 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 14 nov. 2001
    Livré le 30 nov. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bi Group PLC
    Transactions
    • 30 nov. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 nov. 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 déc. 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 13 oct. 1999
    Livré le 21 oct. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Property at nettlehill road, houston industrial estate, livingston.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 oct. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 23 sept. 1999
    Livré le 30 sept. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 sept. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 nov. 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 déc. 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 14 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 26 août 1997
    Livré le 11 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.12 hectares at telford square,houston industrial estate,livingston.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 sept. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 oct. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 30 oct. 1992
    Livré le 04 nov. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by hunting park engineering limited
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 04 nov. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 21 août 1989
    Acquis le 19 nov. 1992
    Livré le 09 déc. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1.22 hectares at nettlehill road houston industrial estate livingston west lothian.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 déc. 1992Enregistrement d'une acquisition (416)
    • 30 sept. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 21 août 1989
    Acquis le 19 nov. 1992
    Livré le 09 déc. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1.22 hectares at nettlehill road houston industrial estate livingston west lothian.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 déc. 1992Enregistrement d'une acquisition (416)
    • 11 oct. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 04 févr. 1988
    Livré le 17 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 02 févr. 1988
    Livré le 10 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    2.05 hectares at nettlehill road, livingston.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 févr. 1988Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0