MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED

MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC107209
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    16 Charlotte Square
    Edinburgh
    EH2 4DF
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EWOS (ALNESS) LIMITED05 juil. 200405 juil. 2004
    AQUASCOT GROUP LIMITED27 juin 199527 juin 1995
    AQUASCOT MARKETING LIMITED19 oct. 198719 oct. 1987

    Quels sont les derniers comptes de MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 mars 2011

    État du capital au 14 mars 2011

    • Capital: GBP 438,812
    SH01

    Nomination de Mr Douglas Low en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Roger Dart en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr John Alexander Christie en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Tarald Sivertsen en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Geir Sjaastad en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de William Young en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 déc. 2009

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 déc. 2008

    16 pagesAA

    Nomination de Roger John Dart en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    Comptes annuels établis au 30 déc. 2007

    15 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    Qui sont les dirigeants de MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHRISTIE, John Alexander
    Maxwell Street
    EH10 5HT Edinburgh
    23/16
    Scotland
    Secrétaire
    Maxwell Street
    EH10 5HT Edinburgh
    23/16
    Scotland
    154184170001
    HOMBLE, Synne
    N-0491
    Oslo
    Solligrenda 11
    Norway
    Administrateur
    N-0491
    Oslo
    Solligrenda 11
    Norway
    NorwayNorwegian131062490001
    LOW, Douglas Robert Duncan
    16 Charlotte Square
    Edinburgh
    EH2 4DF
    Administrateur
    16 Charlotte Square
    Edinburgh
    EH2 4DF
    ScotlandBritish108811280002
    CHRISTIE, John Alexander
    Maxwell Street
    EH10 5HT Edinburgh
    23/16
    Midlothian
    Secrétaire
    Maxwell Street
    EH10 5HT Edinburgh
    23/16
    Midlothian
    British140170170001
    DART, Roger John
    Craigie Crescent
    KW15 1EP Kirkwall
    4
    Orkney
    Secrétaire
    Craigie Crescent
    KW15 1EP Kirkwall
    4
    Orkney
    British146392500001
    MACKAY, Heather Florence
    Claddagh
    Achterneed
    IV14 9AA Strathpeffer
    Ross Shire
    Secrétaire
    Claddagh
    Achterneed
    IV14 9AA Strathpeffer
    Ross Shire
    British67953990002
    MURRAY, Robert Russell
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    Secrétaire
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    British67953970001
    OVERTON, Dennis Karl
    Braefoot Cottages
    Fodderty
    IV15 9UE Strathpeffer
    Secrétaire
    Braefoot Cottages
    Fodderty
    IV15 9UE Strathpeffer
    British80737760001
    STUART, Matthew Gordon
    11 Drummond Road
    IV2 4NA Inverness
    Inverness Shire
    Secrétaire
    11 Drummond Road
    IV2 4NA Inverness
    Inverness Shire
    British64033870001
    AGNEW, Keith Dalway
    White Gates
    West Moulin Road
    PH16 5EQ Pitlochry
    Perthshire
    Administrateur
    White Gates
    West Moulin Road
    PH16 5EQ Pitlochry
    Perthshire
    British45855000002
    FILS, Pierre Yves
    123 Rue De La Tour
    Paris
    France
    Administrateur
    123 Rue De La Tour
    Paris
    France
    French32799380001
    HERRERA, Luis Javier
    Vanskavaig Carness Road
    St Ola
    KW15 1UE Kirkwall
    Orkney
    Administrateur
    Vanskavaig Carness Road
    St Ola
    KW15 1UE Kirkwall
    Orkney
    Chilean98594970001
    LAWRIE, Charles Sharp
    Aniton House
    48 Rubislaw Den South
    AB2 6AX Aberdeen
    Administrateur
    Aniton House
    48 Rubislaw Den South
    AB2 6AX Aberdeen
    British41249220002
    MEAKIN, Nicholas St John
    Runcton House Lorraine Way
    Bramford
    IP8 4JA Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    Runcton House Lorraine Way
    Bramford
    IP8 4JA Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish35721600001
    MORALES, Francisco Miranda
    36 Braemar, Clay Loan
    KW15 1QQ Kirkwall
    Orkney
    Administrateur
    36 Braemar, Clay Loan
    KW15 1QQ Kirkwall
    Orkney
    Chilean121143130001
    MURRAY, Robert Russell
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    Administrateur
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    United KingdomBritish67953970001
    MURRAY, Robert Russell
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    Administrateur
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    United KingdomBritish67953970001
    OVERTON, Dennis Karl
    The Braefoot
    Fodderty
    IV15 9UE Strathpeffer
    Ross Shire
    Administrateur
    The Braefoot
    Fodderty
    IV15 9UE Strathpeffer
    Ross Shire
    ScotlandBritish80737760001
    OVERTON, Dennis Karl
    Braefoot Cottages
    Fodderty
    IV15 9UE Strathpeffer
    Administrateur
    Braefoot Cottages
    Fodderty
    IV15 9UE Strathpeffer
    ScotlandBritish80737760001
    PALMER, Ronald Mackay
    Green Acres
    No 5 Knockfarrel
    IV15 9TQ Dingwall
    Ross Shire
    Administrateur
    Green Acres
    No 5 Knockfarrel
    IV15 9TQ Dingwall
    Ross Shire
    British49741450001
    PARRY, John
    Dundonnel
    IV23 2QU Garvie
    Ross-Shire
    Administrateur
    Dundonnel
    IV23 2QU Garvie
    Ross-Shire
    British1087410001
    PAYNE, James Gladstone
    Ardvar Lodge
    Drumbeg
    IV27 4NJ Lairg
    Sutherland
    Administrateur
    Ardvar Lodge
    Drumbeg
    IV27 4NJ Lairg
    Sutherland
    ScotlandBritish6196670001
    PHILLIPS, William Charles Henry
    Ivybank
    Bishopmill
    IV30 2DE Elgin
    Administrateur
    Ivybank
    Bishopmill
    IV30 2DE Elgin
    British454980001
    REEVE, Andrew James
    30 Vyner Place
    IV26 2XR Ullapool
    Administrateur
    30 Vyner Place
    IV26 2XR Ullapool
    British50186870002
    REX, Stepehen Charles
    Airor, St Martins,
    Cullicudden,By Culbokie,, Ross-Shire
    IV7 8JT By Dingwall
    Administrateur
    Airor, St Martins,
    Cullicudden,By Culbokie,, Ross-Shire
    IV7 8JT By Dingwall
    British97608220001
    SINCLAIR, Charles John
    51 Feddon Hill
    IV10 8SP Fortrose
    Ross Shire
    Scotland
    Administrateur
    51 Feddon Hill
    IV10 8SP Fortrose
    Ross Shire
    Scotland
    British50197000001
    SIVERTSEN, Tarald
    8286 Nordfold
    Norway
    Administrateur
    8286 Nordfold
    Norway
    NorwayNorwegian134255990001
    SJAASTAD, Geir
    C, 0587
    Oslo
    Fagerliveien 24
    Norway
    Administrateur
    C, 0587
    Oslo
    Fagerliveien 24
    Norway
    NorwayNorwegian133629360001
    SMITH, Philip
    Van Zuylen
    Van Nijevelstraat 102
    2242 At Wassenaar
    2242
    Netherlands
    Administrateur
    Van Zuylen
    Van Nijevelstraat 102
    2242 At Wassenaar
    2242
    Netherlands
    British73918640001
    SOUTER, William Graham
    Mid Clashdoran
    IV4 7AN Beauly
    Inverness-Shire
    Administrateur
    Mid Clashdoran
    IV4 7AN Beauly
    Inverness-Shire
    British4973520001
    STEIRO, Oystein
    Furstlia 15
    1367 Snaroya
    Norway
    Administrateur
    Furstlia 15
    1367 Snaroya
    Norway
    Norwegian81729570001
    STUART, Matthew Gordon
    11 Drummond Road
    IV2 4NA Inverness
    Inverness Shire
    Administrateur
    11 Drummond Road
    IV2 4NA Inverness
    Inverness Shire
    British64033870001
    TAIT, Michael Laurence
    1 Hayfield Court
    Commercial Street
    ZE1 0WN Lerwick
    Isle Of Shetland
    Administrateur
    1 Hayfield Court
    Commercial Street
    ZE1 0WN Lerwick
    Isle Of Shetland
    ScotlandBritish267768460002
    WHYTE, George Mccurrach Mcintosh
    Ruarach, Inverinate
    IV40 8HG Kyle
    Ross-Shire
    Administrateur
    Ruarach, Inverinate
    IV40 8HG Kyle
    Ross-Shire
    United KingdomBritish85024920001
    WILLIAMS, Peter Clifford
    13a Nelson Street
    EH3 6LF Edinburgh
    Administrateur
    13a Nelson Street
    EH3 6LF Edinburgh
    British47212810004

    MAINSTREAM (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 04 avr. 1996
    Livré le 11 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Units 12, 13, 14 and 15 teaninich industrial estate, alness.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 avr. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Marine mortgage
    Créé le 29 janv. 1996
    Livré le 05 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    64 shares in the vessel "aqua-marra-lass".
    Personnes ayant droit
    • Nws Bank PLC
    Transactions
    • 05 févr. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 07 févr. 1995
    Livré le 16 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fish farm at rhunahoarine point, kintyre, argyll.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 févr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 27 juil. 1994
    Livré le 29 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Kellock Limited
    Transactions
    • 29 juil. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 juin 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 janv. 1996Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 07 sept. 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 02 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 28 févr. 1994
    Livré le 08 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ross & Cromarty Enterprise Limited
    Transactions
    • 08 mars 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 juin 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 janv. 1996Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 07 sept. 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 03 sept. 1993
    Livré le 10 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground situated at rhunahoarine point, kintyre.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 10 sept. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 31 août 1993
    Livré le 03 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 03 sept. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 21 oct. 1989
    Livré le 26 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Highlands and Islands Development Board
    Transactions
    • 26 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    • 12 juin 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 janv. 1996Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 07 sept. 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 03 juin 1988
    Livré le 14 juin 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 juin 1988Enregistrement d'une charge
    • 12 juin 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 janv. 1996Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 10 sept. 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 23 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0