MONO GROUP

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMONO GROUP
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité illimitée
    Numéro de société SC107956
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MONO GROUP ?

    • (9999) /

    Où se situe MONO GROUP ?

    Adresse du siège social
    National Oilwell Varco Uk Ltd Badentoy Crescent
    Badentoy Industrial Estate
    AB12 4YD Portlethen
    Aberdeen
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MONO GROUP ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DMWS 68 LIMITED30 nov. 198730 nov. 1987

    Quels sont les derniers comptes de MONO GROUP ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour MONO GROUP ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    4 pagesAA

    Nomination de Alastair James Fleming en tant que secrétaire le 30 sept. 2011

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Christopher Paul O'neil en tant que secrétaire le 30 sept. 2011

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de David Keener en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Christopher Paul O'neil en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de David James Keener en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Thomas Boyle en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 juin 2011

    État du capital au 21 juin 2011

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Thomas Douglas Boyle le 13 juin 2011

    2 pagesCH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2010

    5 pagesAA

    État du capital au 21 déc. 2010

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    Résolutions

    Resolutions
    28 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolutions

    Reduce share premium account 17/12/2010
    RES13

    Cessation de la nomination de Katherine Leighton en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Naylon le 13 juin 2010

    2 pagesCH01

    Nomination de Christopher Paul O'neil en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    14 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages353

    Qui sont les dirigeants de MONO GROUP ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FLEMING, Alastair James
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    Secrétaire
    Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Park
    Portlethen
    AB12 4YD Aberdeen
    C/O National Oilwell Varco
    United Kingdom
    163563910001
    NAYLON, Paul
    338 Newton Road
    Lowton
    WA3 1HE Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    338 Newton Road
    Lowton
    WA3 1HE Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishManaging Director28875970001
    O'NEIL, Christopher Paul
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishTax Manager162062160001
    VALENTINE, Steven Grenville
    4 Barnes Close
    Haslington
    CW1 5ZG Crewe
    Administrateur
    4 Barnes Close
    Haslington
    CW1 5ZG Crewe
    EnglandBritishFinance Director92773870002
    FLETCHER, Anthony Trevor
    Higher Oaklands Farm House
    Barrowford
    BB9 6QZ Nelson
    Secrétaire
    Higher Oaklands Farm House
    Barrowford
    BB9 6QZ Nelson
    British113788270001
    LEIGHTON, Katherine Jennifer
    Kirk House
    Victoria Terrace, Kemnay
    AB51 5RL Inverurie
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    Kirk House
    Victoria Terrace, Kemnay
    AB51 5RL Inverurie
    Aberdeenshire
    BritishAccountant110703040002
    MATHER, Melanie Gay
    2717 Luella
    77536 Deer Park
    Texas
    Usa
    Secrétaire
    2717 Luella
    77536 Deer Park
    Texas
    Usa
    American92773820001
    O'NEIL, Christopher Paul
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    Secrétaire
    Forest Park
    AB39 2GF Stonehaven
    69
    Kincardineshire
    British146000450001
    TORKINGTON, John Robert
    2 Barwell Close
    Reddish
    SK5 6YF Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    2 Barwell Close
    Reddish
    SK5 6YF Stockport
    Cheshire
    BritishAccountant35453200001
    BODDINGTON, Kenneth William
    4 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    4 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    BritishDirector1343490001
    BOYLE, Thomas Douglas
    Lanark
    Old Inn Road, Findon Portlethen
    AB12 3RT Aberdeen
    Administrateur
    Lanark
    Old Inn Road, Findon Portlethen
    AB12 3RT Aberdeen
    UkBritishUk Finance Director61611910001
    CAMP, Glenn Bryan
    19 Hough Lane
    Gristhorpe
    SK9 2LQ Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    19 Hough Lane
    Gristhorpe
    SK9 2LQ Wilmslow
    Cheshire
    AmericanManaging Director54147750001
    FITZGERALD, Mel Oliver
    3 Marlyns Drive
    Burpham
    GU4 7LS Guildford
    Surrey
    Administrateur
    3 Marlyns Drive
    Burpham
    GU4 7LS Guildford
    Surrey
    United Kingdom/EnglandIrishChartered Engineer69993790001
    FLETCHER, Anthony Trevor
    Higher Oaklands Farm House
    Barrowford
    BB9 6QZ Nelson
    Administrateur
    Higher Oaklands Farm House
    Barrowford
    BB9 6QZ Nelson
    BritishDirector113788270001
    GARVEY, William
    1 Chapel Brow
    Broadbottom
    SK14 6HH Hyde
    Cheshire
    Administrateur
    1 Chapel Brow
    Broadbottom
    SK14 6HH Hyde
    Cheshire
    BritishDirector590690001
    GARVEY, William
    1 Chapel Brow
    Broadbottom
    SK14 6HH Hyde
    Cheshire
    Administrateur
    1 Chapel Brow
    Broadbottom
    SK14 6HH Hyde
    Cheshire
    BritishDirector590690001
    HARRISON, Michael
    126 Manchester Road
    Chapel En Le Frith
    SK12 6TP Stockport
    Cheshire
    England
    Administrateur
    126 Manchester Road
    Chapel En Le Frith
    SK12 6TP Stockport
    Cheshire
    England
    EnglandBritishManager86410610001
    HERBERT, John Shotton
    Michelend
    Lewes Road, Westmeston
    BN6 8RH Hassocks
    West Sussex
    Administrateur
    Michelend
    Lewes Road, Westmeston
    BN6 8RH Hassocks
    West Sussex
    BritishChartered Accountant81675020001
    HOUSTON, John Joseph
    3 Kinmundy Avenue
    AB32 6TG Westhill
    Aberdeenshire
    Administrateur
    3 Kinmundy Avenue
    AB32 6TG Westhill
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishFinancial Controller81041240001
    HUGHES, Emyr Tonlas
    Danesbury 50 Byng Drive
    EN6 1UF Potters Bar
    Hertfordshire
    Administrateur
    Danesbury 50 Byng Drive
    EN6 1UF Potters Bar
    Hertfordshire
    BritishDirector40119990001
    KASH, John
    57 Aspen Drive
    FOREIGN Basking Ridge
    New Jersey
    Usa
    Administrateur
    57 Aspen Drive
    FOREIGN Basking Ridge
    New Jersey
    Usa
    AmericanExecutive Vice President Opera9489980001
    KEENER, David James
    4819 Xp
    Rijsbergen
    Oranjestraat 33
    Netherlands
    Administrateur
    4819 Xp
    Rijsbergen
    Oranjestraat 33
    Netherlands
    NetherlandsUsaCompany Director161469350001
    KENNEDY, Michael James
    15 Heathway
    CR3 5DN Caterham
    Surrey
    Administrateur
    15 Heathway
    CR3 5DN Caterham
    Surrey
    BritishFinancial Director54147870002
    KRABLIN, Steven Wayne
    9619 Windrush Drive
    77379 Spring
    Texas
    Usa
    Administrateur
    9619 Windrush Drive
    77379 Spring
    Texas
    Usa
    UsaUnited StatesChief Financial Officer69886740001
    MATHEWSON, Lindsay Thomas
    21 Macclesfield Road
    SK17 9AH Buxton
    Derbyshire
    Administrateur
    21 Macclesfield Road
    SK17 9AH Buxton
    Derbyshire
    BritishDirector590700001
    MOLLER, Leslie George
    12 Chester Court
    Chester Road
    HA6 1BQ Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    12 Chester Court
    Chester Road
    HA6 1BQ Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Director63570320001
    NICHOLSON, Stephen John
    48 Wolseley Gardens
    W4 3LS London
    Administrateur
    48 Wolseley Gardens
    W4 3LS London
    BritishCompany Director3042100001
    OCONNOR, William Evans
    Gristhorpe
    19 Hough Lane
    SK9 2LQ Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    Gristhorpe
    19 Hough Lane
    SK9 2LQ Wilmslow
    Cheshire
    Us Citizen13102020001
    SPEIRS, John Garrett
    20 Dunstall Road
    Wimbledon
    SW20 0HR London
    Administrateur
    20 Dunstall Road
    Wimbledon
    SW20 0HR London
    EnglandBritishDirector428480001
    TOCHER, Judith Robertson
    Blacktop House, Blacktop
    Kingswells
    AB15 8QJ Aberdeen
    Administrateur
    Blacktop House, Blacktop
    Kingswells
    AB15 8QJ Aberdeen
    United KingdomBritishLawyer82086030001
    WHITE, Philip Arthur Laxton
    15 Bedford Street
    Stockton Heath
    WA4 6LY Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    15 Bedford Street
    Stockton Heath
    WA4 6LY Warrington
    Cheshire
    BritishDirector13102030001

    MONO GROUP a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 08 juin 1988
    Livré le 28 juin 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    (A) by way of third fixed charge all the property (if any) specified in the first schedule of the debenture together with all buildings and fixtures (as hereinafter defined) thereon and the benefit of any covenants for title given or entered into by any predecessor in title of the company and any moneys paid or payable in performance of such covenants; (b) by way of third fixed charge all estates or interests in any freehold or leasehold property.
    Personnes ayant droit
    • Gallaher LTD
    Transactions
    • 28 juin 1988Enregistrement d'une charge
    Guarantee & debenture
    Créé le 08 juin 1988
    Livré le 16 juin 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1. by way of second fixed charge all estates or interest in any freehold or leasehold property wheresoever situate now belonging to the company and all buildings and fixtures thereon; 2. by way of second fixed charge: (a) all of the shares; and (b) all dividends paid or payable after the date hereof on all or any of the shares and all stocks, shares, securities (and the dividends or interest thereon), rights, moneys or property accruing or offered at any time by way of redemption, bonus, preference, option rights or otherwise to or in respect of any of the shares or in substitution or exchange for any of them; and 3. by way of second fixed charge: (a) all present and future estates or interests in any freehold or leasehold property belonging to it and all buildings and fixtures thereon and all proceeds of sale thereof; (b) all plant and machinery now or in the future owned by the company and its interest in any such plant or machinery in its possession; (c) its present and future interest in all stocks, shares (other than the shares), debentures, bonds or other securities; (d) all moneys (including interest) standing to the credit of each of its accounts with any bank, financial institution or other person and the debt or debts represented thereby.
    Personnes ayant droit
    • Bankers Trust Company
    Transactions
    • 16 juin 1988Enregistrement d'une charge
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Guarantee & debenture
    Créé le 08 juin 1988
    Livré le 16 juin 1988
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1. by way of first legal mortgage all estates or interest in any freehold or leasehold property wheresoever situate now belonging to the company and all buildings and fixtures thereon; 2. by way of first legal mortgage: (a) all of the shares; and (b) all dividends paid or payable after the date hereof on all or any of the shares and all stocks, shares, securities (and the dividends or interest thereon) rights, moneys or property accruing or offered at any time by way of redemption, bonus, preference, option rights or otherwise to or in respect of any of the shares or in substitution or exchange for any of them; and 3. by way of first fixed charge: (a) all present and future estates or interests in any freehold or leasehold property belonging to it and all buildings and fixtures thereon and all proceeds of sale thereof; (b) all plant and machinery now or in the future owned by the company and its interest in any such plant or machinery in its possession; (c) its present and future interest in all stocks, shares (other than the shares), debentures, bonds or other securities; (d) all moneys (including interest) standing to the credit of each of its accounts with any bank, financial institution or other person and the debt or debts represented thereby.
    Personnes ayant droit
    • Bankers Trust Company as Agent for Itself & Others
    Transactions
    • 16 juin 1988Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0