PHOENIX SCP TRUSTEES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PHOENIX SCP TRUSTEES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC108046 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PHOENIX SCP TRUSTEES LIMITED ?
| Adresse du siège social | Standard Life House Lothian Road EH1 2DH Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PHOENIX SCP TRUSTEES LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PHOENIX SCP TRUSTEES LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 avr. 2027 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 15 avr. 2027 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 avr. 2026 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour PHOENIX SCP TRUSTEES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 01 avr. 2026 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Pearl Group Secretariat Services Limited le 10 nov. 2025 | 1 pages | CH04 | ||||||
Modification des détails de Phoenix Group Management Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 nov. 2025 | 2 pages | PSC05 | ||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2024 | 17 pages | AA | ||||||
Cessation de la nomination de Dean Paul Butler en tant que directeur le 29 sept. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 avr. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Deuxième dépôt de la déclaration de confirmation datée du 01 avr. 2023 | 3 pages | RP04CS01 | ||||||
Nomination de Mr Dean Paul Butler en tant qu'administrateur le 06 déc. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||
Nomination de Mrs Amy Elizabeth Madden en tant qu'administrateur le 06 déc. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||
Cessation de la nomination de Brid Mary Meaney en tant que directeur le 06 déc. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||
Cessation de la nomination de Samantha Rose Buckle en tant que directeur le 06 déc. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2023 | 17 pages | AA | ||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Brid Mary Meaney le 10 avr. 2024 | 2 pages | CH01 | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 avr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Deuxième dépôt pour la nomination de Samantha Rose Buckle en tant qu'administrateur | 3 pages | RP04AP01 | ||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2022 | 17 pages | AA | ||||||
Modification des détails de Pearl Group Management Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 janv. 2023 | 2 pages | PSC05 | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 avr. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
| ||||||||
Nomination de Ms Samantha Rose Buckle en tant qu'administrateur le 31 déc. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||
| ||||||||
Nomination de Ms Jacqueline Dorothy Mary Noakes en tant qu'administrateur le 31 déc. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||
Cessation de la nomination de Antonios Kassimiotis en tant que directeur le 31 déc. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||
Nomination de Mrs Brid Mary Meaney en tant qu'administrateur le 31 déc. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||
Cessation de la nomination de Andrew Moss en tant que directeur le 31 déc. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 15 pages | AA | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 avr. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Qui sont les dirigeants de PHOENIX SCP TRUSTEES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEARL GROUP SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secrétaire | Brindleyplace B1 2JB Birmingham 10 United Kingdom |
| 115204320002 | ||||||||||
| MADDEN, Amy Elizabeth | Administrateur | Lothian Road EH1 2DH Edinburgh Standard Life House Scotland | United Kingdom | British | 330096850001 | |||||||||
| NOAKES, Jacqueline Dorothy Mary | Administrateur | Lothian Road EH1 2DH Edinburgh Standard Life House Scotland | United Kingdom | Irish | 252091280001 | |||||||||
| HENDERSON, Gordon | Secrétaire | Surrenden Lodge 23 Cammo Crescent EH4 8DZ Edinburgh Midlothian | British | 344750001 | ||||||||||
| RAMSAY, Caroline | Secrétaire | 1 Maclean Place Bishopbriggs G64 3BJ Glasgow Lanarkshire | British | 39851670003 | ||||||||||
| ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secrétaire | Abbey National House 2 Triton Square Regent's Place NW1 3AN London | 61749570003 | |||||||||||
| BELL, Ian James | Administrateur | Symington Lodge Farmhouse Symington ML12 6LW Biggar Lanarkshire | British | 68362820001 | ||||||||||
| BRYSON, Norval Mackenzie, Dr | Administrateur | Achmore 1 Hillview Terrace EH12 8RA Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 344790003 | |||||||||
| BUCHANAN, Jeanette Scott | Administrateur | 9 Craiglockhart Quadrant EH14 1HD Edinburgh Midlothian | British | 73590790001 | ||||||||||
| BUCKLE, Samantha Rose | Administrateur | Lothian Road EH1 2DH Edinburgh Standard Life House Scotland | England | British | 304185800002 | |||||||||
| BUTLER, Dean Paul | Administrateur | Lothian Road EH1 2DH Edinburgh Standard Life House Scotland | England | British | 330098580001 | |||||||||
| CLARK, Rosalie Elizabeth | Administrateur | Mercury Cottage, Newport Road DD6 9AU Tayport Fife | British | 83704950001 | ||||||||||
| DOWNING, Wadham St John | Administrateur | Lilac Croft Pool Close Little Comberton WR10 3EL Pershore Worcestershire | United Kingdom | British | 107951950001 | |||||||||
| FELSTON, Graham Stuart | Administrateur | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 England | British Citizen | British | 80578130002 | |||||||||
| FITZGERALD, Peter Gerald | Administrateur | Echline Farmhouse EH30 9SW South Queensferry West Lothian | British | 344800002 | ||||||||||
| GARDINER, Stanley Richard | Administrateur | 9 Netherbank View EH16 6YY Edinburgh Mid Lothian Scotland | British | 52228050001 | ||||||||||
| GILLON, Hamish William | Administrateur | 12 Avon Road EH4 6RD Edinburgh Midlothian | British | 344780001 | ||||||||||
| GRAHAM, John | Administrateur | 10 Woodhall Road EH13 0DX Edinburgh Midlothian | British | 8878120001 | ||||||||||
| JOYCE, James Mason | Administrateur | 26 Cedarwood Avenue Newton Mearns G77 5QD Glasgow | British | 39138330001 | ||||||||||
| KASSIMIOTIS, Antonios | Administrateur | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 England | United Kingdom | Australian | 180514160001 | |||||||||
| KILPATRICK, Stuart | Administrateur | 32 Esslemont Road EH16 5PY Edinburgh Midlothian | British | 803590001 | ||||||||||
| LUSCOMBE, Kerr | Administrateur | 3e Melbourne Court Braidpark Drive, Giffnock G46 6LA Glasgow | Scotland | British | 83541890001 | |||||||||
| MARCHANT, Patricia Mary | Administrateur | 15 Deenethorpe NN17 3EP Corby Newlands | United Kingdom | British | 135374250001 | |||||||||
| MEANEY, Brid Mary | Administrateur | Lothian Road EH1 2DH Edinburgh Standard Life House Scotland | England | Irish | 284496660001 | |||||||||
| MEEHAN, Brendan Joseph | Administrateur | 24 Kirby Close NN4 6AB Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 98270380001 | |||||||||
| MOORE, David James | Administrateur | Macbiehill Cottage EH46 7AZ West Linton Peeblesshire | British | 370060001 | ||||||||||
| MORGAN, Michael Bartlett | Administrateur | The Conifers 520b Lanark Road West Balerno EH14 7DH Edinburgh Midlothian | British | 92766610001 | ||||||||||
| MOSS, Andrew | Administrateur | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 England | England | British | 151524430063 | |||||||||
| NICHOLSON, Marina | Administrateur | Hideaway Ferrygate EH39 5DQ North Berwick East Lothian | British | 73590820001 | ||||||||||
| POTTINGER, Graham Robert | Administrateur | 1 Gotter Bank Quarriers Village PA11 3NX Bridge Of Weir Renfrewshire | British | 33361050003 | ||||||||||
| RAMSAY, Donald | Administrateur | 219 Nithsdale Road G41 5HA Glasgow | Scotland | British | 43514780002 | |||||||||
| SCOTT, William Andrew Black | Administrateur | 56 Durham Avenue EH15 1RY Edinburgh Midlothian | British | 344770001 | ||||||||||
| SEYMOUR-JACKSON, Ralph Thomas | Administrateur | 408 Ferry Road EH5 2AD Edinburgh | British | 58315620001 | ||||||||||
| SHERLOCK, John William | Administrateur | Seaforth Nisbet Road EH31 2BQ Gullane East Lothian Uk | British | 60092530001 | ||||||||||
| SMITH, Craigie Alexander Donald | Administrateur | 4 Netherby Road EH5 3NA Edinburgh Midlothian | British | 370070001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PHOENIX SCP TRUSTEES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Group Management Services Limited | 06 avr. 2016 | Brindleyplace B1 2JB Birmingham 10 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0