STIRLING MARINE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTIRLING MARINE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC108613
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STIRLING MARINE LIMITED ?

    • (6110) /

    Où se situe STIRLING MARINE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Stirling & Gilmour
    Pavilion Court
    G81 1BL 45 Kilbowie Road, Clydebank
    Dunbartonshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STIRLING MARINE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AIDEN SHIPPING COMPANY LIMITED07 mai 199207 mai 1992
    HARRISONS INTERNATIONAL LIMITED 02 oct. 198902 oct. 1989
    PACIFIC SHELF 150 LIMITED11 janv. 198811 janv. 1988

    Quels sont les derniers comptes de STIRLING MARINE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour STIRLING MARINE LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour STIRLING MARINE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    4 pages4.26(Scot)

    Cessation de la nomination de Richard Ryan en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    4 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    4 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 juil. 2010

    État du capital au 02 juil. 2010

    • Capital: GBP 334,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    12 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    11 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    12 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de STIRLING MARINE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ALAIS, Steven Morton
    9 Grays Inn Square
    WC1R 5JF London
    Secrétaire
    9 Grays Inn Square
    WC1R 5JF London
    British2988490001
    CAMBURN, Clyde Martin
    1 Marsh Cottage
    Shepherds Lane Reydon
    IP18 6SB Southwold
    Administrateur
    1 Marsh Cottage
    Shepherds Lane Reydon
    IP18 6SB Southwold
    EnglandBritish44503380004
    GELLERT, John Matthew
    25th Floor
    1370 Avenue Of The Americas
    10010 New York
    Ny 10019
    Usa
    Administrateur
    25th Floor
    1370 Avenue Of The Americas
    10010 New York
    Ny 10019
    Usa
    United StatesAmerican70080070001
    BAIRD, David George
    19 Blackwood Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JY Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    19 Blackwood Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JY Glasgow
    Lanarkshire
    British25620001
    MD SECRETARIES LIMITED
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Secrétaire désigné
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    900005110001
    BAIRD, David George
    19 Blackwood Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JY Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    19 Blackwood Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JY Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish25620001
    BENSON, David Gillies
    Ducks Farm
    Eastcott
    SN10 4PJ Devizes
    Wiltshire
    Administrateur
    Ducks Farm
    Eastcott
    SN10 4PJ Devizes
    Wiltshire
    British1856390001
    BURROWS, Ian Edwin
    32 Queen Street
    G84 9QL Helensburgh
    Dunbartonshire
    Administrateur
    32 Queen Street
    G84 9QL Helensburgh
    Dunbartonshire
    British25670001
    CADENHEAD, Kenneth Caldwell
    6 Kinnoul Lane
    G12 9HF Glasgow
    Administrateur
    6 Kinnoul Lane
    G12 9HF Glasgow
    British25680002
    CADENHEAD, Kenneth Caldwell
    6 Kinnoul Lane
    G12 9HF Glasgow
    Administrateur
    6 Kinnoul Lane
    G12 9HF Glasgow
    British25680002
    COWDEROY, James Anthony Frank
    The Glassert
    Lochard Road
    FK8 3TJ Aberfoyle
    Stirlingshire
    Administrateur
    The Glassert
    Lochard Road
    FK8 3TJ Aberfoyle
    Stirlingshire
    ScotlandBritish40380390001
    HARRISON, Iain Victor Robinson
    Craighat
    Killearn
    G63 9QL Glasgow
    Administrateur
    Craighat
    Killearn
    G63 9QL Glasgow
    ScotlandBritish38290001
    LENTHALL, Rodney Desmonde Morgan
    Mulberry Lodge
    Lodge Hill Road
    GU10 3RD Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Mulberry Lodge
    Lodge Hill Road
    GU10 3RD Farnham
    Surrey
    British64332640001
    RYAN, Richard James
    6 Redcliffe Way
    NR13 5LS Brundall
    Norfolk
    Administrateur
    6 Redcliffe Way
    NR13 5LS Brundall
    Norfolk
    United KingdomBritish75873300001
    WILSON, Andrew George
    Little Carbeth
    G63 9QJ Killearn
    Glasgow
    Administrateur
    Little Carbeth
    G63 9QJ Killearn
    Glasgow
    British782420001
    WORDIE, Peter Jeffrey
    The Row
    FK15 9NZ Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    The Row
    FK15 9NZ Dunblane
    Perthshire
    British25640001
    MD SECRETARIES LIMITED
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Administrateur désigné
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    900005110001

    STIRLING MARINE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of covenant
    Créé le 10 juil. 1998
    Livré le 30 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Earnings in respect of the vessel "stirling tay".
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 juil. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Deed of covenant
    Créé le 09 juil. 1998
    Livré le 10 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    64/64TH shares,the earnings & requisition compensation the vessel "stirling tay".
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 juil. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Second priority statutory ship mortgage
    Créé le 09 juil. 1998
    Livré le 10 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    64/64TH shares in the ship "stirling tay".
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 juil. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    First priority statutory ship mortgage
    Créé le 09 juil. 1998
    Livré le 10 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    64/64TH shares in the ship "stirling tay".
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transactions
    • 10 juil. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Performance guarantee assignation
    Créé le 22 août 1997
    Livré le 28 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All the companys beneficial interest & its rights & titles.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 août 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Assignation in security
    Créé le 22 août 1997
    Livré le 28 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole right,title and interest under the contracts.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 août 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Delivery order
    Créé le 22 août 1997
    Livré le 28 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The vessel, her engines,equipment,machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 août 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Shipowners form
    Créé le 22 août 1997
    Livré le 28 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The company's obligations under the shipowners form
    Brèves mentions
    Any moneys payable in accordance with the terms of the security documents.
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transactions
    • 28 août 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Deed of covenant
    Créé le 26 août 1996
    Livré le 28 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Companys right,title and interest in all money payable by shell U.K. limited.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 août 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Deed of covenant
    Créé le 23 août 1996
    Livré le 28 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All rights,title and interest in & to the mortgaged property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 août 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Second priority statutory mortgage
    Créé le 23 août 1996
    Livré le 26 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    64/64TH shares in the vessel "stirling forth" registered on the bahamas no. 728058.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 août 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    First priority statutory ship mortgage
    Créé le 23 août 1996
    Livré le 26 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    64/64TH shares on the vessel "stirling forth" registered in the bahamas no.728508.
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transactions
    • 26 août 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 09 janv. 1996
    Livré le 22 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    51/64TH shares in the ship "stirling fyne", off no 726104, registered at nassau, and her boats, guns, etc....... see ch microfiche for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and Others
    Transactions
    • 22 janv. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Deed of covenant
    Créé le 09 janv. 1996
    Livré le 22 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The company's rights, title and interest in the ship and its shares.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent and Trustee for Others
    Transactions
    • 22 janv. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignment
    Créé le 09 janv. 1996
    Livré le 22 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The earnings, requisition compensation, etc....... see ch microfiche for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent and Trustee for Others
    Transactions
    • 22 janv. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 08 janv. 1996
    Livré le 22 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent and Trustee for Others
    Transactions
    • 22 janv. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 janv. 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 sept. 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 09 sept. 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 09 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 08 janv. 1996
    Livré le 22 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by stirling offshore limited
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 22 janv. 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 22 janv. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 sept. 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 09 sept. 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 09 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Performance guarantee assignation
    Créé le 15 déc. 1995
    Livré le 19 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The company's whole beneficial interest and all its benefits, rights and titles (but not its obligations) in and under the performance guarantee dated 30/3/95 made by kvaerner A.S. in favour of the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 déc. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Contract assignation
    Créé le 15 déc. 1995
    Livré le 19 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The company's whole rights, interests and benefits (but not its obligations) under the ship building contract dated 30/3/95, relating to the construction of a vessel to be known during construction as yard no. 310....... see ch microfiche for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 déc. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Delivery order
    Créé le 15 déc. 1995
    Livré le 19 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The vessel known as yard no. 310 and all her engines, equipment, etc....... see ch microfiche.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 déc. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Shipowners form
    Créé le 15 déc. 1995
    Livré le 19 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All sums payable under clause 10.2 of a contract assignation and clause 10 of the general terms by the company....... See ch microfiche for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transactions
    • 19 déc. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Deed of covenant
    Créé le 21 nov. 1994
    Livré le 12 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due and to become due under a loan agreement, guarantee and security documents
    Brèves mentions
    By way of security for the secured indebtedness the chargor as beneficial owner mortgages and charges and agrees to mortgage asnd charge to and in favour of the chargee all its rights, title and interest, present and future, to and in the ship and to and in the shares of the ship owned by the chargor.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 déc. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Four party agreement
    Créé le 21 nov. 1994
    Livré le 12 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due and to become due in terms of a loan agreement
    Brèves mentions
    1) the head charterparty and the head charter rights 2) any requisition compensation and the earnings.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 déc. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 21 nov. 1994
    Livré le 12 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due and to become due in terms of a loan agreement and a deed of covenant
    Brèves mentions
    51/64 shares, of which the chargee is owner, in the motor ship "stirling fyne" (ex edda fjord) registered on the bahamian flag at the port of nassau.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 déc. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 21 nov. 1994
    Livré le 12 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £2,650,000 and all further sums due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 déc. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 déc. 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 sept. 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 09 sept. 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 09 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui

    STIRLING MARINE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    01 févr. 2011Commencement of winding up
    02 oct. 2015Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0