BLANE LEISURE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBLANE LEISURE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC109050
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BLANE LEISURE LIMITED ?

    • Vente au détail d'articles de sport, d'articles de pêche, d'articles de camping, de bateaux et de bicyclettes (47640) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Vente au détail de vêtements en magasin spécialisé (47710) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Vente au détail de chaussures en magasin spécialisé (47721) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Vente au détail d'articles en cuir en magasin spécialisé (47722) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe BLANE LEISURE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o KPMG LLP
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BLANE LEISURE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 janv. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BLANE LEISURE LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BLANE LEISURE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de passage de l'administration à la dissolution

    21 pages2.26B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    21 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    20 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    20 pages2.20B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    1 pages2.22B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    21 pages2.20B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    1 pages2.22B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    21 pages2.20B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    1 pages2.22B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    27 pages2.20B(Scot)

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Proposition réputée de l'administrateur

    1 pages2.16BZ(Scot)

    Proposition de l'administrateur

    59 pages2.16B(Scot)

    legacy

    6 pagesMG05s

    legacy

    6 pagesMG05s

    legacy

    6 pagesMG05s

    legacy

    6 pagesMG05s

    legacy

    6 pagesMG05s

    legacy

    6 pagesMG05s

    legacy

    3 pagesMG03s

    Qui sont les dirigeants de BLANE LEISURE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILLIAMS, David Robert
    c/o Kpmg Llp
    Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    20
    Secrétaire
    c/o Kpmg Llp
    Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    20
    161504010001
    ADAMS, David Alexander Robertson
    c/o Kpmg Llp
    Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    20
    Administrateur
    c/o Kpmg Llp
    Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    20
    EnglandBritish55757700003
    CHRISTENSEN, Lawrence Richard
    c/o Kpmg Llp
    Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    20
    Administrateur
    c/o Kpmg Llp
    Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    20
    United KingdomBritish171869050001
    CORLISS, Robert James
    c/o Kpmg Llp
    Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    20
    Administrateur
    c/o Kpmg Llp
    Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    20
    UsaAmerican170571310001
    WILLIAMS, David Robert
    c/o Kpmg Llp
    Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    20
    Administrateur
    c/o Kpmg Llp
    Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    20
    United KingdomBritish157062220001
    ASHBY, Jonathan
    Hinckley Court
    CW12 4WE Congleton
    1
    Cheshire
    Secrétaire
    Hinckley Court
    CW12 4WE Congleton
    1
    Cheshire
    British134682180001
    GREENWOOD, John David
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    Secrétaire
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    British4527320003
    HUNTER, Thomas Campbell
    19 Savoy Court
    KA7 2XP Ayr
    Secrétaire
    19 Savoy Court
    KA7 2XP Ayr
    British791810001
    KAYE, David Stanley
    3 Egidia Avenue
    Giffnock
    G46 7NH Glasgow
    Secrétaire
    3 Egidia Avenue
    Giffnock
    G46 7NH Glasgow
    British78278710003
    MADELEY, David Phillip
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    Secrétaire
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    British128847520001
    MANNING, Richard Denley John
    56/58 Argyle Street
    Glasgow
    G2 8AF Lanarkshire
    Secrétaire
    56/58 Argyle Street
    Glasgow
    G2 8AF Lanarkshire
    152718110001
    CLAIRMONTS SOLICITORS
    9 Clairmont Gardens
    G3 7LW Glasgow
    Secrétaire
    9 Clairmont Gardens
    G3 7LW Glasgow
    44581680001
    COPPOCK, Lawrence Patrick
    The Close
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    Administrateur
    The Close
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    EnglandUnited Kingdom152718990001
    DUNN, Barry John Keith
    The Farm House
    Back Lane Heath Charnock
    PR6 9DJ Chorley
    Administrateur
    The Farm House
    Back Lane Heath Charnock
    PR6 9DJ Chorley
    United KingdomBritish60493690005
    DUNN, Barry John Keith
    4 The Walled Garden
    Shaw Hill Drive
    PR6 7PD Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    4 The Walled Garden
    Shaw Hill Drive
    PR6 7PD Chorley
    Lancashire
    British60493690001
    GIBB, Duncan John
    78 Mure Avenue
    KA3 1TT Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    78 Mure Avenue
    KA3 1TT Kilmarnock
    Ayrshire
    British791830001
    GRABINER, Ian Michael
    Daylesford
    5 Methven Road
    G46 6TG Glasgow
    Administrateur
    Daylesford
    5 Methven Road
    G46 6TG Glasgow
    ScotlandBritish63235540002
    GREENWOOD, John David
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritish4527320003
    HUNTER, Marion Agnes
    The Paddock
    Southwood Road
    Troon
    Administrateur
    The Paddock
    Southwood Road
    Troon
    British1116210002
    HUNTER, Thomas Campbell
    19 Savoy Court
    KA7 2XP Ayr
    Administrateur
    19 Savoy Court
    KA7 2XP Ayr
    British791810001
    HUNTER, Thomas Blane, Sir
    Ladykirk House
    Ladykirk Estate
    KA9 2SF Monkton
    Administrateur
    Ladykirk House
    Ladykirk Estate
    KA9 2SF Monkton
    United KingdomBritish97904280003
    JONES, David Charles, Sir
    Whinbrae Wheatley Lane
    Ben Rhydding
    LS29 8SF Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Whinbrae Wheatley Lane
    Ben Rhydding
    LS29 8SF Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish11515940001
    JONES, Keith John
    56/58 Argyle Street
    Glasgow
    G2 8AF Lanarkshire
    Administrateur
    56/58 Argyle Street
    Glasgow
    G2 8AF Lanarkshire
    United KingdomBritish149574500001
    KINNAIRD, John
    1 Courthill
    Bearsden
    G61 3SN Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    1 Courthill
    Bearsden
    G61 3SN Glasgow
    Lanarkshire
    British70691510002
    KNIGHT, Thomas William
    Flat 5 Eastfield House
    15 Moor Road South
    NE3 1ND Gosforth
    Administrateur
    Flat 5 Eastfield House
    15 Moor Road South
    NE3 1ND Gosforth
    British11423040008
    MADELEY, David Phillip
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    Administrateur
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    EnglandBritish128847520001
    MANNING, Richard Denley John
    39 Ash Lane
    BA5 2LR Wells
    Somerset
    Administrateur
    39 Ash Lane
    BA5 2LR Wells
    Somerset
    United KingdomBritish77961690001
    MCCLUSKEY, Brian
    5b Longbank Road
    Alloway
    KA7 4SA Ayr
    Ayrshire
    Uk
    Administrateur
    5b Longbank Road
    Alloway
    KA7 4SA Ayr
    Ayrshire
    Uk
    British68223140002
    RIGBY, Mary
    Greystone Farm 1 Hall Lane
    Parbold
    WN8 7BD Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    Greystone Farm 1 Hall Lane
    Parbold
    WN8 7BD Wigan
    Lancashire
    British28471030002
    RONNIE, Christopher
    Grove House
    83 Knutsford Road
    SK9 6JH Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    Grove House
    83 Knutsford Road
    SK9 6JH Wilmslow
    Cheshire
    EnglandScottish79360390002
    RONNIE, Christopher
    2 Arnprior Place
    Alloway
    KA7 4PT Ayr
    Ayrshire
    Administrateur
    2 Arnprior Place
    Alloway
    KA7 4PT Ayr
    Ayrshire
    British54926420003
    SHARPE, Duncan James
    Waddington Old Hall Clitheroe Road
    Waddington
    BB7 3HP Clitheroe
    Lancashire
    Administrateur
    Waddington Old Hall Clitheroe Road
    Waddington
    BB7 3HP Clitheroe
    Lancashire
    British13873080002
    TRANTER, Colin Albert
    Off Sandy Lane
    Lower Peover
    WA16 9JF Knutsford
    Woodside Cottage
    Cheshire
    Uk
    Administrateur
    Off Sandy Lane
    Lower Peover
    WA16 9JF Knutsford
    Woodside Cottage
    Cheshire
    Uk
    United KingdomBritish138755910001
    WHELAN, David
    The Manor House
    Miry Lane Parbold
    WN8 7TA Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    The Manor House
    Miry Lane Parbold
    WN8 7TA Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritish4527330001
    WILLIAMS, Peter Wodehouse
    Rayners Road
    SW15 2AY London
    3
    Administrateur
    Rayners Road
    SW15 2AY London
    3
    EnglandBritish135547730001

    BLANE LEISURE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 27 avr. 2012
    Livré le 08 mai 2012
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 08 mai 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 22 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • 22 nov. 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (MG05s)
    Bond & floating charge
    Créé le 27 avr. 2012
    Livré le 08 mai 2012
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 08 mai 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 22 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • 22 nov. 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (MG05s)
    Guarantee & debenture
    Créé le 03 juin 2009
    Livré le 16 juin 2009
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First legal mortgage and first fixed equitable charge over plots of land at challenge way, martland park, wigan, lancashire WN5 0LD;floating charge over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 juin 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • 22 nov. 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (MG05s)
    Bond & floating charge
    Créé le 03 juin 2009
    Livré le 16 juin 2009
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever all sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 juin 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 juin 2009
    • 22 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • 22 nov. 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (MG05s)
    Account charge
    Créé le 17 déc. 2008
    Livré le 31 déc. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The chargors right, title and interest in and to the charged asset (the deposit & account).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 déc. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    • 22 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Bond & floating charge
    Créé le 06 oct. 2008
    Livré le 14 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Kaupthing Singer & Friedlander Limited
    Transactions
    • 14 oct. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 oct. 2008Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 04 août 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 06 oct. 2008
    Livré le 10 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 oct. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 oct. 2008Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 16 oct. 2008Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 déc. 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (MG05s)
    • 22 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 06 oct. 2008
    Livré le 10 oct. 2008
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 oct. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 oct. 2008Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 22 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • 22 nov. 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (MG05s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Guarantee & debenture
    Créé le 26 sept. 2008
    Livré le 02 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 oct. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 oct. 2008Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 déc. 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (MG05s)
    • 22 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Guarantee and debenture
    Créé le 26 sept. 2008
    Livré le 29 sept. 2008
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Guarantee and debenture including legal mortgage and fixed charge all land, fixed charges and floating charge over all assets not effectively charged by the guarantee and debenture - see form 410 paper apart for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 sept. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 sept. 2008
    • 03 oct. 2008Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 oct. 2008Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 22 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • 22 nov. 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (MG05s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 29 janv. 1996
    Livré le 02 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Olympic business park,drybridge road,dundonald.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 févr. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 26 nov. 1995
    Livré le 29 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 nov. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 23 mars 1989
    Livré le 12 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Warehouse and office premises situated east or south east side of david orr street, kilmarnock.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    Bond & floating charge
    Créé le 07 oct. 1988
    Livré le 17 oct. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 oct. 1988Enregistrement d'une charge
    • 29 nov. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    BLANE LEISURE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 avr. 2009Date of meeting to approve CVA
    29 avr. 2009Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Notesscottish-insolvency-info
    2
    DateType
    27 avr. 2009Date of meeting to approve CVA
    16 juin 2010Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Notesscottish-insolvency-info
    3
    DateType
    22 mars 2011Date of meeting to approve CVA
    16 oct. 2012Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    practitioner
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Notesscottish-insolvency-info
    4
    DateType
    01 oct. 2012Administration started
    25 sept. 2015Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    practitioner
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Blair Carnegie Nimmo
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    practitioner
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    David James Costley-Wood
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester
    practitioner
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0