LYCIDAS SECRETARIES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | LYCIDAS SECRETARIES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC110030 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LYCIDAS SECRETARIES LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1 George Square G2 1AL Glasgow Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LYCIDAS SECRETARIES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour LYCIDAS SECRETARIES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Frank Raine Johnstone en tant que directeur le 31 août 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Roderick Alexander Louden Harrison en tant qu'administrateur le 30 juil. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Rona Nicolson Hutchison en tant que directeur le 26 janv. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Frank Raine Johnstone en tant qu'administrateur le 26 janv. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Maclay Murray & Spens Llp en tant que secrétaire le 27 oct. 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Dentons Secretaries Limited en tant que secrétaire le 27 oct. 2017 | 2 pages | AP04 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 oct. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Stevenson Biggart en tant que directeur le 27 oct. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lorna Margaret Mccaa en tant que directeur le 01 oct. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires | 9 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher John William Stenning en tant que directeur le 07 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Thomas Wilson Aitken en tant que directeur le 07 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 292 st. Vincent Street Glasgow G2 5TQ à 1 George Square Glasgow Scotland G2 1AL le 15 oct. 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de James William Rattray Mackie en tant que directeur le 07 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Rona Nicolson Hutchison en tant qu'administrateur le 07 sept. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Lorna Margaret Mccaa en tant qu'administrateur le 07 sept. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Alexis Irene Graham en tant qu'administrateur le 07 sept. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de LYCIDAS SECRETARIES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENTONS SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | EC4M 7WS London One Fleet Place United Kingdom |
| 98515470015 | ||||||||||||||
| BLYTH, Douglas John | Administrateur | Thriplee Road PA11 3HH Bridge Of Weir 15 Renfrewshire United Kingdom | Scotland | British | 152406590001 | |||||||||||||
| GRAHAM, Alexis Irene | Administrateur | George Square G2 1AL Glasgow 1 United Kingdom | Scotland | British | 192109610001 | |||||||||||||
| HARRISON, Roderick Alexander Louden | Administrateur | George Square G2 1AL Glasgow 1 Scotland | Scotland | British | 85789520002 | |||||||||||||
| KERR, Eleanor Mary | Administrateur | 25 Raceource Road KA7 2TE Ayr Sleaford House Ayrshire United Kingdom | Scotland | British | 42230490003 | |||||||||||||
| MAILLIE, John Parker | Secrétaire | 292 St Vincent Street G2 5TQ Glasgow Lanarkshire | British | 737470001 | ||||||||||||||
| LYCIDAS NOMINEES LIMITED | Secrétaire désigné | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 Scotland |
| 900003280001 | ||||||||||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Secrétaire | George Square G2 1AL Glasgow 1 United Kingdom |
| 201851590001 | ||||||||||||||
| ADAMS, Mark Edward | Administrateur | c/o Mcclure Naismith Llp 47 King William Street EC4R 9AF London Equitable House United Kingdom | United Kingdom | British | 162057040001 | |||||||||||||
| AITKEN, Thomas Wilson | Administrateur | George Square G2 1AL Glasgow 1 Scotland Scotland | Scotland | British | 981670003 | |||||||||||||
| BARR, Alan Lamont | Administrateur | 292 St. Vincent Street Glasgow G2 5TQ | Scotland | British | 146620460001 | |||||||||||||
| BELL, Patrick Ian | Administrateur | 2 Clark Road EH5 3BD Edinburgh | United Kingdom | British | 107403300001 | |||||||||||||
| BIGGART, Andrew Stevenson | Administrateur | Lochwinnoch Road PA13 4DZ Kilmacolm Kinnoul Renfrewshire United Kingdom | Scotland | British | 251423620001 | |||||||||||||
| BLACKWOOD, John Grahame | Administrateur | c/o Mcclure Naismith Llp Ponton Street EH3 9QQ Edinburgh 3 Scotland | Scotland | British | 69144850003 | |||||||||||||
| BROWN, Steven | Administrateur | c/o Mcclure Naismith Llp Ponton Street EH3 9QQ Edinburgh 3 Scotland | Scotland | British | 179662800001 | |||||||||||||
| BURROW, Alistair Stewart | Administrateur | Kintail 27 North Erskine Park Bearsden G61 4LY Glasgow | Scotland | British | 1238860006 | |||||||||||||
| CAMPBELL, Morag | Administrateur | 292 St. Vincent Street Glasgow G2 5TQ | Scotland | British | 35738480001 | |||||||||||||
| CAMPBELL, Peter Colin | Administrateur | 16 Campbell Road EH12 6DT Edinburgh Midlothian | British | 1089790001 | ||||||||||||||
| CHRYSTIE, Kenneth George, Dr | Administrateur | 2 Redlands Road G12 0SJ Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 70280001 | |||||||||||||
| COWIE, Mark Fraser Alexander | Administrateur | c/o Mcclure Naismith Llp Ponton Street EH3 9QQ Edinburgh 3 Scotland | Scotland | British | 69778180007 | |||||||||||||
| CROFT, Alistair Charles | Administrateur | c/o Mcclure Naismith Llp 47 King William Street EC4R 9AF London Equitable House England | United Kingdom | British | 189111470002 | |||||||||||||
| CZARNOCKI, Virginia Margaret Greer | Administrateur | 2 James View ML1 4HN Motherwell Lanarkshire | British | 96032390003 | ||||||||||||||
| DOCHERTY, Caroline | Administrateur | 21 Beechmount Park EH12 5YT Edinburgh Midlothian | British | 1089410005 | ||||||||||||||
| DOUGAN, Mairi-Claire | Administrateur | 15 Cramond Place Dalgety Bay KY11 9LS Dunfermline Fife | Scotland | British | 112513060001 | |||||||||||||
| DUNCAN, Euan Findlay | Administrateur | 292 St. Vincent Street Glasgow G2 5TQ | Scotland | British | 81706140001 | |||||||||||||
| FIELDHOUSE, Jeremy | Administrateur | 193 Hermitage Waterside Thomas Moore Street E1W 1YD London | British | 72875090001 | ||||||||||||||
| FRIER, George William | Administrateur | 16 Tavistock Drive G43 2SJ Glasgow | Scotland | British | 38802850002 | |||||||||||||
| GHOSH, Ashok | Administrateur | c/o Mcclure Naismith Llp 47 King William Street EC4R 9AF London Equitable House England | United Kingdom | British | 108619110001 | |||||||||||||
| GILKS, Geoffrey Paul | Administrateur | 6 Old Palace Terrace The Green TW9 1NB Richmond Surrey | British | 69757860001 | ||||||||||||||
| GOURLAY, David Mcrae | Administrateur | c/o Mcclure Naismith Llp Ponton Street EH3 9QQ Edinburgh 3 Scotland | Scotland | British | 108622840001 | |||||||||||||
| HOGG, Derek William | Administrateur | 112 Moira Terrace EH7 6TG Edinburgh | Scotland | British | 47129220003 | |||||||||||||
| HUTCHESON, Jeffrey Andrew | Administrateur | Roselea 34 Woodland Grove EH15 3PP Duddingston Edinburgh | Scotland | British | 37590090001 | |||||||||||||
| HUTCHISON, Rona Nicolson | Administrateur | George Square G2 1AL Glasgow 1 United Kingdom | Scotland | British | 199240740001 | |||||||||||||
| JOHNSTONE, Frank Raine | Administrateur | George Square G2 1AL Glasgow 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 70370002 | |||||||||||||
| KERR, Scott Thomas Reid | Administrateur | c/o Mcclure Naismith Llp Ponton Street EH3 9QQ Edinburgh 3 Scotland | United Kingdom | British | 53132710001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LYCIDAS SECRETARIES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maclay Murray & Spens Llp | 06 avr. 2016 | George Square G2 1AL Glasgow 1 Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0