LYCIDAS SECRETARIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLYCIDAS SECRETARIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC110030
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LYCIDAS SECRETARIES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe LYCIDAS SECRETARIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 George Square
    G2 1AL Glasgow
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LYCIDAS SECRETARIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LYCIDAS (139) LIMITED23 mars 198823 mars 1988

    Quels sont les derniers comptes de LYCIDAS SECRETARIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour LYCIDAS SECRETARIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Frank Raine Johnstone en tant que directeur le 31 août 2019

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Roderick Alexander Louden Harrison en tant qu'administrateur le 30 juil. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Rona Nicolson Hutchison en tant que directeur le 26 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Frank Raine Johnstone en tant qu'administrateur le 26 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Maclay Murray & Spens Llp en tant que secrétaire le 27 oct. 2017

    1 pagesTM02

    Nomination de Dentons Secretaries Limited en tant que secrétaire le 27 oct. 2017

    2 pagesAP04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 27 oct. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Andrew Stevenson Biggart en tant que directeur le 27 oct. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 oct. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Lorna Margaret Mccaa en tant que directeur le 01 oct. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 déc. 2015

    État du capital au 16 déc. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cessation de la nomination de Christopher John William Stenning en tant que directeur le 07 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Thomas Wilson Aitken en tant que directeur le 07 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 292 st. Vincent Street Glasgow G2 5TQ à 1 George Square Glasgow Scotland G2 1AL le 15 oct. 2015

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de James William Rattray Mackie en tant que directeur le 07 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Rona Nicolson Hutchison en tant qu'administrateur le 07 sept. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Lorna Margaret Mccaa en tant qu'administrateur le 07 sept. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Alexis Irene Graham en tant qu'administrateur le 07 sept. 2015

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de LYCIDAS SECRETARIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DENTONS SECRETARIES LIMITED
    EC4M 7WS London
    One Fleet Place
    United Kingdom
    Secrétaire
    EC4M 7WS London
    One Fleet Place
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement03929157
    98515470015
    BLYTH, Douglas John
    Thriplee Road
    PA11 3HH Bridge Of Weir
    15
    Renfrewshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Thriplee Road
    PA11 3HH Bridge Of Weir
    15
    Renfrewshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish152406590001
    GRAHAM, Alexis Irene
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    United Kingdom
    ScotlandBritish192109610001
    HARRISON, Roderick Alexander Louden
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    Administrateur
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    ScotlandBritish85789520002
    KERR, Eleanor Mary
    25 Raceource Road
    KA7 2TE Ayr
    Sleaford House
    Ayrshire
    United Kingdom
    Administrateur
    25 Raceource Road
    KA7 2TE Ayr
    Sleaford House
    Ayrshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish42230490003
    MAILLIE, John Parker
    292 St Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    292 St Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    Lanarkshire
    British737470001
    LYCIDAS NOMINEES LIMITED
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    Scotland
    Secrétaire désigné
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    Scotland
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC110029
    900003280001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    United Kingdom
    Secrétaire
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    United Kingdom
    Forme juridiqueLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Type d'identificationHors EEE
    Autorité légaleLIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS ACT 2000
    Numéro d'enregistrementSO300744
    201851590001
    ADAMS, Mark Edward
    c/o Mcclure Naismith Llp
    47 King William Street
    EC4R 9AF London
    Equitable House
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Mcclure Naismith Llp
    47 King William Street
    EC4R 9AF London
    Equitable House
    United Kingdom
    United KingdomBritish162057040001
    AITKEN, Thomas Wilson
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    Scotland
    ScotlandBritish981670003
    BARR, Alan Lamont
    292 St. Vincent Street
    Glasgow
    G2 5TQ
    Administrateur
    292 St. Vincent Street
    Glasgow
    G2 5TQ
    ScotlandBritish146620460001
    BELL, Patrick Ian
    2 Clark Road
    EH5 3BD Edinburgh
    Administrateur
    2 Clark Road
    EH5 3BD Edinburgh
    United KingdomBritish107403300001
    BIGGART, Andrew Stevenson
    Lochwinnoch Road
    PA13 4DZ Kilmacolm
    Kinnoul
    Renfrewshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Lochwinnoch Road
    PA13 4DZ Kilmacolm
    Kinnoul
    Renfrewshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish251423620001
    BLACKWOOD, John Grahame
    c/o Mcclure Naismith Llp
    Ponton Street
    EH3 9QQ Edinburgh
    3
    Scotland
    Administrateur
    c/o Mcclure Naismith Llp
    Ponton Street
    EH3 9QQ Edinburgh
    3
    Scotland
    ScotlandBritish69144850003
    BROWN, Steven
    c/o Mcclure Naismith Llp
    Ponton Street
    EH3 9QQ Edinburgh
    3
    Scotland
    Administrateur
    c/o Mcclure Naismith Llp
    Ponton Street
    EH3 9QQ Edinburgh
    3
    Scotland
    ScotlandBritish179662800001
    BURROW, Alistair Stewart
    Kintail 27 North Erskine Park
    Bearsden
    G61 4LY Glasgow
    Administrateur
    Kintail 27 North Erskine Park
    Bearsden
    G61 4LY Glasgow
    ScotlandBritish1238860006
    CAMPBELL, Morag
    292 St. Vincent Street
    Glasgow
    G2 5TQ
    Administrateur
    292 St. Vincent Street
    Glasgow
    G2 5TQ
    ScotlandBritish35738480001
    CAMPBELL, Peter Colin
    16 Campbell Road
    EH12 6DT Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    16 Campbell Road
    EH12 6DT Edinburgh
    Midlothian
    British1089790001
    CHRYSTIE, Kenneth George, Dr
    2 Redlands Road
    G12 0SJ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    2 Redlands Road
    G12 0SJ Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish70280001
    COWIE, Mark Fraser Alexander
    c/o Mcclure Naismith Llp
    Ponton Street
    EH3 9QQ Edinburgh
    3
    Scotland
    Administrateur
    c/o Mcclure Naismith Llp
    Ponton Street
    EH3 9QQ Edinburgh
    3
    Scotland
    ScotlandBritish69778180007
    CROFT, Alistair Charles
    c/o Mcclure Naismith Llp
    47 King William Street
    EC4R 9AF London
    Equitable House
    England
    Administrateur
    c/o Mcclure Naismith Llp
    47 King William Street
    EC4R 9AF London
    Equitable House
    England
    United KingdomBritish189111470002
    CZARNOCKI, Virginia Margaret Greer
    2 James View
    ML1 4HN Motherwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    2 James View
    ML1 4HN Motherwell
    Lanarkshire
    British96032390003
    DOCHERTY, Caroline
    21 Beechmount Park
    EH12 5YT Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    21 Beechmount Park
    EH12 5YT Edinburgh
    Midlothian
    British1089410005
    DOUGAN, Mairi-Claire
    15 Cramond Place
    Dalgety Bay
    KY11 9LS Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    15 Cramond Place
    Dalgety Bay
    KY11 9LS Dunfermline
    Fife
    ScotlandBritish112513060001
    DUNCAN, Euan Findlay
    292 St. Vincent Street
    Glasgow
    G2 5TQ
    Administrateur
    292 St. Vincent Street
    Glasgow
    G2 5TQ
    ScotlandBritish81706140001
    FIELDHOUSE, Jeremy
    193 Hermitage Waterside
    Thomas Moore Street
    E1W 1YD London
    Administrateur
    193 Hermitage Waterside
    Thomas Moore Street
    E1W 1YD London
    British72875090001
    FRIER, George William
    16 Tavistock Drive
    G43 2SJ Glasgow
    Administrateur
    16 Tavistock Drive
    G43 2SJ Glasgow
    ScotlandBritish38802850002
    GHOSH, Ashok
    c/o Mcclure Naismith Llp
    47 King William Street
    EC4R 9AF London
    Equitable House
    England
    Administrateur
    c/o Mcclure Naismith Llp
    47 King William Street
    EC4R 9AF London
    Equitable House
    England
    United KingdomBritish108619110001
    GILKS, Geoffrey Paul
    6 Old Palace Terrace
    The Green
    TW9 1NB Richmond
    Surrey
    Administrateur
    6 Old Palace Terrace
    The Green
    TW9 1NB Richmond
    Surrey
    British69757860001
    GOURLAY, David Mcrae
    c/o Mcclure Naismith Llp
    Ponton Street
    EH3 9QQ Edinburgh
    3
    Scotland
    Administrateur
    c/o Mcclure Naismith Llp
    Ponton Street
    EH3 9QQ Edinburgh
    3
    Scotland
    ScotlandBritish108622840001
    HOGG, Derek William
    112 Moira Terrace
    EH7 6TG Edinburgh
    Administrateur
    112 Moira Terrace
    EH7 6TG Edinburgh
    ScotlandBritish47129220003
    HUTCHESON, Jeffrey Andrew
    Roselea
    34 Woodland Grove
    EH15 3PP Duddingston
    Edinburgh
    Administrateur
    Roselea
    34 Woodland Grove
    EH15 3PP Duddingston
    Edinburgh
    ScotlandBritish37590090001
    HUTCHISON, Rona Nicolson
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    United Kingdom
    ScotlandBritish199240740001
    JOHNSTONE, Frank Raine
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish70370002
    KERR, Scott Thomas Reid
    c/o Mcclure Naismith Llp
    Ponton Street
    EH3 9QQ Edinburgh
    3
    Scotland
    Administrateur
    c/o Mcclure Naismith Llp
    Ponton Street
    EH3 9QQ Edinburgh
    3
    Scotland
    United KingdomBritish53132710001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LYCIDAS SECRETARIES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Maclay Murray & Spens Llp
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    06 avr. 2016
    George Square
    G2 1AL Glasgow
    1
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueLimited Liability Partnership
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleLimited Liability Partnerships Act 2000
    Lieu d'enregistrementUk Register Of Companies
    Numéro d'enregistrementSo300744
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0