SCOTT, REUTER LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SCOTT, REUTER LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC111482 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SCOTT, REUTER LIMITED ?
| Adresse du siège social | c/o AFS (SCOTLAND) LIMITED Unit 20 15, Borrowmeadow Road Springkerse Industrial Estate FK7 7UW Stirling |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SCOTT, REUTER LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SCOTT, REUTER LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation | |
|---|---|
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 07 oct. 2024 |
Quels sont les derniers dépôts pour SCOTT, REUTER LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 6 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2024 | 8 pages | AA | ||
Notification de Lhanbryde Services Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 févr. 2024 | 2 pages | PSC02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 07 oct. 2024 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Période comptable précédente prolongée du 31 mars 2024 au 30 sept. 2024 | 1 pages | AA01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 août 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 août 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2023 | 8 pages | AA | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2022 | 9 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 août 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2021 | 9 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 août 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2020 | 8 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 août 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2019 | 8 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 août 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2018 | 8 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 août 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2017 | 8 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 août 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2016 | 7 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de SCOTT, REUTER LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVERY, Stephen John | Secrétaire | 32c Kenilworth Road FK9 4EH Bridge Of Allan Stirling | British | 73550410001 | ||||||
| AVERY, Stephen John | Administrateur | 32c Kenilworth Road FK9 4EH Bridge Of Allan Stirling | United Kingdom | British | 73550410001 | |||||
| BRUNDLE, Margaret | Secrétaire | 15 Rothbury Avenue Monkton Village NE32 5NU Jarrow Tyne & Wear | British | 783210001 | ||||||
| EVANS, William Wilson | Secrétaire | 133 South Street PA16 8TD Greenock Renfrewshire | British | 414930001 | ||||||
| HUGHES, Gerald John | Secrétaire | Ware House Ware Road EH39 4BN North Berwick East Lothian | British | 114922340001 | ||||||
| HYND, Russell John | Secrétaire | 56 Priorwood Road Cleveland Park Newton Mearns G77 6ZZ Glasgow Lanarkshire | British | 62990090002 | ||||||
| HBJGW SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire | Exchange Tower 19 Canning Street EH3 8EH Edinburgh Midlothian | 665080003 | |||||||
| ADAMS, Janess | Administrateur | 25 Clarendon Crescent EH49 6AW Linlithgow West Lothian | United Kingdom | British | 35011780001 | |||||
| BROOSHOOFT, Frederick Michael Desmond | Administrateur | Wycliffe House Snow Hill LE13 1PD Melton Mowbray Leicestershire | British | 27881830001 | ||||||
| CLARK, Thomas Andrew | Administrateur | Clifton Kilbarchan Road PA11 3EG Bridge Of Weir | British | 27503050001 | ||||||
| EVANS, William Wilson | Administrateur | 133 South Street PA16 8TD Greenock Renfrewshire | Scotland | British | 414930001 | |||||
| HUGHES, Gerald John | Administrateur | Ware House Ware Road EH39 4BN North Berwick East Lothian | United Kingdom | British | 114922340001 | |||||
| HUGHES, Gerald John | Administrateur | Ware House Ware Road EH39 4BN North Berwick East Lothian | United Kingdom | British | 114922340001 | |||||
| HYND, Russell John | Administrateur | 56 Priorwood Road Cleveland Park Newton Mearns G77 6ZZ Glasgow Lanarkshire | British | 62990090002 | ||||||
| KEENAN, James | Administrateur | 22 Tennant Street Leith EH6 5ND Edinburgh Midlothian | British | 18387170001 | ||||||
| KIRKPATRICK, Ian | Administrateur | 35 Chester Road IG7 6AH Chigwell Essex | United Kingdom | British | 31693560001 | |||||
| LAWRENCE, Ian Roy | Administrateur | C/O Grangemouth Ship Repair Carron Dock FK3 8JH Grangemouth | United Kingdom | British | 81666850003 | |||||
| LAWRENCE, Ian Roy | Administrateur | Holly Farm Chapel Lane WA8 4NX Cronton Widnes | United Kingdom | British | 81666850003 | |||||
| LUNDY, Robert | Administrateur | Langdene Moredun Road PA2 9LH Paisley Renfrewshire | Scotland | British | 841310001 | |||||
| MACKINTOSH, Graeme | Administrateur | Main Street Townhill KY12 0ED Dunfermline 8 Fife | British | 88495630001 | ||||||
| MCKAY, David Alexander | Administrateur | 34 Warriston Drive EH3 5LY Edinburgh | British | 97630660001 | ||||||
| ROLASTON, Carl Geoffrey | Administrateur | 36 Kinellan Road EH12 6ES Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 65165500001 | |||||
| SEWELL, Robert William Reuter | Administrateur | 44 Connaught Place EH6 4RN Edinburgh Midlothian | British | 783220001 | ||||||
| SMITH, Michael Andrew | Administrateur | Flat 1r, 198 Wilton Street G20 6BL Glasgow | British | 65926290002 | ||||||
| SOFTLEY, John | Administrateur | 92 Fauldburn East Craigs EH12 8YJ Edinburgh Midlothian | British | 783230001 | ||||||
| WALKER, George Philip | Administrateur | 61 Hawthorn Avenue Bearsden G61 3NF Glasgow Lanarkshire | British | 982400001 | ||||||
| WILLIAMSON, James Wright | Administrateur | 32 Parsons Green Terrace EH8 7AF Edinburgh Midlothian | British | 783240001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SCOTT, REUTER LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lhanbryde Services Ltd | 01 févr. 2024 | Kenilworth Road Bridge Of Allan FK9 4EH Stirling 32c Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr Stephen John Avery | 08 août 2016 | Kenilworth Road Bridge Of Allan FK9 4EH Stirling 32c Scotland | Non | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0