STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED

STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC111734
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED ?

    • Hôtels et hébergement similaire (55100) / Hébergement et restauration

    Où se situe STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    1 George Square
    G2 1AL Glasgow
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ORRMAC (NO:63) LIMITED20 juin 198820 juin 1988

    Quels sont les derniers comptes de STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de passage de l'administration à la dissolution

    38 pages2.26B(Scot)

    Proposition révisée de l'administrateur

    2 pages2.17B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    31 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    29 pages2.20B(Scot)

    Démission d'un administrateur

    1 pages2.29B(Scot)

    Démission d'un administrateur

    1 pages2.29B(Scot)

    Proposition réputée de l'administrateur

    1 pages2.16BZ(Scot)

    État des affaires avec formulaire 2.13B(Scot)

    16 pages2.15B(Scot)

    Proposition de l'administrateur

    147 pages2.16B(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de C/O C/O Maclay Murray & Spens Llp 1 George Square Glasgow G2 1AL Scotland à C/O Maclay Murray & Spens Llp 1 George Square Glasgow G2 1AL le 26 sept. 2014

    1 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pages2.11B(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA à C/O Maclay Murray & Spens Llp 1 George Square Glasgow G2 1AL le 15 sept. 2014

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Michael Edward Jourdain en tant que directeur le 01 août 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Peter Procopis en tant que directeur le 01 août 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Declan Mckelvey en tant qu'administrateur le 01 août 2014

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 avr. 2014

    État du capital au 28 avr. 2014

    • Capital: GBP 500,000
    SH01

    Cessation de la nomination de David Kaye en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Kaye en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    19 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    legacy

    19 pagesMG01s

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    16 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCKELVEY, Declan
    Melrose Court
    Lincoln Road
    SK9 2HD Wilmslow
    1
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Melrose Court
    Lincoln Road
    SK9 2HD Wilmslow
    1
    Cheshire
    England
    EnglandIrishChartered Accountant172282530001
    CAMERON, William Alasdair
    115 Bentinck Drive
    KA10 6JB Troon
    Ayrshire
    Secrétaire
    115 Bentinck Drive
    KA10 6JB Troon
    Ayrshire
    BritishCa1244320001
    GOULDING, Ian Don
    44 Daisy Lea Lane
    Lindley
    HD3 3LP Huddersfield
    Secrétaire
    44 Daisy Lea Lane
    Lindley
    HD3 3LP Huddersfield
    BritishChartered Accountant39828490004
    HENDERSON, William Shields
    23 Dundas Street
    EH3 6QQ Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    23 Dundas Street
    EH3 6QQ Edinburgh
    Midlothian
    British893760001
    KAYE, David Robert
    6 Copthall Gardens
    Mill Hill
    NW7 2NG London
    Secrétaire
    6 Copthall Gardens
    Mill Hill
    NW7 2NG London
    British110817160002
    LANGRIDGE, Megan Joy
    42 Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    Kent
    Secrétaire
    42 Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    Kent
    British86459820005
    ORR MACQUEEN W S
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Secrétaire
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    39211930001
    ANDERSON, Alan William
    24 Hillside Terrace
    Edinburgh
    Administrateur
    24 Hillside Terrace
    Edinburgh
    BritishSolicitor740310001
    BRYNES, Peter
    19 Viking Crescent
    Houston
    PA6 7LQ Johnstone
    Renfrewshire
    Administrateur
    19 Viking Crescent
    Houston
    PA6 7LQ Johnstone
    Renfrewshire
    BritishCivil Engineer71545500001
    CAMERON, William Alasdair
    115 Bentinck Drive
    KA10 6JB Troon
    Ayrshire
    Administrateur
    115 Bentinck Drive
    KA10 6JB Troon
    Ayrshire
    BritishCa1244320001
    CAMPBELL, Colin John
    25 Wycombe End
    HP9 1LZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    25 Wycombe End
    HP9 1LZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishDirector99161140001
    GALGANI, Franco
    13 Keppel Road
    EH39 4QF North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    13 Keppel Road
    EH39 4QF North Berwick
    East Lothian
    BritishHotelier43293400002
    GOULDING, Ian Don
    44 Daisy Lea Lane
    Lindley
    HD3 3LP Huddersfield
    Administrateur
    44 Daisy Lea Lane
    Lindley
    HD3 3LP Huddersfield
    United KingdomBritishChartered Accountant39828490004
    HENDERSON, William Shields
    Park House 13 Greenhill Park
    EH10 4DW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Park House 13 Greenhill Park
    EH10 4DW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishFinancial Advisor55090001
    JOURDAIN, Michael Edward
    The Sticks
    Hatchgate Lane
    RH17 5DU Cuckfield
    Sussex
    Administrateur
    The Sticks
    Hatchgate Lane
    RH17 5DU Cuckfield
    Sussex
    EnglandBritishDirector58412670001
    KAYE, David Robert
    14 Clifford Street
    W1S 4JU London
    Bond Street House
    England
    Administrateur
    14 Clifford Street
    W1S 4JU London
    Bond Street House
    England
    United KingdomBritishDirector110817160002
    MARCOVECCHIO, Massimo Mario
    27 Manor Wood Road
    CR8 4LG Purley
    Surrey
    Administrateur
    27 Manor Wood Road
    CR8 4LG Purley
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Surveyor75936930001
    MURRAY, Rodger Grant
    24 Moston Terrace
    Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Moston Terrace
    Edinburgh
    British900000170001
    PAISNER, Jonathan Samuel
    Bond Street House
    14 Clifford Street
    W1S 4JU London
    Administrateur
    Bond Street House
    14 Clifford Street
    W1S 4JU London
    United KingdomBritishSolicitor78399950005
    PROCOPIS, Peter
    7a Lauderdale Road
    W9 1LT London
    Administrateur
    7a Lauderdale Road
    W9 1LT London
    United KingdomAustralianFinance Director66047970002
    PURTILL, Michael Edward
    Froghall
    Barmby Moor
    YO42 4DA Pocklington
    East Yorkshire
    Administrateur
    Froghall
    Barmby Moor
    YO42 4DA Pocklington
    East Yorkshire
    EnglandIrishChartered Accountant7856280001
    ROGERS, Paul
    Ash Barton
    20 The Ridgeway
    WD7 8PR Radlett
    Hertfordshire
    Administrateur
    Ash Barton
    20 The Ridgeway
    WD7 8PR Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor41216370001
    SIMMERS, Brian Maxwell
    Remuera
    Kirkhouse Road, Killearn
    G63 9NB Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    Remuera
    Kirkhouse Road, Killearn
    G63 9NB Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritishChartered Accountant1064940001
    SIMMERS, Graeme Maxwell
    Kincaple
    Balfron
    G63 ORW Glasgow
    Administrateur
    Kincaple
    Balfron
    G63 ORW Glasgow
    ScotlandBritishCa1064950001
    SMITH, Paul Murray
    Woodlands 3 The Lade
    EH14 7LB Balerno
    Midlothian
    Administrateur
    Woodlands 3 The Lade
    EH14 7LB Balerno
    Midlothian
    BritishDirector1064970001
    WATSON, David James
    18 Saville Row
    London
    Administrateur
    18 Saville Row
    London
    BritishCompany Director1123110001

    STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 03 avr. 2012
    Livré le 05 avr. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Irish Bank Resolution Corporation Limited
    Transactions
    • 05 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Assignation of rents
    Créé le 24 juil. 2009
    Livré le 28 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Right, title and interest in and to the rental income over stirling highland hotel, stirling.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 28 juil. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    Deed of confirmation
    Créé le 07 juil. 2009
    Livré le 21 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Variation of previously registered floating charge, assignation of rents and standard securities-see form for further details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 21 juil. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    Assignation of rents
    Créé le 20 sept. 2007
    Livré le 11 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Present and future right, title and interest in and to the rental income over the stirling highland hotel, spittal street, stirling.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporatiin PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 22 juil. 2004
    Livré le 29 juil. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under the transaction documents
    Brèves mentions
    The tenant's interest in the lease in respect of the subjects comprising 1.88 acres of ground and known as and forming the stirling highland hotel, spittal street, stirling.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 29 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 12 juil. 2004
    Livré le 16 juil. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Security Trustee for Itself and Others
    Transactions
    • 16 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 12 avr. 2002
    Livré le 23 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The stirling highland hotel, spittal street, stirling.
    Personnes ayant droit
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transactions
    • 23 avr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 04 avr. 2002
    Livré le 12 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transactions
    • 12 avr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 21 juil. 2000
    Livré le 04 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Stirling highland hotel, spittal street, stirling.
    Personnes ayant droit
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transactions
    • 04 août 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 13 juil. 2000
    Livré le 27 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transactions
    • 27 juil. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 14 janv. 2000
    Livré le 03 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The stirling highland hotel, stirling.
    Personnes ayant droit
    • De Nationale Investeringsbank N.V.
    Transactions
    • 03 févr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 23 déc. 1999
    Livré le 13 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • De Nationale Investeringsbank N.V
    Transactions
    • 13 janv. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 04 mai 1990
    Livré le 11 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £400,000 and all sums due or to become due
    Brèves mentions
    Lease out property between central doc. Council and company dated 20/4/90.
    Personnes ayant droit
    • Scottish Development Agency
    Transactions
    • 11 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 03 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 04 mai 1990
    Livré le 11 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Lease over 1.88 acres at old high school stirling.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 08 févr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Instrument of charge
    Créé le 20 avr. 1990
    Livré le 03 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £400,000 together with all further sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Scottish Development Agency
    Transactions
    • 03 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 11 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 20 avr. 1990
    Livré le 30 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 03 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    STIRLING HIGHLAND HOTEL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    11 sept. 2014Administration started
    10 sept. 2015Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Paul David Williams
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    practitioner
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    David John Whitehouse
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    practitioner
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Paul John Clark
    The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    practitioner
    The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0