AAL REALISATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAAL REALISATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC112087
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AAL REALISATIONS LIMITED ?

    • Autres industries manufacturières n.d.a. (32990) / Industries manufacturières

    Où se situe AAL REALISATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kpmg Llp
    319 St. Vincent Street
    G2 5AS Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AAL REALISATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ARRAN AROMATICS LIMITED04 juil. 198804 juil. 1988

    Quels sont les derniers comptes de AAL REALISATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour AAL REALISATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans CVL

    20 pagesLIQ14(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    27 pages2.20B(Scot)

    Avis de passage de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.25B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    26 pages2.20B(Scot)

    legacy

    1 pages2.18B(Scot)

    État des affaires avec formulaire 2.13B(Scot)/2.14B(Scot)

    110 pages2.15B(Scot)

    Proposition de l'administrateur

    49 pages2.16B(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de Home Farm Brodick Isle of Arran KA27 8DD à Kpmg Llp 319 st. Vincent Street Glasgow G2 5AS le 14 mars 2017

    2 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    1 pagesMR04

    Nomination d'un administrateur

    3 pages2.11B(Scot)

    Certificat de changement de nom

    Company name changed arran aromatics LIMITED\certificate issued on 06/03/17
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name06 mars 2017

    Avis de changement de nom"

    CONNOT

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 juil. 2016

    État du capital au 06 juil. 2016

    • Capital: GBP 737,681.999996
    SH01

    Cessation de la nomination de Philip John Pittman en tant que directeur le 31 mai 2016

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 28 févr. 2015

    8 pagesAA

    Cessation de la nomination de Alan Victor Wade en tant que directeur le 31 oct. 2015

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Jacqeeline Gale le 27 juil. 2015

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    12 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 juil. 2015

    État du capital au 21 juil. 2015

    • Capital: GBP 737,681.999996
    SH01

    Nomination de Miss Danielle Wilder en tant qu'administrateur le 01 juin 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Jacqeeline Gale en tant qu'administrateur le 01 juin 2015

    2 pagesAP01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 28 févr. 2014

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    12 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 juil. 2014

    État du capital au 24 juil. 2014

    • Capital: GBP 737,681.999996
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2013

    9 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de AAL REALISATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FERNIE, Gillian
    Brodick
    KA27 8DD Isle Of Arran
    Home Farm
    Scotland
    Secrétaire
    Brodick
    KA27 8DD Isle Of Arran
    Home Farm
    Scotland
    181136520001
    FERNIE, Gillian
    Brodick
    KA27 8DD Isle Of Arran
    Home Farm
    Scotland
    Administrateur
    Brodick
    KA27 8DD Isle Of Arran
    Home Farm
    Scotland
    ScotlandBritish180492930001
    GALE, Jacqueline Mary
    319 St. Vincent Street
    G2 5AS Glasgow
    Kpmg Llp
    Administrateur
    319 St. Vincent Street
    G2 5AS Glasgow
    Kpmg Llp
    ScotlandBritish195409440001
    RUSSELL, Andrew Stewart
    Brooklands Avenue
    G71 7AT Uddungston
    1
    South Lanarkshire
    Administrateur
    Brooklands Avenue
    G71 7AT Uddungston
    1
    South Lanarkshire
    ScotlandBritish55213050004
    WILDER, Danielle Gina
    319 St. Vincent Street
    G2 5AS Glasgow
    Kpmg Llp
    Administrateur
    319 St. Vincent Street
    G2 5AS Glasgow
    Kpmg Llp
    EnglandBritish199551900001
    MURRIE, Janet Linda
    Bewley, 10 Sheean Drive
    Glencoy
    KA27 8DH Brodick
    Isle Of Arran
    Secrétaire
    Bewley, 10 Sheean Drive
    Glencoy
    KA27 8DH Brodick
    Isle Of Arran
    British1298480002
    RENNICK, Alastair Stuart
    35 Alma Park
    KA27 8AF Brodick
    Isle Of Arran
    Secrétaire
    35 Alma Park
    KA27 8AF Brodick
    Isle Of Arran
    British53192980001
    WALKER, Robert Thomas Andrew
    Rozelle Drive
    Newton Mearns
    G77 6YU Glasgow
    4
    Secrétaire
    Rozelle Drive
    Newton Mearns
    G77 6YU Glasgow
    4
    British153863180001
    SHELF SECRETARY LIMITED
    Standard Building 4th Floor 94 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Renfrewshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Standard Building 4th Floor 94 Hope Street
    G2 6PH Glasgow
    Standard Building
    Renfrewshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC307444
    115954880001
    BROWN, Eric Gordon
    5 Kirkhill Road
    ML10 6HN Strathaven
    Lanarkshire
    Administrateur
    5 Kirkhill Road
    ML10 6HN Strathaven
    Lanarkshire
    ScotlandBritish34459550001
    MACDONALD, Morinne
    Flat 3/2 30 Highburgh Road
    Dowanhill
    G12 9DZ Glasgow
    Administrateur
    Flat 3/2 30 Highburgh Road
    Dowanhill
    G12 9DZ Glasgow
    ScotlandBritish93420180001
    MURRIE, Janet Linda
    Bewley, 10 Sheean Drive
    Glencoy
    KA27 8DH Brodick
    Isle Of Arran
    Administrateur
    Bewley, 10 Sheean Drive
    Glencoy
    KA27 8DH Brodick
    Isle Of Arran
    British1298480002
    OWENS, Anthony
    41 Beltonfoot Way
    ML2 0GA Wishaw
    North Lanarkshire
    Administrateur
    41 Beltonfoot Way
    ML2 0GA Wishaw
    North Lanarkshire
    ScotlandBritish86285020002
    PITTMAN, Philip John
    2 Craigievar Place
    West Acres, Newton Mearns
    G77 6YE Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    2 Craigievar Place
    West Acres, Newton Mearns
    G77 6YE Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish115658830001
    RENNICK, Alastair Stuart
    35 Alma Park
    KA27 8AF Brodick
    Isle Of Arran
    Administrateur
    35 Alma Park
    KA27 8AF Brodick
    Isle Of Arran
    British53192980001
    RUSSELL, Iain Alexander
    Thornhill
    Whiting Bay
    KA27 8RF Isle Of Arran
    Scotland
    Administrateur
    Thornhill
    Whiting Bay
    KA27 8RF Isle Of Arran
    Scotland
    British31550920001
    RUSSELL, Janet Wycherley
    KA27 8RQ Whiting Bay
    Cairnbaan
    Isle Of Arran
    Administrateur
    KA27 8RQ Whiting Bay
    Cairnbaan
    Isle Of Arran
    United KingdomBritish31550930004
    SUGDEN, Anthony
    127 Bolling Road
    LS29 8PN Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    127 Bolling Road
    LS29 8PN Ilkley
    West Yorkshire
    British43800400001
    TRUE, Michael Lodge
    Meadowbank Lodge
    Whiting Bay
    KA27 8QT Brodick
    Isle Of Arran
    Administrateur
    Meadowbank Lodge
    Whiting Bay
    KA27 8QT Brodick
    Isle Of Arran
    British69323090001
    TRUE, Susan Elizabeth
    Meadowbank Lodge
    Whiting Bay
    KA27 8QT Brodick
    Isle Of Arran
    Administrateur
    Meadowbank Lodge
    Whiting Bay
    KA27 8QT Brodick
    Isle Of Arran
    British71058630002
    WADE, Alan Victor
    Home Farm
    Brodick
    KA27 8DD Isle Of Arran
    Administrateur
    Home Farm
    Brodick
    KA27 8DD Isle Of Arran
    United KingdomBritish82168150003
    WALKER, Robert Thomas Andrew
    4 Rozelle Drive
    Westacres
    G77 6YU Newton Mearns
    East Renfrewshire
    Administrateur
    4 Rozelle Drive
    Westacres
    G77 6YU Newton Mearns
    East Renfrewshire
    United KingdomBritish99292690001

    AAL REALISATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 28 sept. 2010
    Livré le 07 oct. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 07 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 07 oct. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 06 juin 2001
    Livré le 14 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Island cheese factory, creelers restaurant and duchess court shops, home farm buildings, brodick, arran.
    Personnes ayant droit
    • Argyll and the Islands Enterprise Company
    Transactions
    • 14 juin 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 19 avr. 2001
    Livré le 30 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Island cheese factory, creelers restaurant & duchess court shops, home farm, brodick, arran.
    Personnes ayant droit
    • Argyll and the Islands Enterprise Company Limited
    Transactions
    • 30 avr. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 26 mars 2001
    Livré le 12 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Argyll and the Islands Enterprise Company
    Transactions
    • 12 avr. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 avr. 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 26 avr. 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 juin 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 26 avr. 1996
    Livré le 13 mai 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.35 hectares at home farm, brodick, isle of arran.
    Personnes ayant droit
    • Highlands and Islands Enterprise
    Transactions
    • 13 mai 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 19 avr. 1993
    Livré le 23 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.37 hectares at home farm buildings, brodick, isle of arran.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 avr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 23 mars 1990
    Livré le 03 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    37 decimal parts of hectare ground part of home farm buildings brodick.
    Personnes ayant droit
    • Highlands and Islands Development Board
    Transactions
    • 03 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 23 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 08 janv. 1990
    Livré le 19 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Highlands and Islands Development Board
    Transactions
    • 19 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 24 mai 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 26 mai 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 23 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Floating charge
    Créé le 30 août 1989
    Livré le 05 sept. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Highlands and Islands Development Board
    Transactions
    • 05 sept. 1989Enregistrement d'une charge
    • 15 juin 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 08 juil. 1989
    Livré le 20 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    • 12 juin 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 07 oct. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    AAL REALISATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 mars 2017Administration started
    27 févr. 2018Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Blair Carnegie Nimmo
    1 Marischal Square
    Broad Street
    AB10 1DD Aberdeen
    practitioner
    1 Marischal Square
    Broad Street
    AB10 1DD Aberdeen
    Gerard Anthony Friar
    319 St Vincent Street
    G2 5AS Glasgow
    practitioner
    319 St Vincent Street
    G2 5AS Glasgow
    2
    DateType
    27 févr. 2018Commencement of winding up
    20 nov. 2019Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Gerard Anthony Friar
    319 St Vincent Street
    G2 5AS Glasgow
    proposed liquidator
    319 St Vincent Street
    G2 5AS Glasgow
    Blair Carnegie Nimmo
    1 Marischal Square
    Broad Street
    AB10 1DD Aberdeen
    proposed liquidator
    1 Marischal Square
    Broad Street
    AB10 1DD Aberdeen
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0