REGENERSIS (GLASGOW) LIMITED

REGENERSIS (GLASGOW) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREGENERSIS (GLASGOW) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC112872
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REGENERSIS (GLASGOW) LIMITED ?

    • Autres activités de télécommunications (61900) / Information et communication
    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe REGENERSIS (GLASGOW) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 James Watt Avenue
    Westwood Park
    KY7 4UA Glenrothes
    Fife
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de REGENERSIS (GLASGOW) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TOTAL REPAIR SOLUTIONS LIMITED06 juil. 201106 juil. 2011
    REGENERSIS (GLASGOW) LIMITED19 févr. 201019 févr. 2010
    TOTAL REPAIR SOLUTIONS LIMITED18 avr. 200018 avr. 2000
    WESTWOOD COMMUNICATIONS LIMITED 22 août 198822 août 1988

    Quels sont les derniers comptes de REGENERSIS (GLASGOW) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour REGENERSIS (GLASGOW) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2018

    14 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 32 Fountain Drive Inchinnan Business Park Inchinnan Renfrewshire PA4 9RF à 1 James Watt Avenue Westwood Park Glenrothes Fife KY7 4UA le 25 févr. 2019

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2017

    15 pagesAA

    Nomination de Clc Secretarial Services Ltd en tant que secrétaire le 01 juil. 2018

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Lorraine Young Company Secretaries Limited en tant que secrétaire le 30 juin 2018

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Satisfaction de la charge SC1128720011 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1128720012 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2016

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Période comptable précédente prolongée du 30 juin 2016 au 31 déc. 2016

    1 pagesAA01

    Modification des coordonnées du secrétaire Lorraine Young Company Secretaries Limited le 22 déc. 2016

    1 pagesCH04

    Nomination de Mr Christopher Howe en tant qu'administrateur le 04 avr. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Gerald Joseph Parsons en tant qu'administrateur le 04 avr. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Leo David Parsons en tant qu'administrateur le 04 avr. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jog Dhody en tant que directeur le 04 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 30 juin 2015

    16 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de REGENERSIS (GLASGOW) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CLC SECRETARIAL SERVICES LTD
    Aldersgate Street
    EC1A 4HJ London
    10 Aldersgate Street
    England
    Secrétaire
    Aldersgate Street
    EC1A 4HJ London
    10 Aldersgate Street
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement03567116
    249037320001
    HOWE, Christopher
    James Watt Avenue
    Westwood Park
    KY7 4UA Glenrothes
    1
    Fife
    United Kingdom
    Administrateur
    James Watt Avenue
    Westwood Park
    KY7 4UA Glenrothes
    1
    Fife
    United Kingdom
    United StatesAmericanCfo207227000001
    PARSONS, Gerald Joseph
    James Watt Avenue
    Westwood Park
    KY7 4UA Glenrothes
    1
    Fife
    United Kingdom
    Administrateur
    James Watt Avenue
    Westwood Park
    KY7 4UA Glenrothes
    1
    Fife
    United Kingdom
    United StatesAmerican,Chairman & Ceo207226980001
    PARSONS, Leo David
    James Watt Avenue
    Westwood Park
    KY7 4UA Glenrothes
    1
    Fife
    United Kingdom
    Administrateur
    James Watt Avenue
    Westwood Park
    KY7 4UA Glenrothes
    1
    Fife
    United Kingdom
    United StatesAmericanPresident & Coo207226970001
    DICK, William Austin
    Broomfield Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JP Glasgow
    92
    Secrétaire
    Broomfield Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JP Glasgow
    92
    British134203250001
    EMANUEL, Richard John Metcalfe
    Le Formentor
    27 Avenue Princesse Grace
    Monaco
    98000
    Secrétaire
    Le Formentor
    27 Avenue Princesse Grace
    Monaco
    98000
    BritishCompany Director91766020001
    JOHNSTON, Philip James
    10 Mclaren Grove
    Kittoch Glen, East Kilbride
    G74 4SR Glasgow
    Secrétaire
    10 Mclaren Grove
    Kittoch Glen, East Kilbride
    G74 4SR Glasgow
    British90598180001
    SINCLAIR, Margaret
    37 Turnberry Drive
    Newton Mearns
    G77 5SE Glasgow
    Secrétaire
    37 Turnberry Drive
    Newton Mearns
    G77 5SE Glasgow
    British39627650002
    TANSINI, Sergio
    55 Gamekeepers Road
    EH4 6LR Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    55 Gamekeepers Road
    EH4 6LR Edinburgh
    Midlothian
    ItalianDirector106858140001
    TELFORD, Bruce
    Westwood,51 Broompark Drive
    Newton Mearns
    G77 5EH Renfrewshire
    Secrétaire
    Westwood,51 Broompark Drive
    Newton Mearns
    G77 5EH Renfrewshire
    BritishCompany Director1165580001
    TEMPLE, John Nicholas
    Windfalls Highfield Road
    West Moors
    BH22 0NA Ferndown
    Dorset
    Secrétaire
    Windfalls Highfield Road
    West Moors
    BH22 0NA Ferndown
    Dorset
    British84493950001
    WEATHERALL, Sally
    32 Fountain Drive
    Inchinnan Business Park
    PA4 9RF Inchinnan
    Renfrewshire
    Secrétaire
    32 Fountain Drive
    Inchinnan Business Park
    PA4 9RF Inchinnan
    Renfrewshire
    152389640001
    WILLIAMS, Paul
    18 Kirkhouse Road
    Blanefield
    G63 9DA Glasgow
    Secrétaire
    18 Kirkhouse Road
    Blanefield
    G63 9DA Glasgow
    BritishAccountant83461940001
    LORRAINE YOUNG COMPANY SECRETARIES LIMITED
    6th Floor
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    Shakespeare Martineau Llp
    United Kingdom
    Secrétaire
    6th Floor
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    Shakespeare Martineau Llp
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement07873246
    165261700001
    PRISM COSEC LIMITED
    Regent Street
    W1B 2ES London
    271
    England
    Secrétaire
    Regent Street
    W1B 2ES London
    271
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement06633248
    160987360001
    DHODY, Jog
    32 Fountain Drive
    Inchinnan Business Park
    PA4 9RF Inchinnan
    Renfrewshire
    Administrateur
    32 Fountain Drive
    Inchinnan Business Park
    PA4 9RF Inchinnan
    Renfrewshire
    EnglandBritishChartered Accountant104269910005
    EMANUEL, Richard John Metcalfe
    Le Formentor
    27 Avenue Princesse Grace
    Monaco
    98000
    Administrateur
    Le Formentor
    27 Avenue Princesse Grace
    Monaco
    98000
    MonacoBritishCompany Director91766020001
    GORMAN, Christopher Simon
    Ravenswood Prieston Road
    PA11 3AN Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Administrateur
    Ravenswood Prieston Road
    PA11 3AN Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    ScotlandEnglishCompany Director38525620002
    JOHNSTON, Philip James
    10 Mclaren Grove
    Kittoch Glen, East Kilbride
    G74 4SR Glasgow
    Administrateur
    10 Mclaren Grove
    Kittoch Glen, East Kilbride
    G74 4SR Glasgow
    ScotlandBritishGeneral Manager90598180001
    KELHAM, David William
    32 Fountain Drive
    Inchinnan Business Park
    PA4 9RF Inchinnan
    Renfrewshire
    Administrateur
    32 Fountain Drive
    Inchinnan Business Park
    PA4 9RF Inchinnan
    Renfrewshire
    EnglandBritishDirector87146390001
    KELHAM, David William
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    EnglandBritishDirector87146390001
    LEE, Andrew Stephen
    Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    4th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    32 Wigmore Street
    W1U 2RP London
    4th
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director159105430001
    SIMPSON, William Alexander
    8 Airbles Farm Road
    ML1 3AZ Motherwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    8 Airbles Farm Road
    ML1 3AZ Motherwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritishCo Director206100001
    STOKES, Gary Martin
    16a Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LG Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    16a Fiery Hill Road
    Barnt Green
    B45 8LG Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishDirector71396660002
    TANSINI, Sergio
    32 Fountain Drive
    Inchinnan Business Park
    PA4 9RF Inchinnan
    Renfrewshire
    Administrateur
    32 Fountain Drive
    Inchinnan Business Park
    PA4 9RF Inchinnan
    Renfrewshire
    ScotlandItalianManaging Director106858140001
    TANSINI, Sergio
    55 Gamekeepers Road
    EH4 6LR Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    55 Gamekeepers Road
    EH4 6LR Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandItalianCo Director106858140001
    TELFORD, Bruce
    Westwood,51 Broompark Drive
    Newton Mearns
    G77 5EH Renfrewshire
    Administrateur
    Westwood,51 Broompark Drive
    Newton Mearns
    G77 5EH Renfrewshire
    BritishTraining Officer1165580001
    TELFORD, Robert
    1-102 Byres Road
    G11 5RD Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    1-102 Byres Road
    G11 5RD Glasgow
    Lanarkshire
    BritishSales Administator27186030001
    WHYTE, John Joseph
    8 Greenbank Avenue
    Whitecraigs
    G46 6SG Glasgow
    Administrateur
    8 Greenbank Avenue
    Whitecraigs
    G46 6SG Glasgow
    ScotlandBritishCompany Director9384550003
    WILSON, Jeremy Michael Charles
    Hinchingbrooke Business Park
    Huntingdon
    PE29 6FN Cambridgeshire
    Kingfisher Way
    United Kingdom
    Administrateur
    Hinchingbrooke Business Park
    Huntingdon
    PE29 6FN Cambridgeshire
    Kingfisher Way
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector151756520001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur REGENERSIS (GLASGOW) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    MK12 5TH Wolverton Mill
    Featherstone Road
    Milton Keynes
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    MK12 5TH Wolverton Mill
    Featherstone Road
    Milton Keynes
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement2966414
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    REGENERSIS (GLASGOW) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 04 avr. 2016
    Livré le 08 avr. 2016
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Citizens Bank of Pennsylvania as Security Trustee
    Transactions
    • 08 avr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 12 oct. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 04 avr. 2016
    Livré le 08 avr. 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Citizens Bank of Pennsylvania as Security Trustee
    Transactions
    • 08 avr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 12 oct. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal assignment of contract monies
    Créé le 21 déc. 2012
    Livré le 04 janv. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Rights title and interest in and to the contract monies see form for further details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 04 janv. 2013Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 31 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 20 déc. 2012
    Livré le 09 janv. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 09 janv. 2013Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 09 janv. 2013Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 31 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 12 mai 2011
    Livré le 25 mai 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 25 mai 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 09 janv. 2013Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 avr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 03 sept. 2009
    Livré le 15 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Kbc Bank Nv
    Transactions
    • 15 sept. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Standard security
    Créé le 04 juil. 2003
    Livré le 11 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    28-32 fountain drive, inchinnan, renfrew ren 96005.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 juil. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 26 juin 2003
    Livré le 07 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 juil. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Floating charge
    Créé le 01 juin 1998
    Livré le 10 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 juin 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Floating charge
    Créé le 03 nov. 1993
    Livré le 05 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 nov. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mai 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 17 juil. 1991
    Livré le 24 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 24 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 18 févr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 28 mars 1990
    Livré le 04 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 avr. 1990Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0