STRATHAIRD SALMON LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTRATHAIRD SALMON LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC112895
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STRATHAIRD SALMON LIMITED ?

    • Transformation et conservation de poissons, crustacés et mollusques (10200) / Industries manufacturières

    Où se situe STRATHAIRD SALMON LIMITED ?

    Adresse du siège social
    319 St. Vincent Street
    G2 5AS Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STRATHAIRD SALMON LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    STRATHAIRD LIMITED15 juil. 199315 juil. 1993
    MCLEAN BROTHERS (SMOKED SCOTTISH SALMON) COMPANY LIMITED13 oct. 198813 oct. 1988
    MITRESHELF 47 LIMITED22 août 198822 août 1988

    Quels sont les derniers comptes de STRATHAIRD SALMON LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour STRATHAIRD SALMON LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché)

    7 pagesLIQ13(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de C/O Kpmg Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG à 319 st. Vincent Street Glasgow G2 5AS le 14 mai 2021

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Watermill Road Fraserburgh Aberdeenshire AB43 9HA à C/O Kpmg Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG le 17 juil. 2020

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 10 juil. 2020

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 22 oct. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Jenny Nancy Loncaster en tant que directeur le 25 sept. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Timothy Mark Busby en tant que directeur le 12 sept. 2019

    1 pagesTM01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2019 au 31 mars 2020

    1 pagesAA01

    Nomination de Mr Michael Kamiel Jan Alfons Kestemont en tant qu'administrateur le 04 juil. 2019

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2018

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 04 juil. 2019

    1 pagesTM02

    Modification des coordonnées du secrétaire Wilkin Chapman Company Secretarial Service Ltd le 19 nov. 2018

    1 pagesCH04

    Déclaration de confirmation établie le 22 oct. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2017

    4 pagesAA

    Nomination de Mr Timothy Mark Busby en tant qu'administrateur le 31 déc. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Malcolm Herbert Lofts en tant que directeur le 31 déc. 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 22 oct. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2016

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 oct. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2015

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 nov. 2015

    État du capital au 18 nov. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2014

    3 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    1 pagesSH20

    Qui sont les dirigeants de STRATHAIRD SALMON LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KESTEMONT, Michael Kamiel Jan Alfons
    St. Vincent Street
    G2 5AS Glasgow
    319
    Administrateur
    St. Vincent Street
    G2 5AS Glasgow
    319
    United KingdomBelgian231792890001
    ANDERSON, Jacqueline Shona
    Braydon Hall
    Minety
    SN16 9QX Malmesbury
    Wiltshire
    Secrétaire
    Braydon Hall
    Minety
    SN16 9QX Malmesbury
    Wiltshire
    British681210002
    GAULT, Sandra
    25 Pitblae Gardens
    AB43 7BH Fraserburgh
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    25 Pitblae Gardens
    AB43 7BH Fraserburgh
    Aberdeenshire
    British61174690002
    HARRISON, Colin John
    19 Marine Terrace
    IV10 8UL Rosemarkie
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    19 Marine Terrace
    IV10 8UL Rosemarkie
    Aberdeenshire
    British83243190001
    RITCHIE, Douglas
    20 Beaufort Road
    IV2 3NP Inverness
    Secrétaire
    20 Beaufort Road
    IV2 3NP Inverness
    British681250001
    ROGERS, John Andrew
    19 Croft Road
    Scourguie
    IV3 6RS Inverness
    Secrétaire
    19 Croft Road
    Scourguie
    IV3 6RS Inverness
    British54767800001
    SOUTAR, Norman Graeme Scott
    8 Canonbury Terrace
    IV10 8TT Fortrose
    Ross Shire
    Secrétaire
    8 Canonbury Terrace
    IV10 8TT Fortrose
    Ross Shire
    British59456400003
    WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Secrétaire désigné
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2249348
    900013350001
    ANDERSON, Ian Scott
    Braydon Hall
    Minety
    SN16 9QX Malmesbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Braydon Hall
    Minety
    SN16 9QX Malmesbury
    Wiltshire
    EnglandBritish681230002
    ANDERSON, Jacqueline Shona
    Braydon Hall
    Minety
    SN16 9QX Malmesbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Braydon Hall
    Minety
    SN16 9QX Malmesbury
    Wiltshire
    EnglandBritish681210002
    BRITTON, Christopher Paul
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    Administrateur
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    United KingdomBritish127835580001
    BUSBY, Timothy Mark
    Watermill Road
    Fraserburgh
    AB43 9HA Aberdeenshire
    Administrateur
    Watermill Road
    Fraserburgh
    AB43 9HA Aberdeenshire
    EnglandEnglish169852920001
    FORBES, Hamish Drummond
    Watermill Road
    Fraserburgh
    AB43 9HA Aberdeenshire
    Administrateur
    Watermill Road
    Fraserburgh
    AB43 9HA Aberdeenshire
    EnglandBritish66295550001
    GATES, Kevin
    20 Moray Park Avenue
    Culloden
    IV1 2LS Inverness
    Administrateur
    20 Moray Park Avenue
    Culloden
    IV1 2LS Inverness
    British47833660001
    GATES, Kevin
    20 Moray Park Avenue
    Culloden
    IV1 2LS Inverness
    Administrateur
    20 Moray Park Avenue
    Culloden
    IV1 2LS Inverness
    British47833660001
    HARKJAER, Per
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    EnglandDanish127032620001
    HARRIS, Derrick
    Shamba
    Croy
    IV1 2PR Inverness
    Administrateur
    Shamba
    Croy
    IV1 2PR Inverness
    British1259590001
    HARRIS, Derrick
    Shamba
    Croy
    IV1 2PR Inverness
    Administrateur
    Shamba
    Croy
    IV1 2PR Inverness
    British1259590001
    HAZELDEAN, James William
    29/5 Inverleith Place
    EH3 5QD Edinburgh
    Administrateur
    29/5 Inverleith Place
    EH3 5QD Edinburgh
    British10359650003
    HUNTER, Jeremy Julian
    20 Birch Drive
    Maryburgh
    IV7 8ED Dingwall
    Ross Shire
    Administrateur
    20 Birch Drive
    Maryburgh
    IV7 8ED Dingwall
    Ross Shire
    British62987810001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Administrateur
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish84487230001
    LOFTS, Malcolm Herbert
    Watermill Road
    Fraserburgh
    AB43 9HA Aberdeenshire
    Administrateur
    Watermill Road
    Fraserburgh
    AB43 9HA Aberdeenshire
    EnglandBritish177239110001
    LONCASTER, Jenny Nancy
    Watermill Road
    Fraserburgh
    AB43 9HA Aberdeenshire
    Administrateur
    Watermill Road
    Fraserburgh
    AB43 9HA Aberdeenshire
    EnglandBritish185293570001
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Administrateur
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    United KingdomBritish2785890001
    RITCHIE, Douglas
    20 Beaufort Road
    IV2 3NP Inverness
    Administrateur
    20 Beaufort Road
    IV2 3NP Inverness
    British681250001
    ROGERS, John Andrew
    19 Croft Road
    Scourguie
    IV3 6RS Inverness
    Administrateur
    19 Croft Road
    Scourguie
    IV3 6RS Inverness
    British54767800001
    SMITH, Kevan William
    Whistletop Cottage Upper Harrapool
    IV49 9AH Broadford
    Isle Of Skye
    Administrateur
    Whistletop Cottage Upper Harrapool
    IV49 9AH Broadford
    Isle Of Skye
    British54926990001
    SOUTAR, Norman Graeme Scott
    8 Canonbury Terrace
    IV10 8TT Fortrose
    Ross Shire
    Administrateur
    8 Canonbury Terrace
    IV10 8TT Fortrose
    Ross Shire
    British59456400003
    TAYLOR, Robert Charles
    15a Old Mill Lane
    IV2 3XP Inverness
    Administrateur
    15a Old Mill Lane
    IV2 3XP Inverness
    British89933750001
    THORN, Phillip Anthony
    Drynie Lodge Upper Myrtlefield
    IV2 5BX Inverness
    Administrateur
    Drynie Lodge Upper Myrtlefield
    IV2 5BX Inverness
    United KingdomBritish14693080002
    WRIGHT, Robin James Morrison
    7 Buckland Gate
    Wexham
    SL3 6LS Slough
    Berkshire
    Administrateur
    7 Buckland Gate
    Wexham
    SL3 6LS Slough
    Berkshire
    United KingdomBritish71513490001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur STRATHAIRD SALMON LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    England
    06 avr. 2016
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03751665
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    STRATHAIRD SALMON LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 06 nov. 2008
    Livré le 22 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The tenants interest in the lease of the subjects extending top 0.3 hectares lying to the east of longman drive known as 25 longman drive, inverness INV8833.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 22 nov. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 06 nov. 2008
    Livré le 19 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Tenants interest in lease of 21 longman drive, inverness.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 19 nov. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 06 nov. 2008
    Livré le 19 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Tenants interest in the lease of 23A longman drive, inverness.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 19 nov. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Debenture
    Créé le 23 oct. 2008
    Livré le 05 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 05 nov. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 23 sept. 2008
    Livré le 03 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 03 oct. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 30 mars 2007
    Livré le 04 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects to be known as twenty-three a longman drive, inverness.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 04 avr. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 30 mars 2007
    Livré le 04 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects known as twenty-one longman drive, inverness.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 04 avr. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Debenture
    Créé le 21 mars 2007
    Livré le 31 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed charges by way of legal mortgage all material premises, all the subsidary shares and investments and distribution rights, all other interests in any material premises, all plant machinery vehicles computers office and other equipment, all book debts - see form 410 appendix 2 for further details including floating charge over all assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale as Security Agent
    Transactions
    • 31 mars 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 oct. 2008
    • 28 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 28 mars 2006
    Livré le 31 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under the finance documents
    Brèves mentions
    The tenant's interest in the lease of the subjects extending to 0.763 hectares lying on the north-east side of longman drive, inverness and known as 21 longman drive, inverness.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 31 mars 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 28 mars 2006
    Livré le 31 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under the finance documents
    Brèves mentions
    The tenant's interest in the lease of the warehouse and area of ground extending to 0.719 hectares lying on the north side of longman drive, inverness and to be known as 23A longman drive, inverness.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 31 mars 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Debenture
    Créé le 16 mars 2006
    Livré le 29 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under the finance documents
    Brèves mentions
    First legal mortgage over all material premises; first fixed and floating charges over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 29 mars 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 oct. 2008
    • 28 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 12 déc. 2005
    Livré le 20 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 20 déc. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 07 déc. 2005
    Livré le 28 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Tenants interest in lease over 21 longman drive, inverness.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 28 déc. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 07 déc. 2005
    Livré le 28 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Tenants interest in the lease over 23A longman drive, inverness.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 28 déc. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 20 juil. 2004
    Livré le 28 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    21 longman drive, inverness.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 28 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 20 juil. 2004
    Livré le 28 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground extending to seven hundred and nineteen decimal or one thousandth parts of a hectare or thereby metric measure to be known as 23A longman drive, inverness.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 28 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 30 juin 2004
    Livré le 10 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First legal mortgage over all material premises; first fixed and floating charges over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale
    Transactions
    • 10 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Debenture
    Créé le 20 déc. 2000
    Livré le 04 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 janv. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 20 déc. 2000
    Livré le 03 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 janv. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 20 avr. 1999
    Livré le 26 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    23 and 23A longman drive, inverness.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 avr. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 21 oct. 1997
    Livré le 29 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    23A longman drive,inverness.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 oct. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 21 oct. 1997
    Livré le 29 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    21 longman drive,inverness.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 oct. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 15 oct. 1997
    Livré le 28 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The hatchery and kilmarieloch,kilmarie farm,isle of skye.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 oct. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 15 oct. 1997
    Livré le 28 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1.47 hectares at 2 march road,buckie.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 oct. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 15 oct. 1997
    Livré le 28 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Faoilean,strathaird estate,broadford,isle of skye.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 oct. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    STRATHAIRD SALMON LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 juil. 2020Commencement of winding up
    15 janv. 2022Due to be dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0