STRATHAIRD SALMON LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | STRATHAIRD SALMON LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC112895 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe STRATHAIRD SALMON LIMITED ?
| Adresse du siège social | 319 St. Vincent Street G2 5AS Glasgow |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de STRATHAIRD SALMON LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour STRATHAIRD SALMON LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché) | 7 pages | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Kpmg Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG à 319 st. Vincent Street Glasgow G2 5AS le 14 mai 2021 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Watermill Road Fraserburgh Aberdeenshire AB43 9HA à C/O Kpmg Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG le 17 juil. 2020 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 oct. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jenny Nancy Loncaster en tant que directeur le 25 sept. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy Mark Busby en tant que directeur le 12 sept. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2019 au 31 mars 2020 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Nomination de Mr Michael Kamiel Jan Alfons Kestemont en tant qu'administrateur le 04 juil. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2018 | 4 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 04 juil. 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Wilkin Chapman Company Secretarial Service Ltd le 19 nov. 2018 | 1 pages | CH04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 oct. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2017 | 4 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Timothy Mark Busby en tant qu'administrateur le 31 déc. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Malcolm Herbert Lofts en tant que directeur le 31 déc. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 oct. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2016 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 oct. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2015 | 10 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2014 | 3 pages | AA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de STRATHAIRD SALMON LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESTEMONT, Michael Kamiel Jan Alfons | Administrateur | St. Vincent Street G2 5AS Glasgow 319 | United Kingdom | Belgian | 231792890001 | |||||||||
| ANDERSON, Jacqueline Shona | Secrétaire | Braydon Hall Minety SN16 9QX Malmesbury Wiltshire | British | 681210002 | ||||||||||
| GAULT, Sandra | Secrétaire | 25 Pitblae Gardens AB43 7BH Fraserburgh Aberdeenshire | British | 61174690002 | ||||||||||
| HARRISON, Colin John | Secrétaire | 19 Marine Terrace IV10 8UL Rosemarkie Aberdeenshire | British | 83243190001 | ||||||||||
| RITCHIE, Douglas | Secrétaire | 20 Beaufort Road IV2 3NP Inverness | British | 681250001 | ||||||||||
| ROGERS, John Andrew | Secrétaire | 19 Croft Road Scourguie IV3 6RS Inverness | British | 54767800001 | ||||||||||
| SOUTAR, Norman Graeme Scott | Secrétaire | 8 Canonbury Terrace IV10 8TT Fortrose Ross Shire | British | 59456400003 | ||||||||||
| WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | 26 Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby Cartergate House England |
| 900013350001 | ||||||||||
| ANDERSON, Ian Scott | Administrateur | Braydon Hall Minety SN16 9QX Malmesbury Wiltshire | England | British | 681230002 | |||||||||
| ANDERSON, Jacqueline Shona | Administrateur | Braydon Hall Minety SN16 9QX Malmesbury Wiltshire | England | British | 681210002 | |||||||||
| BRITTON, Christopher Paul | Administrateur | Park Grange Main Street LS22 4AP Sicklinghall West Yorkshire | United Kingdom | British | 127835580001 | |||||||||
| BUSBY, Timothy Mark | Administrateur | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | English | 169852920001 | |||||||||
| FORBES, Hamish Drummond | Administrateur | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | British | 66295550001 | |||||||||
| GATES, Kevin | Administrateur | 20 Moray Park Avenue Culloden IV1 2LS Inverness | British | 47833660001 | ||||||||||
| GATES, Kevin | Administrateur | 20 Moray Park Avenue Culloden IV1 2LS Inverness | British | 47833660001 | ||||||||||
| HARKJAER, Per | Administrateur | Oakridge House 6 Montrose Gardens Oxshott KT22 0UU Leatherhead Surrey | England | Danish | 127032620001 | |||||||||
| HARRIS, Derrick | Administrateur | Shamba Croy IV1 2PR Inverness | British | 1259590001 | ||||||||||
| HARRIS, Derrick | Administrateur | Shamba Croy IV1 2PR Inverness | British | 1259590001 | ||||||||||
| HAZELDEAN, James William | Administrateur | 29/5 Inverleith Place EH3 5QD Edinburgh | British | 10359650003 | ||||||||||
| HUNTER, Jeremy Julian | Administrateur | 20 Birch Drive Maryburgh IV7 8ED Dingwall Ross Shire | British | 62987810001 | ||||||||||
| LEADBEATER, Stephen Paul | Administrateur | Allt Nam Breac Mill Lane, Legbourne LN11 8LT Louth Lincolnshire | England | British | 84487230001 | |||||||||
| LOFTS, Malcolm Herbert | Administrateur | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | British | 177239110001 | |||||||||
| LONCASTER, Jenny Nancy | Administrateur | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | British | 185293570001 | |||||||||
| PARKER, Michael | Administrateur | Humber Lodge Old Post Office Lane South Ferriby DN18 6HH Barton Upon Humber N E Lincolnshire | United Kingdom | British | 2785890001 | |||||||||
| RITCHIE, Douglas | Administrateur | 20 Beaufort Road IV2 3NP Inverness | British | 681250001 | ||||||||||
| ROGERS, John Andrew | Administrateur | 19 Croft Road Scourguie IV3 6RS Inverness | British | 54767800001 | ||||||||||
| SMITH, Kevan William | Administrateur | Whistletop Cottage Upper Harrapool IV49 9AH Broadford Isle Of Skye | British | 54926990001 | ||||||||||
| SOUTAR, Norman Graeme Scott | Administrateur | 8 Canonbury Terrace IV10 8TT Fortrose Ross Shire | British | 59456400003 | ||||||||||
| TAYLOR, Robert Charles | Administrateur | 15a Old Mill Lane IV2 3XP Inverness | British | 89933750001 | ||||||||||
| THORN, Phillip Anthony | Administrateur | Drynie Lodge Upper Myrtlefield IV2 5BX Inverness | United Kingdom | British | 14693080002 | |||||||||
| WRIGHT, Robin James Morrison | Administrateur | 7 Buckland Gate Wexham SL3 6LS Slough Berkshire | United Kingdom | British | 71513490001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur STRATHAIRD SALMON LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Young's Seafood Limited | 06 avr. 2016 | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
STRATHAIRD SALMON LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Créé le 06 nov. 2008 Livré le 22 nov. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The tenants interest in the lease of the subjects extending top 0.3 hectares lying to the east of longman drive known as 25 longman drive, inverness INV8833. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 06 nov. 2008 Livré le 19 nov. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Tenants interest in lease of 21 longman drive, inverness. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 06 nov. 2008 Livré le 19 nov. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Tenants interest in the lease of 23A longman drive, inverness. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 23 oct. 2008 Livré le 05 nov. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 23 sept. 2008 Livré le 03 oct. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 30 mars 2007 Livré le 04 avr. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Subjects to be known as twenty-three a longman drive, inverness. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 30 mars 2007 Livré le 04 avr. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Subjects known as twenty-one longman drive, inverness. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 21 mars 2007 Livré le 31 mars 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed charges by way of legal mortgage all material premises, all the subsidary shares and investments and distribution rights, all other interests in any material premises, all plant machinery vehicles computers office and other equipment, all book debts - see form 410 appendix 2 for further details including floating charge over all assets. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 28 mars 2006 Livré le 31 mars 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due under the finance documents | |
Brèves mentions The tenant's interest in the lease of the subjects extending to 0.763 hectares lying on the north-east side of longman drive, inverness and known as 21 longman drive, inverness. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 28 mars 2006 Livré le 31 mars 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due under the finance documents | |
Brèves mentions The tenant's interest in the lease of the warehouse and area of ground extending to 0.719 hectares lying on the north side of longman drive, inverness and to be known as 23A longman drive, inverness. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 16 mars 2006 Livré le 29 mars 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due under the finance documents | |
Brèves mentions First legal mortgage over all material premises; first fixed and floating charges over assets. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 12 déc. 2005 Livré le 20 déc. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 07 déc. 2005 Livré le 28 déc. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Tenants interest in lease over 21 longman drive, inverness. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 07 déc. 2005 Livré le 28 déc. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Tenants interest in the lease over 23A longman drive, inverness. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 20 juil. 2004 Livré le 28 juil. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 21 longman drive, inverness. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 20 juil. 2004 Livré le 28 juil. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Area of ground extending to seven hundred and nineteen decimal or one thousandth parts of a hectare or thereby metric measure to be known as 23A longman drive, inverness. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 30 juin 2004 Livré le 10 juil. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions First legal mortgage over all material premises; first fixed and floating charges over assets. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 20 déc. 2000 Livré le 04 janv. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over property; fixed charges over assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 20 déc. 2000 Livré le 03 janv. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 20 avr. 1999 Livré le 26 avr. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 23 and 23A longman drive, inverness. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 21 oct. 1997 Livré le 29 oct. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 23A longman drive,inverness. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 21 oct. 1997 Livré le 29 oct. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 21 longman drive,inverness. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 15 oct. 1997 Livré le 28 oct. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The hatchery and kilmarieloch,kilmarie farm,isle of skye. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 15 oct. 1997 Livré le 28 oct. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 1.47 hectares at 2 march road,buckie. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 15 oct. 1997 Livré le 28 oct. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Faoilean,strathaird estate,broadford,isle of skye. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
STRATHAIRD SALMON LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0