TEREX POWERTRAIN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTEREX POWERTRAIN LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC113609
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TEREX POWERTRAIN LIMITED ?

    • Autres activités d'ingénierie (71129) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TEREX POWERTRAIN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Newhouse Industrial Estate
    Newhouse
    ML1 5RY Motherwell
    Lanarkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TEREX POWERTRAIN LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PRECISION POWERTRAIN (U.K.) LIMITED01 déc. 198801 déc. 1988
    RONA LIMITED29 sept. 198829 sept. 1988

    Quels sont les derniers comptes de TEREX POWERTRAIN LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TEREX POWERTRAIN LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour TEREX POWERTRAIN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    13 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 mars 2015

    État du capital au 18 mars 2015

    • Capital: GBP 52,936
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 mars 2014

    État du capital au 25 mars 2014

    • Capital: GBP 52,936
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Mr Kevin Patrick Bradley en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Phillip Widman en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Nomination de George Wayne Ellis en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Brian Heathcote en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    19 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de * Catto Drive Peterhead Aberdeenshire AB42 1RL* le 28 janv. 2011

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    Cessation de la nomination de Ian Lundie en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 25/11/2009
    RES13

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    18 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de TEREX POWERTRAIN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COHEN, Eric I
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    Secrétaire
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    American65582430009
    BRADLEY, Kevin Patrick
    Industrial Estate
    Newhouse
    ML1 5RY Motherwell
    Newhouse
    Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Industrial Estate
    Newhouse
    ML1 5RY Motherwell
    Newhouse
    Lanarkshire
    Scotland
    Untied States Of AmericaAmerican176590390001
    COHEN, Eric I
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    Administrateur
    Burnham Hill Road
    Westport
    Connecticut, 06880
    32
    Fairfield
    Usa
    United StatesAmerican65582430009
    ELLIS, George Wayne
    c/o Terex Corporation
    Nyala Farm Road
    06880 Westport
    200
    Connecticut
    Usa
    Administrateur
    c/o Terex Corporation
    Nyala Farm Road
    06880 Westport
    200
    Connecticut
    Usa
    UsaU.S. Citizen164682610001
    BAILLIE, Fergus Cumming
    4 Abinger Gardens
    Murrayfield
    EH12 6DE Edinburgh
    Scotland
    Secrétaire
    4 Abinger Gardens
    Murrayfield
    EH12 6DE Edinburgh
    Scotland
    British924340002
    MASSON & GLENNIE
    Broad House
    Broad Street
    AB42 1HY Peterhead
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    Broad House
    Broad Street
    AB42 1HY Peterhead
    Aberdeenshire
    41524400001
    BAILLIE, Fergus Cumming
    4 Abinger Gardens
    Murrayfield
    EH12 6DE Edinburgh
    Scotland
    Administrateur
    4 Abinger Gardens
    Murrayfield
    EH12 6DE Edinburgh
    Scotland
    British924340002
    BLOW, Ernest
    27 Prince Street
    AB42 6QE Peterhead
    Administrateur
    27 Prince Street
    AB42 6QE Peterhead
    British1070930001
    BRADFORD, William David
    6 Henderson Park
    AB42 6WR Peterhead
    Aberdeenshire
    Administrateur
    6 Henderson Park
    AB42 6WR Peterhead
    Aberdeenshire
    British48533170001
    BRADFORD, William
    20 Blackhouse Terrace
    AB42 6LR Peterhead
    Administrateur
    20 Blackhouse Terrace
    AB42 6LR Peterhead
    British295440001
    BUCHAN, William Strachan
    14 Greenlaw Road
    Newton Mearns
    G77 6ND Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    14 Greenlaw Road
    Newton Mearns
    G77 6ND Glasgow
    Lanarkshire
    British6506130001
    FRASER, Iain Grant Robertson
    1 Braehead Place
    Longside
    AB42 4UW Peterhead
    Aberdeenshire
    Administrateur
    1 Braehead Place
    Longside
    AB42 4UW Peterhead
    Aberdeenshire
    British50209550001
    FRASER, John
    Eilean A' Cheo
    Blackhills
    AB42 7JR Peterhead
    Administrateur
    Eilean A' Cheo
    Blackhills
    AB42 7JR Peterhead
    British295450001
    HEATHCOTE, Brian Sydney
    1 Bakers Square
    The Green Fernham
    SN7 7NT Faringdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    1 Bakers Square
    The Green Fernham
    SN7 7NT Faringdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish125460530001
    HODGSON, David Eric
    20 Broomvale Drive
    Newton Mearns
    G77 5NN Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    20 Broomvale Drive
    Newton Mearns
    G77 5NN Glasgow
    Lanarkshire
    British912960001
    ISAMAN, Robert
    199 South Main Street
    West Hartford
    Connecticut 06107
    Usa
    Administrateur
    199 South Main Street
    West Hartford
    Connecticut 06107
    Usa
    American125172920001
    LUNDIE, Ian Allison
    4 Cresswell Place
    Newton Mearns
    G77 5FD Glasgow
    Administrateur
    4 Cresswell Place
    Newton Mearns
    G77 5FD Glasgow
    ScotlandBritish37162090002
    MACRITCHIE, John Angus
    Broad House
    Broad Street
    AB42 6JA Peterhead
    Administrateur désigné
    Broad House
    Broad Street
    AB42 6JA Peterhead
    British900003140001
    ROBERTSON, Colin
    4 Leemuir View
    ML8 4AN Carluke
    South Lanarkshire
    Administrateur
    4 Leemuir View
    ML8 4AN Carluke
    South Lanarkshire
    British77076440001
    STEWART, Michael Gavin
    22 Belmont Drive
    Giffnock
    G46 7PA Glasgow
    Administrateur
    22 Belmont Drive
    Giffnock
    G46 7PA Glasgow
    United KingdomBritish59163490001
    WATT, Charles
    1 St Magnus Place
    AB42 2UU Peterhead
    Administrateur
    1 St Magnus Place
    AB42 2UU Peterhead
    ScotlandBritish1070940001
    WIDMAN, Phillip Charles
    25 Old Stone Crossing
    West Simsbury
    Connecticut 06092
    Usa
    Administrateur
    25 Old Stone Crossing
    West Simsbury
    Connecticut 06092
    Usa
    UsaAmerican144249950001

    TEREX POWERTRAIN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 04 août 1994
    Livré le 12 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Kellock Limited
    Transactions
    • 12 août 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 juin 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 27 juin 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 30 janv. 1990
    Livré le 08 févr. 1990
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    3 up 1ST left 238 paisley road west glasgow.
    Personnes ayant droit
    • James Finlay Bank Limited
    Transactions
    • 08 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    Floating charge
    Créé le 24 févr. 1989
    Livré le 16 mars 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 mars 1989Enregistrement d'une charge
    Bond & floating charge
    Créé le 24 févr. 1989
    Livré le 15 mars 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 mars 1989Enregistrement d'une charge
    • 23 mars 1993Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 15 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 24 févr. 1989
    Livré le 14 mars 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Morgan Equipment Co
    Transactions
    • 14 mars 1989Enregistrement d'une charge
    • 18 mars 1993Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 18 mars 1993Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 30 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 24 févr. 1989
    Livré le 01 mars 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Scottish Development Agency Glasgow
    Transactions
    • 01 mars 1989Enregistrement d'une charge
    • 22 mars 1993Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 23 mars 1993Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 10 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0