INSPIRE (PARTNERSHIP THROUGH LIFE) LTD.
Vue d'ensemble
| Nom de la société | INSPIRE (PARTNERSHIP THROUGH LIFE) LTD. |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
| Numéro de société | SC113676 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe INSPIRE (PARTNERSHIP THROUGH LIFE) LTD. ?
| Adresse du siège social | Unit 2000 Academy Park Gower Street G51 1PR Glasgow Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de INSPIRE (PARTNERSHIP THROUGH LIFE) LTD. ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour INSPIRE (PARTNERSHIP THROUGH LIFE) LTD. ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 02 nov. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 16 nov. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 02 nov. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour INSPIRE (PARTNERSHIP THROUGH LIFE) LTD. ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2025 | 32 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 nov. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Patricia Doran le 02 sept. 2025 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2024 | 51 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 nov. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Beach Boulevard Aberdeen AB24 5HP à Unit 2000 Academy Park Gower Street Glasgow G51 1PR le 18 avr. 2024 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Patricia Doran en tant que secrétaire le 18 avr. 2024 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David James Hedley en tant que secrétaire le 18 avr. 2024 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Notification de Community Integrated Care en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 juil. 2023 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 12 avr. 2024 | 2 pages | PSC09 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2023 | 46 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gillian Thomson en tant que directeur le 20 déc. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Allan Dick en tant que directeur le 20 déc. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 nov. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge SC1136760006 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire David James Hedley le 31 juil. 2023 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Statuts | 16 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Nicholas Gray en tant que directeur le 31 juil. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert John Hamilton en tant que directeur le 31 juil. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Hebenton en tant que directeur le 31 juil. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Linda Gray en tant que secrétaire le 31 juil. 2023 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de INSPIRE (PARTNERSHIP THROUGH LIFE) LTD. ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING, Patricia | Secrétaire | Gower Street G51 1PR Glasgow Unit 2000 Academy Park Scotland | 322050180002 | |||||||
| KANE, James Robert | Administrateur | Old Market Court Miners Way WA8 7SP Widnes 2 Cheshire England | England | British | 266307390001 | |||||
| SHERIDAN, Karen | Administrateur | Old Market Court Miners Way WA8 7SP Widnes 2 Cheshire England | Scotland | British | 304320280001 | |||||
| ARTHUR, Karen Mary | Secrétaire | Beach Boulevard Aberdeen AB24 5HP | 165362640002 | |||||||
| BLACKLEDGE, Peter | Secrétaire | 42 Loanhead Terrace AB25 2SY Aberdeen | British | 27855500001 | ||||||
| DALRYMPLE, John Darge | Secrétaire | Dunhallin 36 Dunnottar Avenue AB3 2JJ Stonehaven Kincardineshire | British | 832320001 | ||||||
| GRAY, Linda | Secrétaire | Beach Boulevard AB24 5HP Aberdeen Beach Boulevard Scotland | 247744730001 | |||||||
| HEDLEY, David James | Secrétaire | Old Market Court Miners Way WA8 7SP Widnes 2 Cheshire England | 311922270001 | |||||||
| MCPHEE-SMITH, Catriona Joyce | Secrétaire | 94 Craigiebuckler Avenue AB15 8NT Aberdeen Aberdeenshire | British | 80709990002 | ||||||
| ADAM COCHRAN ADVOCATES | Secrétaire | 6 Bonaccord Square AB9 1XU Aberdeen Aberdeenshire | 109420001 | |||||||
| BARNARD, Susan Patricia | Administrateur | Tilycorthie House Udny AB41 6SD Ellon Aberdeenshire | United Kingdom | British | 58060500001 | |||||
| BAXTER, Derek | Administrateur | Kepplehills Road Bucksburn AB21 9PL Aberdeen 111 Scotland | Scotland | British | 194095730001 | |||||
| BAXTER, Louise Morrison | Administrateur | 38 Albury Road AB1 2TL Aberdeen Aberdeenshire | Scotland U.K. | British | 186091030001 | |||||
| BLACKLEDGE, Peter | Administrateur | Beach Boulevard Aberdeen AB24 5HP | Scotland | British | 27855500001 | |||||
| BROWN, Stuart Burrison | Administrateur | Dean Road EH32 0QS Longniddry 1 Scotland | Scotland | British | 207553750002 | |||||
| BRUCE, Robert | Administrateur | 2 Lochside Terrace Bridge Of Don AB23 8QU Aberdeen Aberdeenshire | British | 832330001 | ||||||
| CARTER, Thomas Edward | Administrateur | 24 Gordon Road AB15 7RL Aberdeen | British | 38134270001 | ||||||
| CHESSOR, John Clinton | Administrateur | Hillside Crescent AB32 6PA Westhill 47 Aberdeenshire Scotland | Scotland | British | 50588700001 | |||||
| CHESSOR, John Clinton | Administrateur | 47 Hillside Crescent AB32 6PA Westhill Aberdeenshire | Scotland | British | 50588700001 | |||||
| D'ARCY, Philip | Administrateur | 14 Glen Avenue AB21 7FA Aberdeen | Scotland | British | 93745560001 | |||||
| DEAR, Martin | Administrateur | Bruntland Court Portlethen AB12 4UQ Aberdeen 41 Scotland | Scotland | British | 194097240001 | |||||
| DICK, David Allan | Administrateur | Rowan Tree Road AB31 5NT Banchory 5 Kincardineshire Scotland | United Kingdom | British | 58157770002 | |||||
| DURNO, Denis, Doctor | Administrateur | Olrig House Portlethen AB12 4QS Aberdeen Aberdeenshire | British | 130510001 | ||||||
| EMSLIE, Joyce | Administrateur | 38 East Park Road Kintore AB51 0FE Inverurie Aberdeenshire | British | 744060001 | ||||||
| EMSLIE, William | Administrateur | 38 East Park Road Kintore AB51 0FE Inverurie Aberdeenshire | Scotland | British | 41319460001 | |||||
| FORBES, Mary Mckay | Administrateur | Slains Park Farm DD10 0SY Kineff | Scotland | British | 142522130001 | |||||
| GRAY, Nicholas | Administrateur | Beach Boulevard Aberdeen AB24 5HP | Scotland | Scottish | 276901390002 | |||||
| HAMILTON, Robert John | Administrateur | Beach Boulevard Aberdeen AB24 5HP | England | British | 209307740002 | |||||
| HAWKINS, Colin Andrew | Administrateur | 106 Middlesmuir Road AB51 4RF Inverurie Aberdeenshire | Scotland | British | 113004100001 | |||||
| HEBENTON, Michael | Administrateur | Beach Boulevard Aberdeen AB24 5HP | Scotland | Scottish | 289679820001 | |||||
| HESSING, Roger | Administrateur | 49 Osborne Place AB25 2BX Aberdeen Aberdeenshire | Scotland | British | 621350001 | |||||
| HESSING, Roger | Administrateur | 49 Osborne Place AB25 2BX Aberdeen Aberdeenshire | Scotland | British | 621350001 | |||||
| HUTCHEON, Valerie Grace | Administrateur | Hazelmere, 6 Lochburn Brae AB51 0XW Kintore Aberdeenshire | Scotland | British | 73282340002 | |||||
| JACKSON, Robin Nigel, Dr | Administrateur | 4 Deeview Gardens Drumoak AB31 5AF Banchory Kincardineshire | Scotland | British | 321038250001 | |||||
| KELLEY, Robert | Administrateur | 24 Saint Nathalan Crescent AB31 5YU Banchory Kincardineshire | Scotland | United Kingdom | 67985520001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur INSPIRE (PARTNERSHIP THROUGH LIFE) LTD. ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community Integrated Care | 31 juil. 2023 | Miners Way WA8 7SP Widnes 2 Old Market Court England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr David Allan Dick | 25 oct. 2016 | Rowan Tree Road AB31 5NT Banchory 5 Scotland | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour INSPIRE (PARTNERSHIP THROUGH LIFE) LTD. ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 27 oct. 2022 | 31 juil. 2023 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0