STOLT SEA FARM LTD.

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTOLT SEA FARM LTD.
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC114037
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STOLT SEA FARM LTD. ?

    • (0502) /

    Où se situe STOLT SEA FARM LTD. ?

    Adresse du siège social
    Ratho Park, 88 Glasgow Road
    Ratho Station
    EH28 8PP Newbridge
    Midlothian
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STOLT SEA FARM LTD. ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    STOLT SEAFARM (UK) LTD.05 janv. 199805 janv. 1998
    GAELIC SEAFOODS (SCOTLAND) LIMITED28 avr. 199328 avr. 1993
    SHIANT ISLES LIMITED13 oct. 198813 oct. 1988

    Quels sont les derniers comptes de STOLT SEA FARM LTD. ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour STOLT SEA FARM LTD. ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 janv. 2010

    État du capital au 26 janv. 2010

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Kenneth James Mcintosh le 31 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    14 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    16 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    1 pages244

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de STOLT SEA FARM LTD. ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    THOMPSON, Lorraine Elizabeth
    40 Gardiner Road
    EH4 3RN Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    40 Gardiner Road
    EH4 3RN Edinburgh
    Midlothian
    British69247060001
    MCINTOSH, Kenneth James
    7 Nursery Park
    PH34 4EW Spean Bridge
    Inverness-Shire
    Administrateur
    7 Nursery Park
    PH34 4EW Spean Bridge
    Inverness-Shire
    ScotlandBritish124854160001
    SUTHERLAND, Alan George
    35 Corton Lea
    Alloway
    KA6 6GJ Ayr
    Administrateur
    35 Corton Lea
    Alloway
    KA6 6GJ Ayr
    ScotlandBritish121052220002
    BRADSHAW, Stephen John
    2 Collingwood Close
    Saltford
    BS31 3HZ Bristol
    Secrétaire
    2 Collingwood Close
    Saltford
    BS31 3HZ Bristol
    British36433080001
    CUNNINGHAM, Roderick
    1 East Street
    Sandwick
    HS2 OAG Isle Of Lewis
    Secrétaire
    1 East Street
    Sandwick
    HS2 OAG Isle Of Lewis
    British744890002
    CUNNINGHAM, Roderick
    1 East Street
    Sandwick
    HS2 OAG Isle Of Lewis
    Secrétaire
    1 East Street
    Sandwick
    HS2 OAG Isle Of Lewis
    British744890002
    DREW, Dan Hamilton
    Lower Poswick
    Whitbourne
    WR6 5SS Worcester
    Secrétaire
    Lower Poswick
    Whitbourne
    WR6 5SS Worcester
    British2128120001
    MACDONALD, Yvonne Frances
    21 West Kilbride Road
    KA24 5DZ Dalry
    Ayrshire
    Secrétaire
    21 West Kilbride Road
    KA24 5DZ Dalry
    Ayrshire
    British82618570002
    WILSON, Roger
    25 Beech Tree Avenue
    SL7 3NH Marlow
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    25 Beech Tree Avenue
    SL7 3NH Marlow
    Buckinghamshire
    British9209680001
    SECRETAR SECURITIES LIMITED
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    Secrétaire
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    77605900001
    BAILLIE, Stuart Malcolm
    1 Victoria Terrace
    IV2 3QA Inverness
    Scotland
    Administrateur
    1 Victoria Terrace
    IV2 3QA Inverness
    Scotland
    Scottish16614750002
    BRADSHAW, Stephen John
    2 Collingwood Close
    Saltford
    BS31 3HZ Bristol
    Administrateur
    2 Collingwood Close
    Saltford
    BS31 3HZ Bristol
    British36433080001
    CUNNINGHAM, Roderick
    1 East Street
    Sandwick
    HS2 OAG Isle Of Lewis
    Administrateur
    1 East Street
    Sandwick
    HS2 OAG Isle Of Lewis
    ScotlandBritish744890002
    DREW, Dan Hamilton
    Lower Poswick
    Whitbourne
    WR6 5SS Worcester
    Administrateur
    Lower Poswick
    Whitbourne
    WR6 5SS Worcester
    EnglandBritish2128120001
    FALLER, Guy Nicholas Anthony
    Jongskollen 27
    1337 Sanbvika
    FOREIGN Norway
    Administrateur
    Jongskollen 27
    1337 Sanbvika
    FOREIGN Norway
    British55284040002
    GABRIEL, Richard
    Huntley Manor
    GL19 3HQ Huntley
    Gloucestershire
    Administrateur
    Huntley Manor
    GL19 3HQ Huntley
    Gloucestershire
    British35002520003
    GILLEN, Patrick Francis
    44 Lambourne Wood
    Brennanstown Road
    IRISH Cabin Teely
    Dublin 18
    Ireland
    Administrateur
    44 Lambourne Wood
    Brennanstown Road
    IRISH Cabin Teely
    Dublin 18
    Ireland
    Irish51824730001
    GRONTVEOT, Havard Johannes
    9 Wedderburn Road
    FK15 0FN Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    9 Wedderburn Road
    FK15 0FN Dunblane
    Perthshire
    Norwegian114924300001
    INGRAM, Michael Peter, Dr
    Bisgood
    Thie-Ny-Chibbyr Surby
    ISLE MAN Port Erin
    Isle Of Man
    Administrateur
    Bisgood
    Thie-Ny-Chibbyr Surby
    ISLE MAN Port Erin
    Isle Of Man
    British878460001
    LORENTZEN, James Stove
    Dr. Holsvei 21a
    0787 Oslo
    Norway
    Administrateur
    Dr. Holsvei 21a
    0787 Oslo
    Norway
    Norwegian83761400001
    MAGUIRE, Brian Donal
    32
    Gravir
    PA86 9QX Isle Of Lewis
    Administrateur
    32
    Gravir
    PA86 9QX Isle Of Lewis
    British35616260001
    MATON, John Charles
    Hillsdown House
    32 Hampstead High Street
    NW3 1QD London
    Administrateur
    Hillsdown House
    32 Hampstead High Street
    NW3 1QD London
    British4953530001
    NICOLSON, Angus
    42-46 Point Street
    PA87 2XF Stornoway
    Isle Of Lewis
    Administrateur
    42-46 Point Street
    PA87 2XF Stornoway
    Isle Of Lewis
    British779730001
    STEIRO, Oystein
    Furstlia 15
    1367 Snaroya
    Norway
    Administrateur
    Furstlia 15
    1367 Snaroya
    Norway
    Norwegian81729570001
    STOLT-NIELSEN, Niels Gregers
    Thomas Heftyesgt 38
    N 0264 Oslo
    Norway
    Administrateur
    Thomas Heftyesgt 38
    N 0264 Oslo
    Norway
    Norwegian48417140001
    WILSON, Robert
    3 Pikes Knowe Court
    Cardrona
    EH45 9LP Peebles
    Borders
    Administrateur
    3 Pikes Knowe Court
    Cardrona
    EH45 9LP Peebles
    Borders
    ScotlandBritish84079420001

    STOLT SEA FARM LTD. a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 09 juin 1998
    Livré le 29 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land at tavay island,isle of lewis.
    Personnes ayant droit
    • Sea Farm Europe Limited
    Transactions
    • 29 juin 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 09 juin 1998
    Livré le 29 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground at sponish,north uist.
    Personnes ayant droit
    • Sea Farm Europe Limited
    Transactions
    • 29 juin 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 09 juin 1998
    Livré le 29 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground near geocrab,south harris.
    Personnes ayant droit
    • Sea Farm Europe Limited
    Transactions
    • 29 juin 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 18 mars 1998
    Livré le 08 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Sea Farm Europe Limited
    Transactions
    • 08 avr. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 11 août 1995
    Livré le 18 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All fish stocks.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ewos Limited
    Transactions
    • 18 août 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 févr. 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 30 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 10 août 1994
    Livré le 24 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    One acre or thereby of ground at sponish, north uist as relative to disposition by the lees group (scotland) limited (in receivership) ifo oval (759) limited dated 18TH august and recorded grs (inverness) 11TH nov 1992.
    Personnes ayant droit
    • Abacus (C.I.) Limited as Trustee of the D.H. Drew Settlement
    Transactions
    • 24 août 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 10 août 1994
    Livré le 24 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    2.258 acres near geocrab, south harris on the west of loch beacravik described in feu charter by lewis and harris welfare and development company limited ifo kenneth mackenzie limited dated 16TH and recorded grs (inverness) 20TH nov 1922 under exception.
    Personnes ayant droit
    • Abacus (C.I.) Limited as Trustee of the D.H. Drew Settlement
    Transactions
    • 24 août 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 août 1994
    Livré le 12 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground at sponish, north uist..... See ch microfiche.
    Personnes ayant droit
    • Hambros Channel Islands Trust Corporation Limited as Trustee
    Transactions
    • 12 août 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 août 1994
    Livré le 12 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground near geocrab, south harris as relative to feu charter by lewis and harris welfare and development company limited ifo kenneth mackenzie limited dated 16TH and recorded grs inverness 20TH nov 1922 under exception..... See ch microfiche.
    Personnes ayant droit
    • Hambros Channel Islands Trust Corporation Limited as Trustee
    Transactions
    • 12 août 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 août 1994
    Livré le 12 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground near geocrab, south harris as relative to feu charter by lewis and harris welfare and development company LTD ifo kenneth mackenzie limited dated 16TH and recorded grs inverness 20TH nov 1922 under exception... See ch microfiche.
    Personnes ayant droit
    • Hambros Channel Islands Trust Corporation Limited as Trustee
    Transactions
    • 12 août 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 août 1994
    Livré le 12 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground at sponish, north uist as relative to disposition by the lees group (scotland) limited (in receivership) ifo oval (759) limited dated 18TH aug and recorded grs inverness 11TH nov 1992.
    Personnes ayant droit
    • Hambros Channel Islands Trust Corporation Limited as Trustee
    Transactions
    • 12 août 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 06 juil. 1994
    Livré le 27 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Abacus (C.I.) Limited as Trustee of the D.H. Drew Settlement
    Transactions
    • 27 juil. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 août 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 févr. 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 28 févr. 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 06 juil. 1994
    Livré le 27 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hambros Channel Islands Trust Corporation Limited as Trustee
    Transactions
    • 27 juil. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 août 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 févr. 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 28 févr. 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 06 juil. 1994
    Livré le 27 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hambros Channel Islands Trust Corporation Limited as Trustee
    Transactions
    • 27 juil. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 août 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 févr. 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 28 févr. 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Floating charge
    Créé le 06 juil. 1994
    Livré le 27 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by the company and others
    Brèves mentions
    See ch microfiche.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hambros Channel Islands Trust Corporation Limited as Trustee
    Transactions
    • 27 juil. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 août 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 06 juil. 1994
    Livré le 27 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by the company and others
    Brèves mentions
    See ch microfiche.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Abacus (C.I.) Limited as Trustee of the D.H. Drew Settlement
    Transactions
    • 27 juil. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 août 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 06 juil. 1994
    Livré le 27 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by the company and others
    Brèves mentions
    See ch microfiche.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hambros Channel Islands Trust Corporation Limited as Trustee
    Transactions
    • 27 juil. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 août 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0