KINGSWAY ENTERTAINMENTS LIMITED

KINGSWAY ENTERTAINMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKINGSWAY ENTERTAINMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC114233
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KINGSWAY ENTERTAINMENTS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe KINGSWAY ENTERTAINMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    160 Dundee Street
    EH11 1DQ Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KINGSWAY ENTERTAINMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PBM TRADING LIMITED27 oct. 198827 oct. 1988

    Quels sont les derniers comptes de KINGSWAY ENTERTAINMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 sept. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour KINGSWAY ENTERTAINMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    15 pages4.26(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de Gala Clubs Regional Office Kerse Lane Falkirk FK1 1RJ le 05 août 2013

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 24 juil. 2013

    LRESSP

    Comptes pour une société dormante établis au 29 sept. 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital au 20 mars 2013

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Harry Willits le 19 févr. 2013

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 24 sept. 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 25 sept. 2010

    5 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    4 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    7 pagesMG03s

    Cessation de la nomination de Diane Penfold en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Harry Willits en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de KINGSWAY ENTERTAINMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GALA CORAL SECRETARIES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Secrétaire
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    69240850005
    WILLITS, Harry Andrew
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    Administrateur
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish175965490001
    GALA CORAL NOMINEES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Administrateur
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    76454320002
    GALA CORAL PROPERTIES LIMITED
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Administrateur
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3720332
    154862410001
    CAIRA, Umberto Vergilio
    54 Bennochy Road
    KY2 5RB Kirkcaldy
    Fife
    Secrétaire
    54 Bennochy Road
    KY2 5RB Kirkcaldy
    Fife
    British67499200001
    CHEATLE, Martyn David
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    Secrétaire
    The Retreat 81 Wales Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8JG Burton On Trent
    Staffordshire
    British48946420001
    GIBNEY, John Michael
    11 Boyce Gardens
    NG3 3FB Nottingham
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    11 Boyce Gardens
    NG3 3FB Nottingham
    Nottinghamshire
    British65178110001
    PHILLIPS, Peter Merton
    36 Abinger Road
    W4 1EL London
    Secrétaire
    36 Abinger Road
    W4 1EL London
    British1100750001
    SINTON, Charles Blair Ritchie
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    Secrétaire
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    British52292450003
    SMERDON, Leigh
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Secrétaire
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Other89075910001
    BURKE, Michael Ian
    Lamont House
    Canons Close
    NG25 0EP Southwell
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Lamont House
    Canons Close
    NG25 0EP Southwell
    Nottinghamshire
    British58500900001
    CAIRA, Mario Pasquale
    Anden Villa 24 Raith Gardens
    KY2 5NJ Kirkcaldy
    Fife
    Administrateur
    Anden Villa 24 Raith Gardens
    KY2 5NJ Kirkcaldy
    Fife
    British22720001
    CAIRA, Umberto Vergilio
    54 Bennochy Road
    KY2 5RB Kirkcaldy
    Fife
    Administrateur
    54 Bennochy Road
    KY2 5RB Kirkcaldy
    Fife
    ScotlandBritish67499200001
    CRONK, John Julian Tristam
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Administrateur
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    British6422100001
    GILLIGAN, Michael Francis
    27 Wembley Gardens
    Beeston
    NG9 3FE Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    27 Wembley Gardens
    Beeston
    NG9 3FE Nottingham
    Nottinghamshire
    British1423690001
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish21686380006
    KELLY, John Michael
    Prospect House
    The Green Finchingfield
    CB7 4JZ Braintree
    Essex
    Administrateur
    Prospect House
    The Green Finchingfield
    CB7 4JZ Braintree
    Essex
    British56474600002
    KERR, John Graham
    The Granary
    Browns Lane
    NG12 5BL Stanton On The Wolds
    Nottinghamshire
    Administrateur
    The Granary
    Browns Lane
    NG12 5BL Stanton On The Wolds
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish91841230001
    LEAFE, Stephen Frederick
    134 Scalpcliffe Road
    DE15 9AB Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    134 Scalpcliffe Road
    DE15 9AB Burton On Trent
    Staffordshire
    British39915030001
    PAYNE, Ian Timothy
    16 Wyken Close
    Dorridge
    B93 8RP Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    16 Wyken Close
    Dorridge
    B93 8RP Solihull
    West Midlands
    British78974110001
    PENFOLD, Diane June
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Administrateur
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    United KingdomBritish59962430002
    ROSS, Brian Richard
    14 Harrisons
    Birchanger
    CM23 5QT Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    14 Harrisons
    Birchanger
    CM23 5QT Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British985530001
    SOWERBY, Richard Thomas Neville
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish47734920003
    THOMAS, Paul
    26 Risegate
    NG12 3JF Cotgrave
    Nottinghamshire
    Administrateur
    26 Risegate
    NG12 3JF Cotgrave
    Nottinghamshire
    British29218800001
    VISOCCHI, Peter
    16 Boglily Road
    KY2 5NE Kirkcaldy
    Fife
    Administrateur
    16 Boglily Road
    KY2 5NE Kirkcaldy
    Fife
    British745370001
    WHITTAKER, James
    14 Cranbrook Drive
    AL4 0SS St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    14 Cranbrook Drive
    AL4 0SS St Albans
    Hertfordshire
    British1100730001

    KINGSWAY ENTERTAINMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 11 mai 2006
    Livré le 26 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 mai 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Standard security
    Créé le 29 déc. 2005
    Livré le 09 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    63 marischal street, peterhead.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 janv. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 29 déc. 2005
    Livré le 09 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at hume street, montrose.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 janv. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 29 déc. 2005
    Livré le 09 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    17-19 commercial road, leven, fife.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 janv. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 29 déc. 2005
    Livré le 09 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area or piece of ground in the burgh of arbroath, county of angus.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 janv. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Bond & floating charge
    Créé le 23 nov. 2005
    Livré le 03 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 déc. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Floating charge
    Créé le 27 oct. 2005
    Livré le 16 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under or in connection with any secured document
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over property and assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 16 nov. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Standard security
    Créé le 16 sept. 2005
    Livré le 23 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area or piec of ground lying in the burgh of arbroath and county of angus, being the subjects on the plan or sketch relative to the disposition by john campbell and another.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 16 sept. 2005
    Livré le 23 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    17-19 commercial road, leven, fife.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 16 sept. 2005
    Livré le 23 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at hume street, montrose.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 16 sept. 2005
    Livré le 23 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    63 marischal street, peterhead.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 01 sept. 2005
    Livré le 20 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 20 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 23 août 2005
    Livré le 05 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 25 févr. 2005
    Livré le 08 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area or piece of ground lying in the burgh of arbroath, county of angus.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 25 févr. 2005
    Livré le 08 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    17-19 commercial road, leven, fife.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 25 févr. 2005
    Livré le 08 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at hume street, montrose, angus.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 25 févr. 2005
    Livré le 08 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    63 marischal street, peterhead.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 11 févr. 2005
    Livré le 24 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 24 févr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 10 févr. 2005
    Livré le 28 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under or in connection with any finance document
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 févr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 18 avr. 2003
    Livré le 24 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liabilities under a senior facilities agreement
    Brèves mentions
    Subjects at kingdom centre, carrick gate, glenrothes.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston
    Transactions
    • 24 avr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 28 mars 2003
    Livré le 04 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Tenants interest in the lease over glenrothes leisure centre,glenrothes.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston as Security Trustee
    Transactions
    • 04 avr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 28 mars 2003
    Livré le 04 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground at arbroath.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston as Security Trustee
    Transactions
    • 04 avr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 28 mars 2003
    Livré le 04 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground at commercial road, leven.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston as Security Trustee
    Transactions
    • 04 avr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 28 mars 2003
    Livré le 04 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground at hume street, montrose.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston as Security Trustee
    Transactions
    • 04 avr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 28 mars 2003
    Livré le 04 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground at maiden street, peterhead.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston as Security Trustee
    Transactions
    • 04 avr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    KINGSWAY ENTERTAINMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 févr. 2014Dissolved on
    24 juil. 2013Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0