CLOCKTOWER EDINBURGH LIMITED

CLOCKTOWER EDINBURGH LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCLOCKTOWER EDINBURGH LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC114525
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CLOCKTOWER EDINBURGH LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe CLOCKTOWER EDINBURGH LIMITED ?

    Adresse du siège social
    7/9 North St. David Street
    EH2 1AW Edinburgh
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CLOCKTOWER EDINBURGH LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WESTBURN PARK LIMITED03 août 198903 août 1989
    CATCHINTER LIMITED16 nov. 198816 nov. 1988

    Quels sont les derniers comptes de CLOCKTOWER EDINBURGH LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CLOCKTOWER EDINBURGH LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CLOCKTOWER EDINBURGH LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Changement d'adresse du siège social de Dolphin House 4 Hunter Square Edinburgh EH1 1QW le 08 avr. 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 déc. 2013

    État du capital au 02 déc. 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes établis au 31 déc. 2012

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Tom Buchanan en tant que directeur le 03 avr. 2013

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    12 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    15 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG03s

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Eric Weir Adair le 19 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Tom Buchanan le 19 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    15 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CLOCKTOWER EDINBURGH LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ADAIR, Eric Weir
    North St. David Street
    EH2 1AW Edinburgh
    7/9
    Scotland
    Administrateur
    North St. David Street
    EH2 1AW Edinburgh
    7/9
    Scotland
    ScotlandBritish116185430001
    BLYTH, William
    Carradale 516 Lanark Road West
    EH14 7DH Balerno
    Midlothian
    Secrétaire
    Carradale 516 Lanark Road West
    EH14 7DH Balerno
    Midlothian
    British514950001
    COCKBURN, David William
    Redbraes
    Venlaw Highroad
    EH45 8RL Peebles
    Secrétaire
    Redbraes
    Venlaw Highroad
    EH45 8RL Peebles
    British79754460001
    MCGOWAN, Carol Ann
    374 Leith Walk
    EH7 4PE Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    374 Leith Walk
    EH7 4PE Edinburgh
    Midlothian
    British112664200001
    WILSON, Mary
    3 Belgrave Road
    EH12 6NG Edinburgh
    Secrétaire
    3 Belgrave Road
    EH12 6NG Edinburgh
    British42188180001
    AITCHISON, Thomas Nisbet
    27 Dudley Terrace
    EH6 4QQ Edinburgh
    Administrateur
    27 Dudley Terrace
    EH6 4QQ Edinburgh
    British43674840001
    ANDERSON, Donald Craig
    39 The Spinney
    EH17 7LE Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    39 The Spinney
    EH17 7LE Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish48629740001
    BLYTH, William
    Carradale 516 Lanark Road West
    EH14 7DH Balerno
    Midlothian
    Administrateur
    Carradale 516 Lanark Road West
    EH14 7DH Balerno
    Midlothian
    British514950001
    BUCHANAN, Tom
    Dolphin House
    4 Hunter Square
    EH1 1QW Edinburgh
    Administrateur
    Dolphin House
    4 Hunter Square
    EH1 1QW Edinburgh
    United KingdomBritish123330960001
    DALGETY, Susan
    16 Temple Park Crescent
    EH11 1HT Edinburgh
    Administrateur
    16 Temple Park Crescent
    EH11 1HT Edinburgh
    British103240003
    DI CIACCA, John Mark
    Jaytu
    Main Road
    KY11 1HA North Queensferry
    Fife
    Administrateur
    Jaytu
    Main Road
    KY11 1HA North Queensferry
    Fife
    United KingdomBritish77111830002
    GEDDES, Keith Taylor
    9 Willowbrae Avenue
    EH8 7HB Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    9 Willowbrae Avenue
    EH8 7HB Edinburgh
    Midlothian
    British975490001
    GORRIE, Donald Cameron Easterbrook
    9 Garscube Terrace
    EH12 6BW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    9 Garscube Terrace
    EH12 6BW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish76140001
    HARKIN, Mark James
    4 Stewart Drive
    Clarkston
    G76 7EZ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    4 Stewart Drive
    Clarkston
    G76 7EZ Glasgow
    Lanarkshire
    British42293490001
    HINDS, Lesley Adelaide
    4 Easter Drylaw Place
    EH4 2QD Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    4 Easter Drylaw Place
    EH4 2QD Edinburgh
    Lothian
    ScotlandBritish3480180001
    HUNTER, Colin Ian
    Stonelaws Farm
    EH40 3DX East Linton
    East Lothian
    Administrateur
    Stonelaws Farm
    EH40 3DX East Linton
    East Lothian
    ScotlandBritish37329910003
    KENNEDY, Sheila
    30 House O'Hill Road
    EH4 2AN Edinburgh
    Administrateur
    30 House O'Hill Road
    EH4 2AN Edinburgh
    British35269940001
    KEREVAN, George
    Brunstane House South Wing
    Brunstane Road South
    EH15 2NQ Edinburgh
    Administrateur
    Brunstane House South Wing
    Brunstane Road South
    EH15 2NQ Edinburgh
    ScotlandBritish660740002
    LOWENBERG, Paul George
    37 Salisbury Road
    EH16 5AA Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    37 Salisbury Road
    EH16 5AA Edinburgh
    Midlothian
    American70889900001
    MCLEOD, Solveig Helene Nilsen
    1 Strathesk Grove
    EH26 8EJ Penicuik
    Midlothian
    Administrateur
    1 Strathesk Grove
    EH26 8EJ Penicuik
    Midlothian
    British85650001
    MCNEILL, John Moncur
    8 Mitchell Street
    EH22 1JQ Dalkeith
    Midlothian
    Administrateur
    8 Mitchell Street
    EH22 1JQ Dalkeith
    Midlothian
    ScotlandBritish57880790001
    PERRY, Ian
    Lilyhill Terrace
    EH8 7DR Edinburgh
    49
    Administrateur
    Lilyhill Terrace
    EH8 7DR Edinburgh
    49
    ScotlandBritish127893650001
    PRINGLE, Michael Stanley Robert
    26 Morningside Park
    EH10 5HB Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Administrateur
    26 Morningside Park
    EH10 5HB Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    ScotlandScottish26173240001
    RICHARD, Christine Margaret
    8 Braid Hills Approach
    EH10 6JY Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    8 Braid Hills Approach
    EH10 6JY Edinburgh
    Midlothian
    British609870001
    ROSS, William
    3 Mayburn Avenue
    EH20 9HA Loanhead
    Midlothian
    Administrateur
    3 Mayburn Avenue
    EH20 9HA Loanhead
    Midlothian
    British763580003
    SEATH, Mary
    5 Wheatfield Road
    EH11 2PT Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    5 Wheatfield Road
    EH11 2PT Edinburgh
    Midlothian
    British1314490001
    SLEIGH, Daphne Mary Walker, Cllr
    8 Buckstone Wood
    EH10 6QW Edinburgh
    Administrateur
    8 Buckstone Wood
    EH10 6QW Edinburgh
    British39647390001
    TURNER, Derrick
    3 Admiral Terrace
    EH10 4JH Edinburgh
    Administrateur
    3 Admiral Terrace
    EH10 4JH Edinburgh
    ScotlandBritish79590200002
    WALL, Ian James, Prof
    85 Warrender Park Road
    EH9 1EW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    85 Warrender Park Road
    EH9 1EW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish430300001

    CLOCKTOWER EDINBURGH LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 05 févr. 2008
    Livré le 14 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Tenants interest in lease between the city of edinburgh council and edinburgh development & investment limited registered under title number MID59765.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Scotland PLC
    Transactions
    • 14 févr. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 05 févr. 2008
    Livré le 14 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Clocktower estate, south gyle crescent, edinburgh MID17874.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Scotland PLC
    Transactions
    • 14 févr. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Bond & floating charge
    Créé le 29 janv. 2008
    Livré le 01 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Scotland PLC
    Transactions
    • 01 févr. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Standard security
    Créé le 07 mai 2004
    Livré le 21 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The long leasehold over the clocktower industrial estate, south gyle, edinburgh MID59765.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 mai 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 07 mai 2004
    Livré le 21 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Property known as the clocktower industrial estate, south gyle, edinburgh MID17874.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 mai 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 22 juil. 1993
    Livré le 11 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    4.87 acres lying to the south of calder road marked area "e" on the plan annexed to disposition by james miller ifo dalbeg developments LTD dated 7TH and recorded grs midlothian 9TH march 1990 under exception.
    Personnes ayant droit
    • Lothian and Edinburgh Enterprise Limited
    Transactions
    • 11 août 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 22 juil. 1993
    Livré le 05 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground extending to 4.87 acres lying to the south of the calder road, currie as relative to dispostion by james miller in favour of dalbeg developments limited.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 août 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 27 juin 1991
    Livré le 17 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    4.87 acres south of calder road, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Enterprise Edinburgh Limited
    Transactions
    • 17 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 20 févr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0