MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC115235 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 201 West George Street C/O Miller Developments G2 2LW Glasgow Lanarkshire Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 avr. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Sutherland le 16 oct. 2020 | 2 pages | CH01 | ||
Notification de Milsut2 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 juil. 2020 | 2 pages | PSC02 | ||
Cessation de F&J Ventures Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 juil. 2020 | 1 pages | PSC07 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 30 avr. 2020 | 10 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 03 mai 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2019 au 30 avr. 2020 | 1 pages | AA01 | ||
Modification des détails de F&J Ventures Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 févr. 2020 | 2 pages | PSC05 | ||
Changement d'adresse du siège social de 201 West George Street C/O Miller Developments Glasgow G2 2LW Scotland à 201 West George Street C/O Miller Developments Glasgow Lanarkshire G2 2LW le 05 févr. 2020 | 1 pages | AD01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL à 201 West George Street C/O Miller Developments Glasgow G2 2LW le 04 févr. 2020 | 1 pages | AD01 | ||
Cessation de Mdl Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 avr. 2019 | 3 pages | PSC07 | ||
Notification de F&J Ventures Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 avr. 2019 | 4 pages | PSC02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 03 mai 2019 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2018 | 12 pages | AA | ||
Changement d'adresse du siège social de Miller House 2 Lochside View Edinburgh Park Edinburgh EH12 9DH à 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL le 25 janv. 2019 | 2 pages | AD01 | ||
Satisfaction de la charge SC1152350004 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2017 | 15 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 03 mai 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2016 | 16 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Euan James Edward Haggerty en tant que directeur le 30 juin 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination d'un directeur | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Kirsty Fraser Macgregor en tant que secrétaire le 31 mai 2017 | 1 pages | TM02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 03 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
Qui sont les dirigeants de MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLOY, David Thomas | Administrateur | West George Street C/O Miller Developments G2 2LW Glasgow 201 Lanarkshire Scotland | Scotland | British | 76474600001 | |||||
| SUTHERLAND, Andrew | Administrateur | West George Street C/O Miller Developments G2 2LW Glasgow 201 Lanarkshire Scotland | Canada | British | 66368290041 | |||||
| DONALDSON, Euan James | Secrétaire | 28 Trainers Brae EH39 4NR North Berwick East Lothian | British | 41273760002 | ||||||
| DUFFIELD, Sheelagh Jane | Secrétaire | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | British | 170591090001 | ||||||
| LAWSON, Gordon Kenneth | Secrétaire | 5 Trench Knowe EH10 7HL Edinburgh | British | 145330001 | ||||||
| MACGREGOR, Kirsty Fraser | Secrétaire | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | 195963090001 | |||||||
| MACKINNON, Iain Lachlan | Secrétaire | 1 Hermitage Drive EH10 6DE Edinburgh | British | 66282570001 | ||||||
| SMYTH, Pamela June | Secrétaire | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | British | 65057960002 | ||||||
| BALLARD, Michael George | Administrateur | 72 Craigleith View EH4 3JY Edinburgh Midlothian | British | 42894290001 | ||||||
| BORLAND, Donald William | Administrateur | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | United Kingdom | British | 66010670002 | |||||
| BRADBURY, Toby Jonathan | Administrateur | Hillsgate Chapel Lane Penistone S36 6AQ Sheffield | British | 55511210001 | ||||||
| CLARK, Alexander Wilson | Administrateur | 44 Birkhill Road Cambusbarron FK7 9JS Stirling Stirlingshire | British | 500420001 | ||||||
| CLARKE, Robert Anthony | Administrateur | 6 The Paddock Sandy Loan EH31 2BW Gullane East Lothian | British | 3221280003 | ||||||
| HAGGERTY, Euan James Edward | Administrateur | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | Scotland | British | 162679260001 | |||||
| HODSDEN, Richard David | Administrateur | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | England | British | 183337930001 | |||||
| IKE, Henry Max | Administrateur | 6 Hutton Close Nether Poppleton YO26 6PJ York North Yorkshire | Dutch | 67313250001 | ||||||
| JACKSON, Julie Mansfield | Administrateur | 31 Inverleith Gardens EH3 5PR Edinburgh | United Kingdom | British | 94193070001 | |||||
| JOHNSTON, Neil William | Administrateur | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | United Kingdom | British | 109876070001 | |||||
| JOHNSTON, Neil William | Administrateur | 12 Winton Gardens EH10 7ET Edinburgh | British | 58059470001 | ||||||
| LAMB, Alan Clive | Administrateur | 17 Chetwynd Road SO16 3JA Southampton Hampshire | British | 61933620001 | ||||||
| MCCULLOCH, Robert Mitchell Ogilvie | Administrateur | The Saplings 16 Church Lane Bardsey LS17 9DN Leeds West Yorkshire | British | 27174530001 | ||||||
| MILLER, Keith Manson | Administrateur | Cherry Hollows 1(B)Easter Belmont Road EH12 6EX Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 546650002 | |||||
| MILLER, Philip Hartley | Administrateur | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | Scotland | British | 28512070005 | |||||
| OGILVIE, Ian | Administrateur | 12 Old Boyne Hill Farm Wood Lane Chapelthorpe WF4 3JL Wakefield West Yorkshire | British | 42582570002 | ||||||
| PEET, Roderick | Administrateur | Laughton House 23 Hailgate, Howden DN14 7SL Goole North Humberside | England | British | 67313470001 | |||||
| RICHARDS, John Steel | Administrateur | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | United Kingdom | British | 1318380002 | |||||
| RICHARDS, John Steel | Administrateur | 21 Lovedale Road EH14 7DW Balerno Glendaruel | United Kingdom | British | 1318380001 | |||||
| SHAW, John Clifford Barratt | Administrateur | Portelet 61 Oldway Drive B91 3HP Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 18542070001 | |||||
| SMYTH, Pamela June | Administrateur | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | Scotland | British | 65057960002 | |||||
| WOOD, Marlene | Administrateur | 15 Ormidale Terrace EH12 6DY Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 31152030002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milsut2 Limited | 30 juil. 2020 | West George Street G2 2LW Glasgow 201 Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| F&J Ventures Limited | 22 avr. 2019 | West George Street C/O Miller Developments G2 2LW Glasgow 201 Lanarkshire Scotland | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mdl Investments Limited | 06 avr. 2016 | 133-137 Alexandra Road Wimbledon SW19 7JY London Connect House United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
MILLER HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 08 oct. 2015 Livré le 14 oct. 2015 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 29 févr. 2012 Livré le 08 mars 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 29 févr. 2012 Livré le 08 mars 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 20 avr. 1999 Livré le 30 avr. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0