HOST EUROPE EIGHT LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | HOST EUROPE EIGHT LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC115367 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HOST EUROPE EIGHT LIMITED ?
| Adresse du siège social | Lomond House 9 George Square G2 1QQ Glasgow |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HOST EUROPE EIGHT LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour HOST EUROPE EIGHT LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire | 3 pages | 4.26(Scot) | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 24 Great King Street Edinburgh Lothian EH3 6QN le 30 oct. 2012 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2010 | 10 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Divers Section 519 | 1 pages | MISC | ||||||||||
Nomination de Mr Tobias Mohr en tant qu'administrateur | 4 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Patrick Pulvermueller en tant qu'administrateur | 4 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Thomas Vollrath en tant qu'administrateur | 4 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de James Shutler en tant que secrétaire | 4 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Rebecca Wotherspoon en tant que secrétaire | 2 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Peter Dubens en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Joseph en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Till en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alexander Collins en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2009 | 12 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 17 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Till le 04 déc. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Alexander Fiske Collins le 04 déc. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark William Joseph le 04 déc. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Ms Rebecca Jane Wotherspoon le 04 déc. 2009 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed webfusion LIMITED\certificate issued on 13/10/09 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de HOST EUROPE EIGHT LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHUTLER, James | Secrétaire | Roundwood Avenue Stockley Park UB11 1FF Uxbridge 5 Middlesex United Kingdom | British | 155592990001 | ||||||
| MOHR, Tobias | Administrateur | 5 Roundwood Avenue Stockley Park UB11 1FF Uxbridge Webfusion Ltd | United Kingdom | German | 133846810002 | |||||
| PULVERMUELLER, Patrick | Administrateur | Welserstrasse 14 D-51149 Koln Host Europe Gmbh Germany | Germany | German | 155584970001 | |||||
| VOLLRATH, Thomas | Administrateur | 5 Roundwood Avenue Stockley Park UB11 1FF Uxbridge Webfusion Ltd. United Kingdom | United Kingdom | German | 155561550001 | |||||
| ANTHONY, John Stuart Frazer | Secrétaire | 62 London Road RG10 9EY Twyford Berkshire | British | 36967410004 | ||||||
| BROCKSOM, Richard Anthony | Secrétaire | 4 Green Bush Lane GU6 8ED Cranleigh Greenbushes Surrey | British | 55078130003 | ||||||
| ERFAN, Mehdi | Secrétaire | Flat 3 190 Randolph Avenue W9 1PE London | British | 65755480001 | ||||||
| GIBSON, Carolyn Ann | Secrétaire | 10 Hanger Hill KT13 9XR Weybridge Surrey | British | 59736770001 | ||||||
| PORTER, Stewart Charles | Secrétaire | Roundwood Avenue Stockley Park UB11 1FF Uxbridge 5 Middlesex | British | 67037910004 | ||||||
| PORTER, Stewart Charles | Secrétaire | 1 Triangle Business Park HP22 5BL Stoke Mandeville Buckinghamshire | British | 67037910002 | ||||||
| WOTHERSPOON, Rebecca Jane | Secrétaire | Floor The Economist Building 25 St James's Street SW1A 1HA London 8th | New Zealander | 134162710001 | ||||||
| PARK CIRCUS REGISTRARS LIMITED | Secrétaire | 6 Park Circus Place G3 6AN Glasgow | 1081300002 | |||||||
| ANTHONY, John Stuart Frazer | Administrateur | 62 London Road RG10 9EY Twyford Berkshire | England | British | 36967410004 | |||||
| ASPINALL, John Damian Androcles | Administrateur | Hastings House Walton Street SW3 1SA London | England | British | 87424600001 | |||||
| BAILEY, Stephen Paul | Administrateur | Hatherwood Cliff Road PO39 0EN Totland Bay Isle Of Wight | United Kingdom | British | 34395930002 | |||||
| BILTON, Anton John Godfrey | Administrateur | 46 Cadogan Place SW1X 9RU London | British | 21454000001 | ||||||
| BLACKALL, Laurence Charles Neil | Administrateur | 2 Ravenna Road Putney SW15 6AW London | United Kingdom | British | 80624810001 | |||||
| BLACKALL, Laurence Charles Neil | Administrateur | 2 Ravenna Road Putney SW15 6AW London | United Kingdom | British | 80624810001 | |||||
| BROCKSOM, Richard Anthony | Administrateur | 4 Green Bush Lane GU6 8ED Cranleigh Greenbushes Surrey | England | British | 55078130003 | |||||
| CHRISTIE-MILLER, Stephen | Administrateur | Woodside Farm Cottage North Sydmonton RG15 9EA Newbury Berkshire | British | 60511430002 | ||||||
| COLLINS, Alexander Fiske | Administrateur | Floor, The Economist Building 25 St. James's Street SW1A 1HA London 8th United Kingdom | United Kingdom | Italian | 135884520001 | |||||
| CROLLA, Dominic | Administrateur | 139 Bennerley Road SW11 6DX London | British | 77528060001 | ||||||
| DUBENS, Peter Adam Daiches | Administrateur | The Economist Building 8th Floor 25 St Jamess Street SW1A 1HA London | Switzerland | British | 153016810001 | |||||
| DUBENS, Peter Adam Daiches | Administrateur | The Economist Building 8th Floor 25 St Jamess Street SW1A 1HA London | Switzerland | British | 153016810001 | |||||
| IRVINE, Nicholas Maxwell | Administrateur | Lavender House Andrew Hill Lane Hedgerley SL2 3UL Slough Berkshire | British | 37623510002 | ||||||
| JOSEPH, Mark William | Administrateur | Floor, The Economist Building 25 St. James's Street SW1A 1HA London 8th | England | British | 72405460001 | |||||
| LAUGHLAND, Hugh William | Administrateur | Higher Stratton Stratton Chase Drive HP8 4NS Chalfont-St-Giles Buckinghamshire | British | 520530002 | ||||||
| MCLEOD, Robert | Administrateur | 43 Wandsworth Bridge Road SW6 2TB London | United Kingdom | British | 54135390001 | |||||
| MOIR, Charles Clement | Administrateur | Gaddesden Place HP2 6EX Hemel Hempstead Hertfordshire | England | British | 17509020001 | |||||
| MURRAY OBODYNSKI, Jan Andrew | Administrateur | Les Bouleaux Rohais De Bas GY6 8YZ St Andrews Guernsey Channel Islands | British | 51638380001 | ||||||
| MURRAY OBODYNSKI, Richard Alan | Administrateur | Venture House Davis Road KT9 1TT Chessington Surrey | British | 46792500001 | ||||||
| PEREIRA, Alan Dennis | Administrateur | 61 Elsenham Street SW18 5NX London | British | 61856670001 | ||||||
| PORTER, Stewart Charles | Administrateur | Roundwood Avenue Stockley Park UB11 1FF Uxbridge 5 Middlesex | British | 67037910004 | ||||||
| PURVIS, Grahame Robert | Administrateur | 21 Leydene Park GU32 1HF East Meon Hampshire | United Kingdom | United Kingdom | 113467720001 | |||||
| READ, Michael David | Administrateur | Roundwood Avenue Stockley Park UB11 1FF Uxbridge 5 Middlesex | United Kingdom | British | 81004070007 |
HOST EUROPE EIGHT LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Créé le 15 sept. 2006 Livré le 04 oct. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage all estates and interests in the freehold and leasehold property including fixed charges and floating charge - see form 410 paper apart 2 for full details. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 15 sept. 2006 Livré le 04 oct. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 04 nov. 2004 Livré le 16 nov. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 04 nov. 2004 Livré le 16 nov. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 31 oct. 2003 Livré le 11 nov. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 14 oct. 1999 Livré le 29 oct. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed charges over assets; floating charge over same. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Floating charge | Créé le 14 oct. 1999 Livré le 29 oct. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed charge over assets; floating charge over same. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 28 mai 1998 Livré le 16 juin 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Floating charge | Créé le 09 janv. 1997 Livré le 28 janv. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over 2 green street,london. See the mortgage charge document for full details. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 20 mars 1996 Livré le 27 mars 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 157 fernhead road,london W9. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 14 mars 1996 Livré le 20 mars 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over 41 sulgrave road,shepherds bush,london & fixed and floating charges relating to the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 14 mars 1996 Livré le 20 mars 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over 33 auckland road,wandsworth,london & fixed and floating charges over property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 14 mars 1996 Livré le 20 mars 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over flat b,157 fernhead road,westminster,london. Fixed & floating charges-see ch microfiche. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 14 mars 1996 Livré le 20 mars 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over 52 harwood road,fulham,london. Fixed and floatingcharges-see ch microfiche. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 14 mars 1996 Livré le 20 mars 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over 166 fernhead road,maida vale,london.fixed & floating charges-see ch microfiche. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 14 mars 1996 Livré le 20 mars 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over 51 penge road,south norwood,croydon.fixed & floating charges-see ch microfiche. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 14 mars 1996 Livré le 20 mars 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over 15 anderson street,chelsea,london & fixed & floating charge-see ch microfiche. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 14 mars 1996 Livré le 20 mars 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over 87 finborough road,london and fixed and floating charge-see ch microfiche. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 08 févr. 1996 Livré le 21 févr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All assets of the company. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 08 févr. 1996 Livré le 16 févr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over flat 5, 75 woodbourne avenue, lambeth, london, registered under title number tgl 107559, fixed charges over plant, goodwill, etc., and a floating charge over plant, etc....... see ch microfiche for full details. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 08 févr. 1996 Livré le 16 févr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over flat 4, 75 woodbourne avenue, lambeth, london, registered under title number tgl 107558, fixed charges over plant, goodwill, etc., and a floating charge over plant, etc....... see ch microfiche for full details. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 08 févr. 1996 Livré le 16 févr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over flat 3, 75 woodbourne avenue, lambeth, london, registered under title number tgl 107557, fixed charges over plant, goodwill, etc., and a floating charge over plant, etc....... see ch microfiche for full details. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 08 févr. 1996 Livré le 16 févr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over 23 malvern road, london, registered under title number ngl 668743, fixed charges over plant, goodwill, etc., and a floating charge over plant, etc....... see ch microfiche for full details. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 08 févr. 1996 Livré le 16 févr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over 23 albert square, london, registered under title number 197071, fixed charges over plant, goodwill, etc., and a floating charge over plant, etc....... see ch microfiche for full details. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 08 févr. 1996 Livré le 16 févr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over 11B mentone mansions, fulham road, london, registered under title number bgl 1359, fixed charges over plant, goodwill, etc., and a floating charge over plant, etc....... see ch microfiche for full details. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
HOST EUROPE EIGHT LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0