HOST EUROPE EIGHT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHOST EUROPE EIGHT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC115367
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HOST EUROPE EIGHT LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe HOST EUROPE EIGHT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Lomond House
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HOST EUROPE EIGHT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WEBFUSION LIMITED08 avr. 200908 avr. 2009
    GXN LIMITED06 mars 200306 mars 2003
    GX NETWORKS LIMITED23 juil. 200223 juil. 2002
    GX NETWORKS ONE LIMITED11 avr. 200211 avr. 2002
    XO LIMITED01 nov. 200001 nov. 2000
    CONCENTRIC NETWORK HOLDINGS LIMITED10 févr. 200010 févr. 2000
    INTERNET TECHNOLOGY GROUP PLC17 sept. 199617 sept. 1996
    CAPITAL & WESTERN ESTATES PLC28 déc. 198828 déc. 1988

    Quels sont les derniers comptes de HOST EUROPE EIGHT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour HOST EUROPE EIGHT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 24 Great King Street Edinburgh Lothian EH3 6QN le 30 oct. 2012

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 19 oct. 2012

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 juil. 2012

    État du capital au 26 juil. 2012

    • Capital: GBP 11,235,284.4
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2010

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Divers

    Section 519
    1 pagesMISC

    Nomination de Mr Tobias Mohr en tant qu'administrateur

    4 pagesAP01

    Nomination de Patrick Pulvermueller en tant qu'administrateur

    4 pagesAP01

    Nomination de Mr Thomas Vollrath en tant qu'administrateur

    4 pagesAP01

    Nomination de James Shutler en tant que secrétaire

    4 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Rebecca Wotherspoon en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Peter Dubens en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mark Joseph en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Till en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alexander Collins en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Till le 04 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Alexander Fiske Collins le 04 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark William Joseph le 04 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Ms Rebecca Jane Wotherspoon le 04 déc. 2009

    1 pagesCH03

    Certificat de changement de nom

    Company name changed webfusion LIMITED\certificate issued on 13/10/09
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name13 oct. 2009

    Avis de changement de nom"

    CONNOT

    Qui sont les dirigeants de HOST EUROPE EIGHT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHUTLER, James
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    United Kingdom
    Secrétaire
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    United Kingdom
    British155592990001
    MOHR, Tobias
    5 Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    Webfusion Ltd
    Administrateur
    5 Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    Webfusion Ltd
    United KingdomGerman133846810002
    PULVERMUELLER, Patrick
    Welserstrasse 14
    D-51149 Koln
    Host Europe Gmbh
    Germany
    Administrateur
    Welserstrasse 14
    D-51149 Koln
    Host Europe Gmbh
    Germany
    GermanyGerman155584970001
    VOLLRATH, Thomas
    5 Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    Webfusion Ltd.
    United Kingdom
    Administrateur
    5 Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    Webfusion Ltd.
    United Kingdom
    United KingdomGerman155561550001
    ANTHONY, John Stuart Frazer
    62 London Road
    RG10 9EY Twyford
    Berkshire
    Secrétaire
    62 London Road
    RG10 9EY Twyford
    Berkshire
    British36967410004
    BROCKSOM, Richard Anthony
    4 Green Bush Lane
    GU6 8ED Cranleigh
    Greenbushes
    Surrey
    Secrétaire
    4 Green Bush Lane
    GU6 8ED Cranleigh
    Greenbushes
    Surrey
    British55078130003
    ERFAN, Mehdi
    Flat 3
    190 Randolph Avenue
    W9 1PE London
    Secrétaire
    Flat 3
    190 Randolph Avenue
    W9 1PE London
    British65755480001
    GIBSON, Carolyn Ann
    10 Hanger Hill
    KT13 9XR Weybridge
    Surrey
    Secrétaire
    10 Hanger Hill
    KT13 9XR Weybridge
    Surrey
    British59736770001
    PORTER, Stewart Charles
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    Secrétaire
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    British67037910004
    PORTER, Stewart Charles
    1 Triangle Business Park
    HP22 5BL Stoke Mandeville
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    1 Triangle Business Park
    HP22 5BL Stoke Mandeville
    Buckinghamshire
    British67037910002
    WOTHERSPOON, Rebecca Jane
    Floor
    The Economist Building 25 St James's Street
    SW1A 1HA London
    8th
    Secrétaire
    Floor
    The Economist Building 25 St James's Street
    SW1A 1HA London
    8th
    New Zealander134162710001
    PARK CIRCUS REGISTRARS LIMITED
    6 Park Circus Place
    G3 6AN Glasgow
    Secrétaire
    6 Park Circus Place
    G3 6AN Glasgow
    1081300002
    ANTHONY, John Stuart Frazer
    62 London Road
    RG10 9EY Twyford
    Berkshire
    Administrateur
    62 London Road
    RG10 9EY Twyford
    Berkshire
    EnglandBritish36967410004
    ASPINALL, John Damian Androcles
    Hastings House
    Walton Street
    SW3 1SA London
    Administrateur
    Hastings House
    Walton Street
    SW3 1SA London
    EnglandBritish87424600001
    BAILEY, Stephen Paul
    Hatherwood
    Cliff Road
    PO39 0EN Totland Bay
    Isle Of Wight
    Administrateur
    Hatherwood
    Cliff Road
    PO39 0EN Totland Bay
    Isle Of Wight
    United KingdomBritish34395930002
    BILTON, Anton John Godfrey
    46 Cadogan Place
    SW1X 9RU London
    Administrateur
    46 Cadogan Place
    SW1X 9RU London
    British21454000001
    BLACKALL, Laurence Charles Neil
    2 Ravenna Road
    Putney
    SW15 6AW London
    Administrateur
    2 Ravenna Road
    Putney
    SW15 6AW London
    United KingdomBritish80624810001
    BLACKALL, Laurence Charles Neil
    2 Ravenna Road
    Putney
    SW15 6AW London
    Administrateur
    2 Ravenna Road
    Putney
    SW15 6AW London
    United KingdomBritish80624810001
    BROCKSOM, Richard Anthony
    4 Green Bush Lane
    GU6 8ED Cranleigh
    Greenbushes
    Surrey
    Administrateur
    4 Green Bush Lane
    GU6 8ED Cranleigh
    Greenbushes
    Surrey
    EnglandBritish55078130003
    CHRISTIE-MILLER, Stephen
    Woodside Farm Cottage
    North Sydmonton
    RG15 9EA Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Woodside Farm Cottage
    North Sydmonton
    RG15 9EA Newbury
    Berkshire
    British60511430002
    COLLINS, Alexander Fiske
    Floor, The Economist Building
    25 St. James's Street
    SW1A 1HA London
    8th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor, The Economist Building
    25 St. James's Street
    SW1A 1HA London
    8th
    United Kingdom
    United KingdomItalian135884520001
    CROLLA, Dominic
    139 Bennerley Road
    SW11 6DX London
    Administrateur
    139 Bennerley Road
    SW11 6DX London
    British77528060001
    DUBENS, Peter Adam Daiches
    The Economist Building
    8th Floor 25 St Jamess Street
    SW1A 1HA London
    Administrateur
    The Economist Building
    8th Floor 25 St Jamess Street
    SW1A 1HA London
    SwitzerlandBritish153016810001
    DUBENS, Peter Adam Daiches
    The Economist Building
    8th Floor 25 St Jamess Street
    SW1A 1HA London
    Administrateur
    The Economist Building
    8th Floor 25 St Jamess Street
    SW1A 1HA London
    SwitzerlandBritish153016810001
    IRVINE, Nicholas Maxwell
    Lavender House
    Andrew Hill Lane Hedgerley
    SL2 3UL Slough
    Berkshire
    Administrateur
    Lavender House
    Andrew Hill Lane Hedgerley
    SL2 3UL Slough
    Berkshire
    British37623510002
    JOSEPH, Mark William
    Floor, The Economist Building
    25 St. James's Street
    SW1A 1HA London
    8th
    Administrateur
    Floor, The Economist Building
    25 St. James's Street
    SW1A 1HA London
    8th
    EnglandBritish72405460001
    LAUGHLAND, Hugh William
    Higher Stratton
    Stratton Chase Drive
    HP8 4NS Chalfont-St-Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Higher Stratton
    Stratton Chase Drive
    HP8 4NS Chalfont-St-Giles
    Buckinghamshire
    British520530002
    MCLEOD, Robert
    43 Wandsworth Bridge Road
    SW6 2TB London
    Administrateur
    43 Wandsworth Bridge Road
    SW6 2TB London
    United KingdomBritish54135390001
    MOIR, Charles Clement
    Gaddesden Place
    HP2 6EX Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Administrateur
    Gaddesden Place
    HP2 6EX Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    EnglandBritish17509020001
    MURRAY OBODYNSKI, Jan Andrew
    Les Bouleaux
    Rohais De Bas
    GY6 8YZ St Andrews
    Guernsey
    Channel Islands
    Administrateur
    Les Bouleaux
    Rohais De Bas
    GY6 8YZ St Andrews
    Guernsey
    Channel Islands
    British51638380001
    MURRAY OBODYNSKI, Richard Alan
    Venture House
    Davis Road
    KT9 1TT Chessington
    Surrey
    Administrateur
    Venture House
    Davis Road
    KT9 1TT Chessington
    Surrey
    British46792500001
    PEREIRA, Alan Dennis
    61 Elsenham Street
    SW18 5NX London
    Administrateur
    61 Elsenham Street
    SW18 5NX London
    British61856670001
    PORTER, Stewart Charles
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    Administrateur
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    British67037910004
    PURVIS, Grahame Robert
    21 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    Administrateur
    21 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    United KingdomUnited Kingdom113467720001
    READ, Michael David
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    Administrateur
    Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1FF Uxbridge
    5
    Middlesex
    United KingdomBritish81004070007

    HOST EUROPE EIGHT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 15 sept. 2006
    Livré le 04 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage all estates and interests in the freehold and leasehold property including fixed charges and floating charge - see form 410 paper apart 2 for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 oct. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 15 sept. 2006
    Livré le 04 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 oct. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 04 nov. 2004
    Livré le 16 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transactions
    • 16 nov. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 04 nov. 2004
    Livré le 16 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transactions
    • 16 nov. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 31 oct. 2003
    Livré le 11 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 nov. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 14 oct. 1999
    Livré le 29 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Concentric Network Corporation
    Transactions
    • 29 oct. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 oct. 1999Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 14 oct. 1999
    Livré le 29 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed charge over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Concentric Network Corporation
    Transactions
    • 29 oct. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 oct. 1999Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 28 mai 1998
    Livré le 16 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Mci Worldcom Limited
    Transactions
    • 16 juin 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 oct. 1999Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 06 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 09 janv. 1997
    Livré le 28 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 2 green street,london. See the mortgage charge document for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 janv. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 20 mars 1996
    Livré le 27 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    157 fernhead road,london W9.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 mars 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 14 mars 1996
    Livré le 20 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 41 sulgrave road,shepherds bush,london & fixed and floating charges relating to the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 mars 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 14 mars 1996
    Livré le 20 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 33 auckland road,wandsworth,london & fixed and floating charges over property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 mars 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 14 mars 1996
    Livré le 20 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over flat b,157 fernhead road,westminster,london. Fixed & floating charges-see ch microfiche.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 mars 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 14 mars 1996
    Livré le 20 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 52 harwood road,fulham,london. Fixed and floatingcharges-see ch microfiche.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 mars 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 14 mars 1996
    Livré le 20 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 166 fernhead road,maida vale,london.fixed & floating charges-see ch microfiche.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 mars 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 14 mars 1996
    Livré le 20 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 51 penge road,south norwood,croydon.fixed & floating charges-see ch microfiche.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 mars 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 14 mars 1996
    Livré le 20 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 15 anderson street,chelsea,london & fixed & floating charge-see ch microfiche.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 mars 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 14 mars 1996
    Livré le 20 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 87 finborough road,london and fixed and floating charge-see ch microfiche.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 mars 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 08 févr. 1996
    Livré le 21 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 févr. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 08 févr. 1996
    Livré le 16 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over flat 5, 75 woodbourne avenue, lambeth, london, registered under title number tgl 107559, fixed charges over plant, goodwill, etc., and a floating charge over plant, etc....... see ch microfiche for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 févr. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 08 févr. 1996
    Livré le 16 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over flat 4, 75 woodbourne avenue, lambeth, london, registered under title number tgl 107558, fixed charges over plant, goodwill, etc., and a floating charge over plant, etc....... see ch microfiche for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 févr. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 08 févr. 1996
    Livré le 16 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over flat 3, 75 woodbourne avenue, lambeth, london, registered under title number tgl 107557, fixed charges over plant, goodwill, etc., and a floating charge over plant, etc....... see ch microfiche for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 févr. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 08 févr. 1996
    Livré le 16 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 23 malvern road, london, registered under title number ngl 668743, fixed charges over plant, goodwill, etc., and a floating charge over plant, etc....... see ch microfiche for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 févr. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 08 févr. 1996
    Livré le 16 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 23 albert square, london, registered under title number 197071, fixed charges over plant, goodwill, etc., and a floating charge over plant, etc....... see ch microfiche for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 févr. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 08 févr. 1996
    Livré le 16 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 11B mentone mansions, fulham road, london, registered under title number bgl 1359, fixed charges over plant, goodwill, etc., and a floating charge over plant, etc....... see ch microfiche for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 févr. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    HOST EUROPE EIGHT LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 oct. 2012Commencement of winding up
    16 avr. 2013Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0