TULLOCH HOMES (SCOTLAND) LIMITED

TULLOCH HOMES (SCOTLAND) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTULLOCH HOMES (SCOTLAND) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC116471
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TULLOCH HOMES (SCOTLAND) LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe TULLOCH HOMES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    7-11 Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TULLOCH HOMES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PLOTFRONT LIMITED28 févr. 198928 févr. 1989

    Quels sont les derniers comptes de TULLOCH HOMES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour TULLOCH HOMES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    5 pages4.26(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de Stoneyfield House Stoneyfield Business Park Inverness IV2 7PA à 7-11 Melville Street Edinburgh EH3 7PE le 02 mai 2017

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 18 avr. 2017

    LRESSP

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 08 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016

    8 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2015

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 janv. 2016

    État du capital au 08 janv. 2016

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Alexander James Grant le 07 janv. 2016

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Alexander James Grant le 02 juil. 2015

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2014

    9 pagesAA

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 janv. 2015

    État du capital au 08 janv. 2015

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 janv. 2014

    État du capital au 08 janv. 2014

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2012

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de James Cameron en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de TULLOCH HOMES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FRASER, George Gabriel
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    7-11
    Administrateur
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    7-11
    ScotlandBritish50219540001
    GRANT, Alexander James
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    7-11
    Administrateur
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    7-11
    United KingdomBritish113195780003
    CAMERON, James
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Stoneyfield House
    Secrétaire
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Stoneyfield House
    British166633750001
    CAMPBELL, Gary Angus
    Clach Na Sanais
    Croy
    IV1 2PG Inverness
    Secrétaire
    Clach Na Sanais
    Croy
    IV1 2PG Inverness
    British44913110001
    MACDONALD, Ronald Sutherland
    135 Stewarton Drive
    G72 8DH Cambuslang
    Secrétaire
    135 Stewarton Drive
    G72 8DH Cambuslang
    British145418810001
    STEWART, Katherine M
    22 Edgemoor Park
    Balloch
    IV1 2RB Inverness
    Inverness Shire
    Secrétaire
    22 Edgemoor Park
    Balloch
    IV1 2RB Inverness
    Inverness Shire
    British565690001
    SUTHERLAND, Caroline Anne
    Slackbuie Way
    Fairways
    IV2 6AT Inverness
    29
    United Kingdom
    Secrétaire
    Slackbuie Way
    Fairways
    IV2 6AT Inverness
    29
    United Kingdom
    British87534020003
    SUTHERLAND, David Fraser
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    Secrétaire
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    British1321720003
    TRACE, Marjory Bremner
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    Secrétaire
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    British43522850004
    ASH, Christine Ann
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    British67480001
    CAMERON, Neil Stuart
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    Administrateur
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    ScotlandBritish34848670001
    CAMPBELL, Duncan John
    14 Cameron Street
    KY12 8DP Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    14 Cameron Street
    KY12 8DP Dunfermline
    Fife
    British19349880001
    CLINTON, David
    213 Westburn Road
    AB2 4QF Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    213 Westburn Road
    AB2 4QF Aberdeen
    Aberdeenshire
    British30279690001
    COOPER, Hilary Joan
    187 Prospect Road
    YO12 7LE Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    187 Prospect Road
    YO12 7LE Scarborough
    North Yorkshire
    British51307940001
    MACDONALD, Ronald Sutherland
    135 Stewarton Drive
    G72 8DH Cambuslang
    Administrateur
    135 Stewarton Drive
    G72 8DH Cambuslang
    United KingdomBritish145418810001
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    MONKS, Charles
    116 Vere Road
    Blackwood
    ML11 9QF Lanark
    Midlothian
    Administrateur
    116 Vere Road
    Blackwood
    ML11 9QF Lanark
    Midlothian
    ScotlandBritish62550910001
    STEWART, Katherine M
    22 Edgemoor Park
    Balloch
    IV1 2RB Inverness
    Inverness Shire
    Administrateur
    22 Edgemoor Park
    Balloch
    IV1 2RB Inverness
    Inverness Shire
    British565690001
    SUTHERLAND, David Fraser
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    Administrateur
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    ScotlandBritish1321720003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TULLOCH HOMES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Stoneyfield House
    Scotland
    06 avr. 2016
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Stoneyfield House
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc496362
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    TULLOCH HOMES (SCOTLAND) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 10 déc. 2009
    Livré le 21 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotyland PLC
    Transactions
    • 21 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 12 nov. 1997
    Livré le 19 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 nov. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 25 sept. 1996
    Livré le 04 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 oct. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 15 sept. 1994
    Livré le 05 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot 2C of the residential sites at newcarron village lying to the west of carron road, falkirk as relative to title number stg 5923.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 oct. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 10 juin 1993
    Livré le 28 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot 2, new carron village, falkirk.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 juin 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 01 avr. 1993
    Livré le 16 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot 2 new carron village falkirk.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 avr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 nov. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 12 avr. 1991
    Livré le 19 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1.141 ha at aberdour.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 25 janv. 1991
    Livré le 04 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    5.44 acres west of carron road falkirk.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 14 sept. 1990
    Livré le 25 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.218 acre northeast side of public road doune to dunblane.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 18 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 09 août 1990
    Livré le 22 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground at airthrey road, causewayhead, stirling.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 18 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 19 déc. 1989
    Livré le 29 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    • 18 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 06 déc. 1989
    Livré le 13 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.218 acre northeastside of public road from doune to dunblane.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)

    TULLOCH HOMES (SCOTLAND) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    12 mars 2019Dissolved on
    18 avr. 2017Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0