SCOTTISH METROPOLITAN DEVELOPMENTS LIMITED

SCOTTISH METROPOLITAN DEVELOPMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSCOTTISH METROPOLITAN DEVELOPMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC116755
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SCOTTISH METROPOLITAN DEVELOPMENTS LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe SCOTTISH METROPOLITAN DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    ERNST & YOUNG LLP
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SCOTTISH METROPOLITAN DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BOURNE DEVELOPMENTS LIMITED09 août 198909 août 1989
    WIDERIG LIMITED13 mars 198913 mars 1989

    Quels sont les derniers comptes de SCOTTISH METROPOLITAN DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour SCOTTISH METROPOLITAN DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA le 30 sept. 2011

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 14 sept. 2011

    LRESSP

    Nomination de Mr Stephen Roy Slocombe en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Manuel Uria Fernandez en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ian Gatiss en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    État du capital au 20 déc. 2010

    • Capital: GBP 2
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Modification des coordonnées de l'administrateur Thomas Marfleet le 11 oct. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Manuel Uria Fernandez le 11 oct. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ian William Gatiss le 11 oct. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Stephen Roy Slocombe le 11 oct. 2010

    2 pagesCH03

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    13 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    28 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    16 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Stephen Roy Slocombe le 01 déc. 2009

    3 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Thomas Marfleet le 03 nov. 2009

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ian William Gatiss le 03 nov. 2009

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Manuel Uria Fernandez le 02 nov. 2009

    3 pagesCH01

    legacy

    4 pages288a

    Qui sont les dirigeants de SCOTTISH METROPOLITAN DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SLOCOMBE, Stephen Roy
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Secrétaire
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    British55097590003
    MARFLEET, Thomas
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish139855250001
    SLOCOMBE, Stephen Roy
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomEnglish151593900001
    BAMBER, Janine Margaret
    Flat 16 St Pauls View
    15 Amwell Street
    EC1R 1UP London
    Secrétaire
    Flat 16 St Pauls View
    15 Amwell Street
    EC1R 1UP London
    British117898690001
    BEWSEY, Martin Roy
    16 Hawthorne Road
    BR1 2HH Bromley
    Kent
    Secrétaire
    16 Hawthorne Road
    BR1 2HH Bromley
    Kent
    British88472130001
    BROWN, David Allan
    Royal Exchange House 100 Queen Street
    G1 3DL Glasgow
    Secrétaire
    Royal Exchange House 100 Queen Street
    G1 3DL Glasgow
    British37710002
    BROWN, Grace
    35 Corringham Road
    Wembley Park
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    Secrétaire
    35 Corringham Road
    Wembley Park
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    British102074060001
    KEARLEY, Andrew Paul
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    Secrétaire
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    British26039210001
    PARSONS-WEISS, Beatrix
    Meadow Cottage
    Hawksfold Lane
    GU27 3JW Fernhurst
    Surrey
    Secrétaire
    Meadow Cottage
    Hawksfold Lane
    GU27 3JW Fernhurst
    Surrey
    German93618170002
    THOMSON, Alan Herbert
    South Hill Of Dripps Cottage
    Thorntonhall
    G74 5AW Glasgow
    Secrétaire
    South Hill Of Dripps Cottage
    Thorntonhall
    G74 5AW Glasgow
    British293000001
    ABRAMSON, Christoffer
    59 Queen Anne Street
    W1G 9JS London
    Administrateur
    59 Queen Anne Street
    W1G 9JS London
    Swedish98463110004
    BARTRAM, Christopher John
    15 Trumpington Road
    CB2 2AJ Cambridge
    Administrateur
    15 Trumpington Road
    CB2 2AJ Cambridge
    EnglandBritish38758710002
    BIRCH, Paul Adrian
    Gorselands
    PA11 3AT Bridge Of Weir
    Administrateur
    Gorselands
    PA11 3AT Bridge Of Weir
    ScotlandBritish772720001
    BIRTWISTLE, David
    184 Upper Woodcote Road
    Caversham
    RG4 7JU Reading
    Berkshire
    Administrateur
    184 Upper Woodcote Road
    Caversham
    RG4 7JU Reading
    Berkshire
    British947020001
    BOTHA, Stephanie
    5 Highbridge Wharf
    Highbridge
    SE10 9PS London
    Administrateur
    5 Highbridge Wharf
    Highbridge
    SE10 9PS London
    American116663740001
    CAIRNS, James Scott
    2 Springfield Grange
    Blackness Road
    EH49 7HA Linlithgow
    West Lothian
    Administrateur
    2 Springfield Grange
    Blackness Road
    EH49 7HA Linlithgow
    West Lothian
    British33041530001
    CASEY, Shay Andrew
    Flat 3 St Mary Hall
    106 Felsham Road
    SW15 1DQ London
    Administrateur
    Flat 3 St Mary Hall
    106 Felsham Road
    SW15 1DQ London
    United KingdomIrish90824990003
    DEBNEY, Richard Johnathon
    81 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9XG London
    Administrateur
    81 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9XG London
    EnglandBritish59232720003
    DEL BEATO, Ilaria Jane
    33 Gorst Road
    Battersea
    SW11 6JB London
    Administrateur
    33 Gorst Road
    Battersea
    SW11 6JB London
    United KingdomBritish93124450002
    FELCE, Gary John
    25 Ickwell Road
    Northill
    SG18 9AB Biggleswade
    Bedfordshire
    Administrateur
    25 Ickwell Road
    Northill
    SG18 9AB Biggleswade
    Bedfordshire
    EnglandBritish107819460001
    GATISS, Ian William
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    EnglandBritish95094220003
    HARRIS, Neil Jason
    Pattison Lane
    Woolstone
    MK15 0AU Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Pattison Lane
    Woolstone
    MK15 0AU Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    EnglandBritish94095660004
    JONES, Robert
    Sideways 38 Bath Road
    Thatcham
    RG13 4SX Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Sideways 38 Bath Road
    Thatcham
    RG13 4SX Newbury
    Berkshire
    British1207330001
    KEARLEY, Andrew Paul
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    Administrateur
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    British26039210001
    LEE, David Robert
    139 Ascot Crescent
    SG1 5SX Stevenage
    Hertfordshire
    Administrateur
    139 Ascot Crescent
    SG1 5SX Stevenage
    Hertfordshire
    British76032910001
    LEWIS, Martyn Phillips
    Wyncroft
    Ringmore
    TQ7 4HL Kingsbridge
    Devon
    Administrateur
    Wyncroft
    Ringmore
    TQ7 4HL Kingsbridge
    Devon
    EnglandBritish96177720001
    MCGREGOR, John Gregg
    Brook Lodge The Street
    North Stoke
    OX10 6BL Wallingford
    Oxfordshire
    Administrateur
    Brook Lodge The Street
    North Stoke
    OX10 6BL Wallingford
    Oxfordshire
    British946660001
    MILNE, Gordon Stewart
    5 Woodhall Road
    Colinton
    EH13 0DQ Edinburgh
    Administrateur
    5 Woodhall Road
    Colinton
    EH13 0DQ Edinburgh
    British39048480001
    PEARSON, William James
    Graham Road
    Wimbledon
    SW19 3SL London
    171
    Administrateur
    Graham Road
    Wimbledon
    SW19 3SL London
    171
    United KingdomBritish133539850001
    THOMSON, Albert Herbert
    South Hill Of Drips Cottage
    Peel Road
    Thorntonhall
    Glasgow
    Administrateur
    South Hill Of Drips Cottage
    Peel Road
    Thorntonhall
    Glasgow
    British1207320001
    URIA FERNANDEZ, Manuel
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomSpanish123133150001
    WALTON, David
    4 Methven Road
    Whitecraigs
    G46 6TG Glasgow
    Strathclyde
    Administrateur
    4 Methven Road
    Whitecraigs
    G46 6TG Glasgow
    Strathclyde
    ScotlandBritish37720001

    SCOTTISH METROPOLITAN DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 06 janv. 2003
    Livré le 13 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground lying to the north of arbroath road, broughty ferry, angus.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 janv. 2003
    Livré le 13 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land on the east side of renfrew road, paisley--title number REN89221.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Fixed security document
    Créé le 16 déc. 2002
    Livré le 23 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed charges over property( by way of first legal mortgage); other assets by way of fixed charges (see schedule for full definitions).
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 déc. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 09 janv. 2001
    Livré le 24 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The obligations as contained in the agreement
    Brèves mentions
    Freehold land relating to the former manweb hq at sealan road, chester containing 8.99 acres.
    Personnes ayant droit
    • Manweb PLC
    Transactions
    • 24 janv. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 04 oct. 1991
    Livré le 18 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Trustee
    Transactions
    • 18 oct. 1991Enregistrement d'une charge
    • 22 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 04 oct. 1991
    Livré le 22 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Scottish Metropolitan Property PLC
    Transactions
    • 22 oct. 1991Enregistrement d'une charge
    • 13 mai 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Fixed and debenture floating charge
    Créé le 22 mai 1989
    Livré le 09 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    See page two of document 6593.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Scottish Metropolital Property PLC
    Transactions
    • 09 juin 1989Enregistrement d'une charge

    SCOTTISH METROPOLITAN DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    17 avr. 2012Dissolved on
    14 sept. 2011Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0