PEARL ALH LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPEARL ALH LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC117118
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PEARL ALH LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe PEARL ALH LIMITED ?

    Adresse du siège social
    G1 5 George Square
    G2 1DY Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PEARL ALH LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RESOLUTION ALH LIMITED18 avr. 200718 avr. 2007
    ALBA LIFE HOLDINGS LIMITED07 déc. 199907 déc. 1999
    BRITANNIA LIFE HOLDINGS LIMITED 02 janv. 199502 janv. 1995
    BRITANNIA LIFE LIMITED31 mars 198931 mars 1989

    Quels sont les derniers comptes de PEARL ALH LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour PEARL ALH LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 29 nov. 2011

    LRESSP

    Changement d'adresse du siège social de 301 st Vincent Street Glasgow G2 5HN le 14 déc. 2011

    2 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 sept. 2011

    État du capital au 02 sept. 2011

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew Moss le 15 mars 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael John Merrick le 05 mars 2010

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    12 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    12 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    Statuts

    17 pagesMA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed resolution alh LIMITED\certificate issued on 13/05/08
    3 pagesCERTNM

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    8 pages363a

    Qui sont les dirigeants de PEARL ALH LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PEARL GROUP SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    Secrétaire
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    115204320002
    MERRICK, Michael John
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    EnglandBritish74114060001
    MOSS, Andrew
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    United KingdomBritish151524430001
    GRIFFIN-SMITH, Philip Bernard
    The Rickyard
    CV23 0JN Easenhall
    7
    Warwickshire
    Secrétaire
    The Rickyard
    CV23 0JN Easenhall
    7
    Warwickshire
    British130189950001
    JORDAN, Barbara Craig
    8 Rosemount Meadows
    Bothwell
    G71 8EL Glasgow
    Secrétaire
    8 Rosemount Meadows
    Bothwell
    G71 8EL Glasgow
    British80291020001
    KELLY, Malcolm James, Mr.
    Balade, 9 Hazel Avenue
    Lenzie
    G66 4RR Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    Balade, 9 Hazel Avenue
    Lenzie
    G66 4RR Glasgow
    Lanarkshire
    British103788380001
    RANKIN, Colin Graham
    Spottiswoode
    Sandy Road
    KA23 9NN Seamill
    Ayrshire
    Secrétaire
    Spottiswoode
    Sandy Road
    KA23 9NN Seamill
    Ayrshire
    British120453410001
    ROSS, Marie Isobel
    51 Killermont Road
    Bearsden
    G61 2JF Glasgow
    Secrétaire
    51 Killermont Road
    Bearsden
    G61 2JF Glasgow
    British42057170004
    WAGNER, Deborah Anne
    1 Hillend Road
    Burnside
    G73 4JU Glasgow
    Secrétaire
    1 Hillend Road
    Burnside
    G73 4JU Glasgow
    British6059110004
    WILSON, John
    2 Kenmore Gardens
    Bearsden
    G61 2BA Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    2 Kenmore Gardens
    Bearsden
    G61 2BA Glasgow
    Lanarkshire
    British464450001
    BAKER, Stephen Paul
    Cornerways
    Rookery Lane Lowsonford
    B95 5ER Henley In Arden
    Warwickshire
    Administrateur
    Cornerways
    Rookery Lane Lowsonford
    B95 5ER Henley In Arden
    Warwickshire
    British100556350001
    BAYLEY, Trevor John
    Woodside Clay Lake
    Endon
    ST9 9DD Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Woodside Clay Lake
    Endon
    ST9 9DD Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish804490002
    BERNSTEIN, Baron Anthony Webber
    Richmond House
    Normans Place
    WA14 2AB Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    Richmond House
    Normans Place
    WA14 2AB Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish7542830001
    BIGGS, Michael Nicholas
    The Red House Little Almshoe
    St Ippollitts
    SG4 7NP Hitchin
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Red House Little Almshoe
    St Ippollitts
    SG4 7NP Hitchin
    Hertfordshire
    United KingdomBritish169003260001
    BROWN, Bernard George
    Hill House
    Broom Close
    KT12 9ET Esher
    Surrey
    Administrateur
    Hill House
    Broom Close
    KT12 9ET Esher
    Surrey
    EnglandBritish8598360004
    BROWN, Bernard George
    Hill House
    Broom Close
    KT12 9ET Esher
    Surrey
    Administrateur
    Hill House
    Broom Close
    KT12 9ET Esher
    Surrey
    EnglandBritish8598360004
    BURDON, Peter Vincent
    6 Belhaven Place
    G77 5FJ Glasgow
    Administrateur
    6 Belhaven Place
    G77 5FJ Glasgow
    British65710740001
    CASSONI, Maria Luisa
    125 Providence Square
    Bermondsey Wall West
    SE1 2ED London
    Administrateur
    125 Providence Square
    Bermondsey Wall West
    SE1 2ED London
    EnglandBritish74583340001
    CRAINE, Roger
    2 Pheasant Field
    Hale Village
    L24 5SD Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    2 Pheasant Field
    Hale Village
    L24 5SD Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritish89585440001
    DAVIDSON, Anthony Beverley
    Pinnerwood Estate
    Castleton Road,Tullibardine
    PH3 1JS Auchterarder
    Perthshire
    Administrateur
    Pinnerwood Estate
    Castleton Road,Tullibardine
    PH3 1JS Auchterarder
    Perthshire
    United KingdomBritish61933730002
    DAVIES, David Wyndham
    Downs Road
    KT18 5JD Epsom
    30
    Surrey
    Administrateur
    Downs Road
    KT18 5JD Epsom
    30
    Surrey
    EnglandBritish10487980001
    FERGUSON, Duncan George Robin
    Clive Wood Farm
    Clive
    SY4 5PR Shrewsbury
    Shropshire
    Administrateur
    Clive Wood Farm
    Clive
    SY4 5PR Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritish144264940001
    GREENFIELD, Richard Edward Keith
    Byeways
    Neston
    CH64 7TA South Wirral
    Merseyside
    Administrateur
    Byeways
    Neston
    CH64 7TA South Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritish100783270001
    HANRATTY, John Joseph
    21 Kingslawn Close
    Howards Lane Putney
    SW15 6QJ London
    Administrateur
    21 Kingslawn Close
    Howards Lane Putney
    SW15 6QJ London
    United KingdomBritish12553730001
    HEAPS, John Edward
    Top House Farm Dodsleigh
    Leigh
    ST10 4QA Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Top House Farm Dodsleigh
    Leigh
    ST10 4QA Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish137263000001
    HENDERSON, William Grahamslaw
    6 West Munro Drive
    G84 9AA Helensburgh
    Dunbartonshire
    Administrateur
    6 West Munro Drive
    G84 9AA Helensburgh
    Dunbartonshire
    United KingdomBritish86647560001
    HILL, John Lawrence
    Warwick Lodge
    10 Warwicks Bench
    GU1 3TG Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Warwick Lodge
    10 Warwicks Bench
    GU1 3TG Guildford
    Surrey
    British1226130001
    HUDSON, Desmond Gerard
    Lindale Off Lampson Road
    G63 9PD Killearn
    Administrateur
    Lindale Off Lampson Road
    G63 9PD Killearn
    United KingdomBritish32094360003
    LAIRD, Gavin Harry, Sir
    9 Cleveden House
    Holmbury Park
    BR1 2WG Bromley
    Kent
    Administrateur
    9 Cleveden House
    Holmbury Park
    BR1 2WG Bromley
    Kent
    British127153740001
    LUSCOMBE, Kerr
    3e Melbourne Court
    Braidpark Drive, Giffnock
    G46 6LA Glasgow
    Administrateur
    3e Melbourne Court
    Braidpark Drive, Giffnock
    G46 6LA Glasgow
    ScotlandBritish83541890001
    MACLEOD, Calum Alexander, Dr
    6 Westfield Terrace
    AB25 2RU Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    6 Westfield Terrace
    AB25 2RU Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish1085020001
    MAIDENS, Ian Graham
    TN5
    Administrateur
    TN5
    United KingdomBritish103576480002
    MERRICK, Michael John
    Long Close
    Main Road, Temple Cloud
    BS39 5DH Bristol
    Administrateur
    Long Close
    Main Road, Temple Cloud
    BS39 5DH Bristol
    EnglandBritish74114060001
    MOSS, Andrew
    Farmfield Raod
    Cheltenham
    GL51 3QZ Gloucester
    50
    United Kingdom
    Administrateur
    Farmfield Raod
    Cheltenham
    GL51 3QZ Gloucester
    50
    United Kingdom
    United KingdomBritish151524430001
    NOWELL, Peter Jack
    Woodlands, 19 Pheasant Walk
    Chalfont St Peter
    SL9 0PW Buckinghamshire
    Administrateur
    Woodlands, 19 Pheasant Walk
    Chalfont St Peter
    SL9 0PW Buckinghamshire
    United KingdomBritish156171700001

    PEARL ALH LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 01 oct. 1991
    Livré le 15 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    36-62 bothwell st glasgow gla 57135.
    Personnes ayant droit
    • Britannia Building Society
    Transactions
    • 15 oct. 1991Enregistrement d'une charge
    • 10 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    PEARL ALH LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    13 juin 2013Dissolved on
    29 nov. 2011Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0