BROOKHOUSE GROUP (NO. 5) LIMITED

BROOKHOUSE GROUP (NO. 5) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBROOKHOUSE GROUP (NO. 5) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC117456
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BROOKHOUSE GROUP (NO. 5) LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe BROOKHOUSE GROUP (NO. 5) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    11 Park Circus
    G3 6AX Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BROOKHOUSE GROUP (NO. 5) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FARTHINGBANK HOLDINGS LIMITED14 sept. 198914 sept. 1989
    PACIFIC SHELF 256 LIMITED24 avr. 198924 avr. 1989

    Quels sont les derniers comptes de BROOKHOUSE GROUP (NO. 5) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au24 sept. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour BROOKHOUSE GROUP (NO. 5) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 24 sept. 2009

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juin 2010

    État du capital au 15 juin 2010

    • Capital: GBP 14,003,829
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Jeremy Gardner le 24 avr. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Hindle le 24 avr. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Peter Chape le 24 avr. 2010

    1 pagesCH03

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages190

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 24 sept. 2008

    13 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 24 sept. 2007

    12 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 24 sept. 2006

    12 pagesAA

    Comptes annuels établis au 24 sept. 2005

    11 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 24 sept. 2004

    11 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de BROOKHOUSE GROUP (NO. 5) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHAPE, Peter
    168-170 Washway Road
    M33 6RH Sale
    Prospect House
    Cheshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    168-170 Washway Road
    M33 6RH Sale
    Prospect House
    Cheshire
    United Kingdom
    British128204680001
    GARDNER, Andrew Jeremy
    168-170 Washway Road
    Haslingden
    M33 6RH Sale
    Prospect House
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    168-170 Washway Road
    Haslingden
    M33 6RH Sale
    Prospect House
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish102740340004
    HINDLE, John
    168-170 Washway Road
    Hale
    M33 6RH Sale
    Prospect House
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    168-170 Washway Road
    Hale
    M33 6RH Sale
    Prospect House
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish4891900001
    BANFI, James Peter
    Crowton Cottage Ainsworth Lane
    Crowton
    CW8 2RS Northwich
    Cheshire
    Secrétaire
    Crowton Cottage Ainsworth Lane
    Crowton
    CW8 2RS Northwich
    Cheshire
    British9872210002
    CAMPION, Clive James
    7 Merrilyn Close
    Claygate
    KT10 0EQ Esher
    Surrey
    Secrétaire
    7 Merrilyn Close
    Claygate
    KT10 0EQ Esher
    Surrey
    British40753600001
    EDWARDS, John Michael
    23 Marshals Drive
    AL1 4RB St. Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    23 Marshals Drive
    AL1 4RB St. Albans
    Hertfordshire
    British67868530001
    LEE, Jonathan Neville Hastings
    7 Lysander Close
    Bekesbourne
    CT4 5EZ Canterbury
    Kent
    Secrétaire
    7 Lysander Close
    Bekesbourne
    CT4 5EZ Canterbury
    Kent
    British77781880002
    MCKIE, Robert Gordon
    4 Blinkbonny Crescent
    EH4 3NB Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    4 Blinkbonny Crescent
    EH4 3NB Edinburgh
    Midlothian
    British30277090001
    NICHOL, Alistair John
    10 Beechfield
    Sandal
    WF2 6AW Wakefield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    10 Beechfield
    Sandal
    WF2 6AW Wakefield
    West Yorkshire
    British79018920001
    SLATER, Gerald Anthony
    Rosilian 46 Trefusis Road
    Flushinig
    TR11 5UB Falmouth
    Cornwall
    Secrétaire
    Rosilian 46 Trefusis Road
    Flushinig
    TR11 5UB Falmouth
    Cornwall
    British1092060001
    SLATER, Gerald Anthony
    Rosilian 46 Trefusis Road
    Flushinig
    TR11 5UB Falmouth
    Cornwall
    Secrétaire
    Rosilian 46 Trefusis Road
    Flushinig
    TR11 5UB Falmouth
    Cornwall
    British1092060001
    BANFI, James Peter
    Crowton Cottage Ainsworth Lane
    Crowton
    CW8 2RS Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    Crowton Cottage Ainsworth Lane
    Crowton
    CW8 2RS Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish9872210002
    BISHOP, David John
    Hill House
    Rettendon Common
    CM3 8EA Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Hill House
    Rettendon Common
    CM3 8EA Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish12294000001
    CAMPION, Clive James
    7 Merrilyn Close
    Claygate
    KT10 0EQ Esher
    Surrey
    Administrateur
    7 Merrilyn Close
    Claygate
    KT10 0EQ Esher
    Surrey
    EnglandBritish40753600001
    CLOGGIE, Allan Marshall
    Low Farthingbank
    DG3 4AH Thornhill
    Dumfriesshire
    Administrateur
    Low Farthingbank
    DG3 4AH Thornhill
    Dumfriesshire
    British1306770001
    JEVONS, David Peter
    Pear Tree Cottage 34 Wrenthorpe Lane
    Wrenthorpe
    WF2 0QA Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Pear Tree Cottage 34 Wrenthorpe Lane
    Wrenthorpe
    WF2 0QA Wakefield
    West Yorkshire
    British30213100001
    LEE, Jonathan Neville Hastings
    7 Lysander Close
    Bekesbourne
    CT4 5EZ Canterbury
    Kent
    Administrateur
    7 Lysander Close
    Bekesbourne
    CT4 5EZ Canterbury
    Kent
    British77781880002
    MARSDEN, Ian Clifford
    47 Withington Avenue
    Culcheth
    WA3 4JE Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    47 Withington Avenue
    Culcheth
    WA3 4JE Warrington
    Cheshire
    British103608350001
    MCKIE, Robert Gordon
    4 Blinkbonny Crescent
    EH4 3NB Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    4 Blinkbonny Crescent
    EH4 3NB Edinburgh
    Midlothian
    British30277090001
    NICHOL, Alistair John
    10 Beechfield
    Sandal
    WF2 6AW Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    10 Beechfield
    Sandal
    WF2 6AW Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish79018920001
    NORTH, Brian Samuel
    Queensbury Priory Road
    Sunningdale
    SL5 9RQ Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Queensbury Priory Road
    Sunningdale
    SL5 9RQ Ascot
    Berkshire
    British6145410001
    SEMADENI, Trevor Nicholas
    Dorneywood Orchard Field
    Postling
    CT21 4EE Hythe
    Kent
    Administrateur
    Dorneywood Orchard Field
    Postling
    CT21 4EE Hythe
    Kent
    EnglandEnglish23768270002

    BROOKHOUSE GROUP (NO. 5) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 22 nov. 1989
    Livré le 01 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank Investments LTD
    Transactions
    • 01 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 22 nov. 1989
    Livré le 01 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • County Nat West Ventures LTD
    Transactions
    • 01 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 22 nov. 1989
    Livré le 24 nov. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transactions
    • 24 nov. 1989Enregistrement d'une charge
    • 16 avr. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0