PROPAC LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPROPAC LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC118170
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PROPAC LIMITED ?

    • Fabrication d'instruments et fournitures médicaux et dentaires (32500) / Industries manufacturières

    Où se situe PROPAC LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Building 3 Bothwell Bridge Business Park
    Bothwell Road
    ML3 0FD Hamilton
    South Lanarkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PROPAC LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    JGT MARKETING SERVICES LIMITED19 juil. 199019 juil. 1990
    CRAIGTON PACKAGING LIMITED22 août 198922 août 1989
    FORTUNA TRADING LIMITED26 mai 198926 mai 1989

    Quels sont les derniers comptes de PROPAC LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PROPAC LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour PROPAC LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Changement d'adresse du siège social de * 26 Netherhall Road Netherton Industrial Est Wishaw Lanarkshire ML2 0JG* le 06 févr. 2014

    2 pagesAD01

    Comptes établis au 31 déc. 2012

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 sept. 2013

    État du capital au 02 sept. 2013

    • Capital: GBP 1,339,940
    SH01

    Nomination de Mr Giovanni Benedetti en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Andrew Palmer en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Andrew Palmer en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes établis au 31 déc. 2011

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Andrew Palmer en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Comptes établis au 31 déc. 2010

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes établis au 31 déc. 2009

    13 pagesAA

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2008

    8 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    15 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages122

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    18 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de PROPAC LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BENEDETTI, Giovanni
    Bothwell Bridge Business Park
    Bothwell Road
    ML3 0FD Hamilton
    Building 3
    South Lanarkshire
    Secrétaire
    Bothwell Bridge Business Park
    Bothwell Road
    ML3 0FD Hamilton
    Building 3
    South Lanarkshire
    175994590001
    BENEDETTI, Giovanni
    21 Overton Drive
    KA23 9LQ West Kilbride
    Strathclyde
    Administrateur
    21 Overton Drive
    KA23 9LQ West Kilbride
    Strathclyde
    United KingdomItalian90520001
    BENEDETTI, Giovanni
    21 Overton Drive
    KA23 9LQ West Kilbride
    Strathclyde
    Secrétaire
    21 Overton Drive
    KA23 9LQ West Kilbride
    Strathclyde
    Italian90520001
    CALDWELL, Graham Ronald
    10 Browncarrick Drive
    Doonfoot
    KA7 4JA Ayr
    Ayrshire
    Secrétaire
    10 Browncarrick Drive
    Doonfoot
    KA7 4JA Ayr
    Ayrshire
    British7015840001
    CLARK, Michael David
    31 Cheviot Crescent
    G75 9GG East Kilbride
    Lanarkshire
    Secrétaire
    31 Cheviot Crescent
    G75 9GG East Kilbride
    Lanarkshire
    British111876120001
    CRAIG, Thomas Kirk
    Amherst Montrose Terrace
    PA11 3DH Bridge Of Weir
    Secrétaire
    Amherst Montrose Terrace
    PA11 3DH Bridge Of Weir
    British5050002
    FINLAY, William Mcturk
    35 Mount Charles Crescent
    Doonfoot
    KA7 4PA Ayr
    Ayrshire
    Secrétaire
    35 Mount Charles Crescent
    Doonfoot
    KA7 4PA Ayr
    Ayrshire
    British74380400001
    GENTLES, John Donald
    20 Broomley Drive
    Giffnock
    G46 6PD Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    20 Broomley Drive
    Giffnock
    G46 6PD Glasgow
    Lanarkshire
    British320650001
    HARROWELL, Graeme Nigel
    10 Newlands Road
    G43 2JB Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    10 Newlands Road
    G43 2JB Glasgow
    Lanarkshire
    British68531440001
    HUGHES, Keith John
    3 Hill Street
    EH2 3JP Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    3 Hill Street
    EH2 3JP Edinburgh
    Midlothian
    British735110001
    OWENS, Anthony
    41 Beltonfoot Way
    ML2 0GA Wishaw
    North Lanarkshire
    Secrétaire
    41 Beltonfoot Way
    ML2 0GA Wishaw
    North Lanarkshire
    British86285020002
    PALMER, Andrew
    Netherhall Road
    Netherton Industrial Estate
    ML2 0JG Wishaw
    26
    Secrétaire
    Netherhall Road
    Netherton Industrial Estate
    ML2 0JG Wishaw
    26
    British163890150001
    WILSON, Kenneth
    343 Glasgow Road
    Waterfoot
    G76 0ER Glasgow
    Secrétaire
    343 Glasgow Road
    Waterfoot
    G76 0ER Glasgow
    British53458580003
    CALDWELL, Graham Ronald
    10 Browncarrick Drive
    Doonfoot
    KA7 4JA Ayr
    Ayrshire
    Administrateur
    10 Browncarrick Drive
    Doonfoot
    KA7 4JA Ayr
    Ayrshire
    British7015840001
    CRAIG, Thomas Kirk
    Amherst Montrose Terrace
    PA11 3DH Bridge Of Weir
    Administrateur
    Amherst Montrose Terrace
    PA11 3DH Bridge Of Weir
    United KingdomBritish5050002
    GALSTON, Ian
    49 Stewart Drive
    Clarkston
    G76 7EX Glasgow
    Administrateur
    49 Stewart Drive
    Clarkston
    G76 7EX Glasgow
    British51403440001
    GENTLES, John Donald
    20 Broomley Drive
    Giffnock
    G46 6PD Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    20 Broomley Drive
    Giffnock
    G46 6PD Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish320650001
    HARROWELL, Graeme Nigel
    10 Newlands Road
    G43 2JB Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    10 Newlands Road
    G43 2JB Glasgow
    Lanarkshire
    British68531440001
    HUGHES, Keith John
    3 Hill Street
    EH2 3JP Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    3 Hill Street
    EH2 3JP Edinburgh
    Midlothian
    British735110001
    JOHNSTONE, Marjory Jane
    3 Hill Street
    EH2 3JP Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    3 Hill Street
    EH2 3JP Edinburgh
    Midlothian
    British748350001
    THOMSON, Gilmour M A
    16 Crosbie Woods
    PA2 0SG Paisley
    Renfrewshire
    Administrateur
    16 Crosbie Woods
    PA2 0SG Paisley
    Renfrewshire
    British922850001

    PROPAC LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 31 janv. 1997
    Livré le 10 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Benedetti International Limited
    Transactions
    • 10 févr. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 avr. 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 14 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 31 janv. 1997
    Livré le 03 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 03 févr. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 mars 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 14 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 31 janv. 1997
    Livré le 03 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Scottish Enterprise
    Transactions
    • 03 févr. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 mars 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 14 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 21 oct. 1996
    Livré le 25 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Kellock Limited
    Transactions
    • 25 oct. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 nov. 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 02 avr. 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 27 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 12 mai 1995
    Livré le 23 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Netherhall road,wishaw.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 mai 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 mars 1996Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 25 mars 1994
    Livré le 29 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 mars 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 nov. 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 07 avr. 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 10 févr. 1993
    Livré le 18 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 18 févr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 avr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0