URS CORPORATION LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéURS CORPORATION LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC118271
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de URS CORPORATION LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe URS CORPORATION LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2nd Floor 177 Bothwell Street
    G2 7ER Glasgow
    Scotland
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de URS CORPORATION LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THORBURN COLQUHOUN LIMITED20 janv. 199420 janv. 1994
    THORBURN LIMITED01 janv. 199201 janv. 1992
    THORBURN GROUP ONE LIMITED02 mars 199002 mars 1990
    BRENDENT LIMITED01 juin 198901 juin 1989

    Quels sont les derniers comptes de URS CORPORATION LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 sept. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au27 sept. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour URS CORPORATION LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au04 juin 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation18 juin 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au04 juin 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour URS CORPORATION LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes pour une petite entreprise établis au 27 sept. 2024

    25 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2025 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de David John Price en tant que directeur le 22 avr. 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Joanne Lucy Lang en tant que directeur le 22 avr. 2025

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Andrew Richard Barker en tant qu'administrateur le 22 avr. 2025

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Richard Stephen Whitehead en tant qu'administrateur le 22 avr. 2025

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 29 sept. 2023

    25 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 7th Floor Aurora Building 120-136 Bothwell Street Glasgow Scotland G2 7EA Scotland à 2nd Floor 177 Bothwell Street Glasgow Scotland G2 7ER le 13 mai 2024

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 sept. 2022

    24 pagesAA

    Comptes pour une petite entreprise établis au 01 oct. 2021

    24 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 02 oct. 2020

    23 pagesAA

    Nomination de Mr David John Price en tant qu'administrateur le 30 oct. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Cheryl Rosalind Mccall en tant que directeur le 30 oct. 2020

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de , Citypoint 2 25 Tyndrum Street, Glasgow, G4 0JY à 7th Floor Aurora Building 120-136 Bothwell Street Glasgow Scotland G2 7EA le 26 oct. 2020

    1 pagesAD01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 27 sept. 2019

    24 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Bolaji Moruf Taiwo le 14 août 2019

    1 pagesCH03

    Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Cheryl Rosalind Mccall le 30 mai 2019

    2 pagesCH01

    Modification des détails de Urs Europe Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 mai 2019

    2 pagesPSC05

    Comptes pour une petite entreprise établis au 28 sept. 2018

    20 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de URS CORPORATION LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TAIWO, Bolaji Moruf
    177 Bothwell Street
    G2 7ER Glasgow
    2nd Floor
    Scotland
    Scotland
    Secrétaire
    177 Bothwell Street
    G2 7ER Glasgow
    2nd Floor
    Scotland
    Scotland
    253993620001
    BARKER, Andrew Richard
    177 Bothwell Street
    G2 7ER Glasgow
    2nd Floor
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    177 Bothwell Street
    G2 7ER Glasgow
    2nd Floor
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish262417280002
    WHITEHEAD, Richard Stephen
    177 Bothwell Street
    G2 7ER Glasgow
    2nd Floor
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    177 Bothwell Street
    G2 7ER Glasgow
    2nd Floor
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish216999550001
    COMBER, Lawrence David
    Chalkpit Terrace
    RH4 1HX Dorking
    12
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Chalkpit Terrace
    RH4 1HX Dorking
    12
    Surrey
    United Kingdom
    British134954060001
    ELLIOTT FREY, Andrew
    5 Combemartin Road
    Southfields
    SW18 5PP London
    Secrétaire
    5 Combemartin Road
    Southfields
    SW18 5PP London
    British83330850002
    HOSKINGS-JAMES, Yvette Denise
    25 Archdale Place
    KT3 3RW New Malden
    Surrey
    Secrétaire
    25 Archdale Place
    KT3 3RW New Malden
    Surrey
    British76485710001
    MACKENZIE, Alan Lovat
    8 Roxburgh Drive
    Bearsden
    G61 3LH Glasgow
    Secrétaire
    8 Roxburgh Drive
    Bearsden
    G61 3LH Glasgow
    British62414920001
    MONAGHAN, Paul
    18 Hartshill Close
    Hillingdon
    UB10 9LH Uxbridge
    Middlesex
    Secrétaire
    18 Hartshill Close
    Hillingdon
    UB10 9LH Uxbridge
    Middlesex
    British59170960001
    PARRY-JONES, Alan
    West George Street
    G2 4QE Glasgow
    243
    Scotland
    Secrétaire
    West George Street
    G2 4QE Glasgow
    243
    Scotland
    158420390001
    PORTER, Derek
    Mayfield
    Tandlehill Road
    PA10 2DD Kilbarchan
    Renfrewshire
    Secrétaire
    Mayfield
    Tandlehill Road
    PA10 2DD Kilbarchan
    Renfrewshire
    British47585310001
    PRIOR, Adela
    14 Glendarvon Street
    Putney
    SW15 1JS London
    Secrétaire
    14 Glendarvon Street
    Putney
    SW15 1JS London
    British51389160003
    BLP SECRETARIES LIMITED
    130 St Vincent Street
    G2 5SE Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    130 St Vincent Street
    G2 5SE Glasgow
    Lanarkshire
    78293470001
    AINSWORTH, Kent
    14 Acacia Avenue
    94904 Kentfield
    California
    Usa
    Administrateur
    14 Acacia Avenue
    94904 Kentfield
    California
    Usa
    American62413530001
    ALEXANDER, John George
    Le Lavendou
    Burney Road Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Le Lavendou
    Burney Road Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    British106639360001
    BEAMAN, John Quentin
    Bewlridge House
    Flimwell Grange
    Hadhurst
    Sussex
    Administrateur
    Bewlridge House
    Flimwell Grange
    Hadhurst
    Sussex
    British340600001
    BENNISON, David James
    84 Tyne Crescent
    Brickhill
    MK41 7UL Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    84 Tyne Crescent
    Brickhill
    MK41 7UL Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritish102667530001
    BENNISON, David James
    84 Tyne Crescent
    Brickhill
    MK41 7UL Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    84 Tyne Crescent
    Brickhill
    MK41 7UL Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritish102667530001
    BETTENBUHL, Volker Helmut
    Gartenstrasse
    65812 Bad Soden Am Taunus
    10
    Germany
    Administrateur
    Gartenstrasse
    65812 Bad Soden Am Taunus
    10
    Germany
    GermanyGerman135135880001
    BRADLEY, Michael Henry
    Elder House North Street
    Tolleshunt Darcy
    CM9 8TF Maldon
    Essex
    Administrateur
    Elder House North Street
    Tolleshunt Darcy
    CM9 8TF Maldon
    Essex
    British43768390001
    BUCHANAN, Neil Wood
    1 Lubnaig Gardens
    Bearsden
    G61 4QX Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    1 Lubnaig Gardens
    Bearsden
    G61 4QX Glasgow
    Lanarkshire
    British264300001
    BUTLER, Nigel Alan
    124 Pursey Drive
    BS32 8DP Bradley Stoke
    South Gloucestershire
    Administrateur
    124 Pursey Drive
    BS32 8DP Bradley Stoke
    South Gloucestershire
    British74878640001
    CLARK, Lawson
    31 Stewart Drive
    Clarkston
    G76 7EY Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    31 Stewart Drive
    Clarkston
    G76 7EY Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish26175860001
    DARLING, Christopher John
    3 Manor Gardens
    Syderstone
    PE31 8SD Kings Lynn
    Norfolk
    Administrateur
    3 Manor Gardens
    Syderstone
    PE31 8SD Kings Lynn
    Norfolk
    British79196510001
    DARLING, Christopher John
    3 Manor Gardens
    Syderstone
    PE31 8SD Kings Lynn
    Norfolk
    Administrateur
    3 Manor Gardens
    Syderstone
    PE31 8SD Kings Lynn
    Norfolk
    British79196510001
    DUNN, Michael John Arnold
    Walnut Acre Tandridge Road
    CR6 9LS Warlingham
    Surrey
    Administrateur
    Walnut Acre Tandridge Road
    CR6 9LS Warlingham
    Surrey
    British11704470001
    DUNSTER, David John
    93 Saint Winifreds Road
    HG2 8LR Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    93 Saint Winifreds Road
    HG2 8LR Harrogate
    North Yorkshire
    British69851610001
    ELLIOTT FREY, Andrew
    5 Combemartin Road
    Southfields
    SW18 5PP London
    Administrateur
    5 Combemartin Road
    Southfields
    SW18 5PP London
    United KingdomBritish83330850002
    GRAY, Stuart Roger
    Bryn House
    Pwllmeyric
    NP6 6LE Chepstow
    Gwent
    Administrateur
    Bryn House
    Pwllmeyric
    NP6 6LE Chepstow
    Gwent
    British43760650001
    GROVE, Richard Wallace
    Sayers Court
    St.Mary Church
    CF7 7LT Cowbridge
    South Glam
    Administrateur
    Sayers Court
    St.Mary Church
    CF7 7LT Cowbridge
    South Glam
    British4170800001
    HOLLOWAY, Keith
    6 Howard Close
    Wilstead
    MK45 3JW Bedford
    Administrateur
    6 Howard Close
    Wilstead
    MK45 3JW Bedford
    British43767860001
    JOHNS, Stephen Peter
    25 St Leonards Way
    RM11 1FP Hornchurch
    Essex
    Administrateur
    25 St Leonards Way
    RM11 1FP Hornchurch
    Essex
    British76485700001
    LANG, Joanne Lucy
    177 Bothwell Street
    G2 7ER Glasgow
    2nd Floor
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    177 Bothwell Street
    G2 7ER Glasgow
    2nd Floor
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish255152790001
    LOVEDAY, Ian Charles
    104 High Street
    TW12 2ST Hampton
    Middlesex
    Administrateur
    104 High Street
    TW12 2ST Hampton
    Middlesex
    UkUk78855850002
    MACFADYEN, Iain Leslie
    Dargarvel Avenue
    G41 5LD Glasgow
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Dargarvel Avenue
    G41 5LD Glasgow
    8
    United Kingdom
    ScotlandBritish136893260001
    MACKENZIE, Alan Lovat
    8 Roxburgh Drive
    Bearsden
    G61 3LH Glasgow
    Administrateur
    8 Roxburgh Drive
    Bearsden
    G61 3LH Glasgow
    ScotlandBritish62414920001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur URS CORPORATION LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Urs Europe Limited
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    2 Leman Street
    E1 8FA London
    Aldgate Tower
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement03678568
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0