URS CORPORATION LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | URS CORPORATION LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC118271 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe URS CORPORATION LIMITED ?
| Adresse du siège social | 2nd Floor 177 Bothwell Street G2 7ER Glasgow Scotland Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de URS CORPORATION LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 30 sept. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 juin 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 27 sept. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour URS CORPORATION LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 04 juin 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 18 juin 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 04 juin 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour URS CORPORATION LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes pour une petite entreprise établis au 27 sept. 2024 | 25 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2025 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de David John Price en tant que directeur le 22 avr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Joanne Lucy Lang en tant que directeur le 22 avr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Andrew Richard Barker en tant qu'administrateur le 22 avr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Richard Stephen Whitehead en tant qu'administrateur le 22 avr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 29 sept. 2023 | 25 pages | AA | ||
Changement d'adresse du siège social de 7th Floor Aurora Building 120-136 Bothwell Street Glasgow Scotland G2 7EA Scotland à 2nd Floor 177 Bothwell Street Glasgow Scotland G2 7ER le 13 mai 2024 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 30 sept. 2022 | 24 pages | AA | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 01 oct. 2021 | 24 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 02 oct. 2020 | 23 pages | AA | ||
Nomination de Mr David John Price en tant qu'administrateur le 30 oct. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Cheryl Rosalind Mccall en tant que directeur le 30 oct. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Changement d'adresse du siège social de , Citypoint 2 25 Tyndrum Street, Glasgow, G4 0JY à 7th Floor Aurora Building 120-136 Bothwell Street Glasgow Scotland G2 7EA le 26 oct. 2020 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 27 sept. 2019 | 24 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Bolaji Moruf Taiwo le 14 août 2019 | 1 pages | CH03 | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 juin 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Cheryl Rosalind Mccall le 30 mai 2019 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des détails de Urs Europe Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 mai 2019 | 2 pages | PSC05 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 28 sept. 2018 | 20 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de URS CORPORATION LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWO, Bolaji Moruf | Secrétaire | 177 Bothwell Street G2 7ER Glasgow 2nd Floor Scotland Scotland | 253993620001 | |||||||
| BARKER, Andrew Richard | Administrateur | 177 Bothwell Street G2 7ER Glasgow 2nd Floor Scotland Scotland | United Kingdom | British | 262417280002 | |||||
| WHITEHEAD, Richard Stephen | Administrateur | 177 Bothwell Street G2 7ER Glasgow 2nd Floor Scotland Scotland | United Kingdom | British | 216999550001 | |||||
| COMBER, Lawrence David | Secrétaire | Chalkpit Terrace RH4 1HX Dorking 12 Surrey United Kingdom | British | 134954060001 | ||||||
| ELLIOTT FREY, Andrew | Secrétaire | 5 Combemartin Road Southfields SW18 5PP London | British | 83330850002 | ||||||
| HOSKINGS-JAMES, Yvette Denise | Secrétaire | 25 Archdale Place KT3 3RW New Malden Surrey | British | 76485710001 | ||||||
| MACKENZIE, Alan Lovat | Secrétaire | 8 Roxburgh Drive Bearsden G61 3LH Glasgow | British | 62414920001 | ||||||
| MONAGHAN, Paul | Secrétaire | 18 Hartshill Close Hillingdon UB10 9LH Uxbridge Middlesex | British | 59170960001 | ||||||
| PARRY-JONES, Alan | Secrétaire | West George Street G2 4QE Glasgow 243 Scotland | 158420390001 | |||||||
| PORTER, Derek | Secrétaire | Mayfield Tandlehill Road PA10 2DD Kilbarchan Renfrewshire | British | 47585310001 | ||||||
| PRIOR, Adela | Secrétaire | 14 Glendarvon Street Putney SW15 1JS London | British | 51389160003 | ||||||
| BLP SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 130 St Vincent Street G2 5SE Glasgow Lanarkshire | 78293470001 | |||||||
| AINSWORTH, Kent | Administrateur | 14 Acacia Avenue 94904 Kentfield California Usa | American | 62413530001 | ||||||
| ALEXANDER, John George | Administrateur | Le Lavendou Burney Road Westhumble RH5 6AU Dorking Surrey | British | 106639360001 | ||||||
| BEAMAN, John Quentin | Administrateur | Bewlridge House Flimwell Grange Hadhurst Sussex | British | 340600001 | ||||||
| BENNISON, David James | Administrateur | 84 Tyne Crescent Brickhill MK41 7UL Bedford Bedfordshire | England | British | 102667530001 | |||||
| BENNISON, David James | Administrateur | 84 Tyne Crescent Brickhill MK41 7UL Bedford Bedfordshire | England | British | 102667530001 | |||||
| BETTENBUHL, Volker Helmut | Administrateur | Gartenstrasse 65812 Bad Soden Am Taunus 10 Germany | Germany | German | 135135880001 | |||||
| BRADLEY, Michael Henry | Administrateur | Elder House North Street Tolleshunt Darcy CM9 8TF Maldon Essex | British | 43768390001 | ||||||
| BUCHANAN, Neil Wood | Administrateur | 1 Lubnaig Gardens Bearsden G61 4QX Glasgow Lanarkshire | British | 264300001 | ||||||
| BUTLER, Nigel Alan | Administrateur | 124 Pursey Drive BS32 8DP Bradley Stoke South Gloucestershire | British | 74878640001 | ||||||
| CLARK, Lawson | Administrateur | 31 Stewart Drive Clarkston G76 7EY Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 26175860001 | |||||
| DARLING, Christopher John | Administrateur | 3 Manor Gardens Syderstone PE31 8SD Kings Lynn Norfolk | British | 79196510001 | ||||||
| DARLING, Christopher John | Administrateur | 3 Manor Gardens Syderstone PE31 8SD Kings Lynn Norfolk | British | 79196510001 | ||||||
| DUNN, Michael John Arnold | Administrateur | Walnut Acre Tandridge Road CR6 9LS Warlingham Surrey | British | 11704470001 | ||||||
| DUNSTER, David John | Administrateur | 93 Saint Winifreds Road HG2 8LR Harrogate North Yorkshire | British | 69851610001 | ||||||
| ELLIOTT FREY, Andrew | Administrateur | 5 Combemartin Road Southfields SW18 5PP London | United Kingdom | British | 83330850002 | |||||
| GRAY, Stuart Roger | Administrateur | Bryn House Pwllmeyric NP6 6LE Chepstow Gwent | British | 43760650001 | ||||||
| GROVE, Richard Wallace | Administrateur | Sayers Court St.Mary Church CF7 7LT Cowbridge South Glam | British | 4170800001 | ||||||
| HOLLOWAY, Keith | Administrateur | 6 Howard Close Wilstead MK45 3JW Bedford | British | 43767860001 | ||||||
| JOHNS, Stephen Peter | Administrateur | 25 St Leonards Way RM11 1FP Hornchurch Essex | British | 76485700001 | ||||||
| LANG, Joanne Lucy | Administrateur | 177 Bothwell Street G2 7ER Glasgow 2nd Floor Scotland Scotland | United Kingdom | British | 255152790001 | |||||
| LOVEDAY, Ian Charles | Administrateur | 104 High Street TW12 2ST Hampton Middlesex | Uk | Uk | 78855850002 | |||||
| MACFADYEN, Iain Leslie | Administrateur | Dargarvel Avenue G41 5LD Glasgow 8 United Kingdom | Scotland | British | 136893260001 | |||||
| MACKENZIE, Alan Lovat | Administrateur | 8 Roxburgh Drive Bearsden G61 3LH Glasgow | Scotland | British | 62414920001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur URS CORPORATION LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urs Europe Limited | 06 avr. 2016 | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0