WM. LOW SUPERMARKETS LIMITED

WM. LOW SUPERMARKETS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWM. LOW SUPERMARKETS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC119497
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WM. LOW SUPERMARKETS LIMITED ?

    • Vente au détail en magasin non spécialisé avec prédominance d'alimentation, de boissons ou de tabac (47110) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe WM. LOW SUPERMARKETS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Atria One
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WM. LOW SUPERMARKETS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au24 févr. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour WM. LOW SUPERMARKETS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché)

    9 pagesLIQ13(Scot)

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    4 pagesMR04

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 1

    5 pagesMR05

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    4 pagesMR04

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré C/O Morton Fraser Llp, 5th Floor Quartermile Two, 2 Lister Square Edinburgh EH3 9GL

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à C/O Morton Fraser Llp, 5th Floor Quartermile Two, 2 Lister Square Edinburgh EH3 9GL

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de C/O Morton Fraser Llp 5th Floor, Quartermile Two 2 Lister Square Edinburgh Scotland EH3 9GL à Atria One 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EX le 03 sept. 2019

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 21 août 2019

    LRESSP

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 16 août 2019

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Nomination de Lynda Jane Heywood en tant qu'administrateur le 09 août 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de John Gibney en tant que directeur le 09 août 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Tesco Services Limited en tant que directeur le 09 août 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 07 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Gibney le 02 avr. 2019

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 24 févr. 2018

    3 pagesAA

    legacy

    158 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Déclaration de confirmation établie le 07 juin 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 25 févr. 2017

    3 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de WM. LOW SUPERMARKETS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TESCO SECRETARIES LIMITED
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement08730224
    182118090001
    HEYWOOD, Lynda Jane
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    Administrateur
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    EnglandBritish213408010001
    WELCH, Robert John
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    Administrateur
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    United KingdomBritish212146700001
    BAILEY, John Anthony
    Games Road
    EN4 9HX Barnet
    Ludgrove Hall 61-65
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Games Road
    EN4 9HX Barnet
    Ludgrove Hall 61-65
    Hertfordshire
    British134568600001
    FIELD, Martin John
    1 Hole Farm Cottages
    Albury Hall Park Albury
    SG11 2JE Ware
    Hertfordshire
    Secrétaire
    1 Hole Farm Cottages
    Albury Hall Park Albury
    SG11 2JE Ware
    Hertfordshire
    British71986450002
    FIELD, Martin John
    1 Hole Farm Cottages
    Albury Hall Park Albury
    SG11 2JE Ware
    Hertfordshire
    Secrétaire
    1 Hole Farm Cottages
    Albury Hall Park Albury
    SG11 2JE Ware
    Hertfordshire
    British71986450002
    FINDLAY, Harvie Leigh
    8 Abercromby Street
    Broughty Ferry
    DD5 2QT Dundee
    Angus
    Secrétaire
    8 Abercromby Street
    Broughty Ferry
    DD5 2QT Dundee
    Angus
    British138020001
    O'KEEFE, Helen Jane
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Secrétaire
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    British96031250001
    SANKAR, Nadine Amanda
    90 Ebury Road
    WD17 2SB Watford
    Secrétaire
    90 Ebury Road
    WD17 2SB Watford
    British72917320001
    AGER, Rowley Stuart
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Administrateur
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritish72555850002
    BAILEY, John Anthony
    Games Road
    EN4 9HX Barnet
    Ludgrove Hall 61-65
    Hertfordshire
    Administrateur
    Games Road
    EN4 9HX Barnet
    Ludgrove Hall 61-65
    Hertfordshire
    EnglandBritish134568600001
    ELMER, Anthony John
    58 Princes Avenue
    IG8 0LP Woodford Green
    Essex
    Administrateur
    58 Princes Avenue
    IG8 0LP Woodford Green
    Essex
    British28698880001
    FIELD, Martin John
    42 Lygean Avenue
    SG12 7AR Ware
    Hertfordshire
    Administrateur
    42 Lygean Avenue
    SG12 7AR Ware
    Hertfordshire
    British71986450003
    FIELD, Martin John
    1 Hole Farm Cottages
    Albury Hall Park Albury
    SG11 2JE Ware
    Hertfordshire
    Administrateur
    1 Hole Farm Cottages
    Albury Hall Park Albury
    SG11 2JE Ware
    Hertfordshire
    British71986450002
    FINDLAY, Brian Edgar
    7 Monkbarns Drive
    DD11 2DS Arbroath
    Angus
    Administrateur
    7 Monkbarns Drive
    DD11 2DS Arbroath
    Angus
    British28314500001
    FINDLAY, Harvie Leigh
    8 Abercromby Street
    Broughty Ferry
    DD5 2QT Dundee
    Angus
    Administrateur
    8 Abercromby Street
    Broughty Ferry
    DD5 2QT Dundee
    Angus
    ScotlandBritish138020001
    GIBNEY, John
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrish194216530003
    GILDERSLEEVE, John
    21 Clarke Road
    Mount Farm Bletchley
    MK1 1LG Milton Keynes
    Administrateur
    21 Clarke Road
    Mount Farm Bletchley
    MK1 1LG Milton Keynes
    British52936560001
    GORDON, Michael John
    13 Evelyn Terrace
    PH2 0BS Perth
    Perthshire
    Uk
    Administrateur
    13 Evelyn Terrace
    PH2 0BS Perth
    Perthshire
    Uk
    British18869250001
    HIGGINSON, Andrew Thomas
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Administrateur
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    EnglandBritish57637410003
    LAING, Stewart Henry
    12 Shiell Street
    Broughty Ferry
    DD5 2TB Dundee
    Administrateur
    12 Shiell Street
    Broughty Ferry
    DD5 2TB Dundee
    British37407980002
    LEAHY, Terence Patrick, Sir
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Administrateur
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritish183358310001
    LESLIE, Alexander Lawson
    8 Fraser Terrace
    PH1 1BX Perth
    Perthshire
    Administrateur
    8 Fraser Terrace
    PH1 1BX Perth
    Perthshire
    British138080001
    LLOYD, Jonathan Mark
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Administrateur
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritish160028560001
    MACLAURIN, Ian Charter, Lord
    14 Great College Street
    Westminster
    SW1P 3RX London
    Administrateur
    14 Great College Street
    Westminster
    SW1P 3RX London
    United KingdomBritish84385670001
    MILLAR, James Lauder
    Westwood
    Auchterhouse
    DD3 0QS Dundee
    Angus
    Administrateur
    Westwood
    Auchterhouse
    DD3 0QS Dundee
    Angus
    British138040001
    MOORE, Paul Anthony
    5th Floor, Quartermile Two
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    C/O Morton Fraser Llp
    Scotland
    Administrateur
    5th Floor, Quartermile Two
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    C/O Morton Fraser Llp
    Scotland
    EnglandBritish194306140002
    MOURANT, Nicholas Claud
    Tesco House
    Delamare Road Cheshunt
    EN8 9SL Waltham Cross
    Hertfordshire
    Administrateur
    Tesco House
    Delamare Road Cheshunt
    EN8 9SL Waltham Cross
    Hertfordshire
    United KingdomBritish67463160002
    NEVILLE-ROLFE, Lucy Jeanne, Ms.
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Administrateur
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    United KingdomBritish148079740001
    RAYCRAFT, Michael
    Stoneymor Wood Farm Hob Lane
    Burton Green
    CV8 1QB Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    Stoneymor Wood Farm Hob Lane
    Burton Green
    CV8 1QB Kenilworth
    Warwickshire
    British44509470001
    REID, David Edward
    Progress House
    The Boulevard Shire Park
    AL7 1RZ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Administrateur
    Progress House
    The Boulevard Shire Park
    AL7 1RZ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British1485630011
    SPICER, Philip Roderick
    12 Lauder Crescent
    PH1 1SU Perth
    Administrateur
    12 Lauder Crescent
    PH1 1SU Perth
    British56674770001
    TESCO SERVICES LIMITED
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Administrateur
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement7600956
    175259630001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WM. LOW SUPERMARKETS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement00243011
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    WM. LOW SUPERMARKETS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 28 août 1992
    Acquis le 09 août 1993
    Livré le 18 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £340,000 and all other monies due from law stores limited and wm. Low supertmarkets limited to the chargee
    Brèves mentions
    All those freehold premises abutting on the south eastern side bransty row and on the eastern side bransty road whitehaven.
    Personnes ayant droit
    • Esso Petroleum Company Limited
    Transactions
    • 18 août 1993Enregistrement d'une acquisition (416)
    • 11 janv. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 28 août 1992
    Livré le 18 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £340,000 and all sums due or to become due by wm. Low supermarkets limited and or another.
    Brèves mentions
    All buildings structures canopies consoles pumps and tanks and other fixed equipment attached to the property and within the ownership of the company.
    Personnes ayant droit
    • Esso Petroleum Company Limited
    Transactions
    • 18 sept. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 janv. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 18 mars 1992
    Livré le 26 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot of ground extending to 0.1957 hectares, harefield road, dundee, to disposition by michael anthony johnston in favour of the company dated 210691 and recorded grs on 010791.
    Personnes ayant droit
    • Esso Petroleum Company Limited
    Transactions
    • 26 mars 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 janv. 2020L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    • 08 févr. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)

    WM. LOW SUPERMARKETS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    15 août 2020Dissolved on
    21 août 2019Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0