ROBERT WYPER (MOTORS) LIMITED

ROBERT WYPER (MOTORS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéROBERT WYPER (MOTORS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC119823
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ROBERT WYPER (MOTORS) LIMITED ?

    • Vente de voitures neuves et de véhicules légers (45111) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe ROBERT WYPER (MOTORS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Thomas Barrie & Co
    Atlantic Chambers
    G2 6QE 1a Cadogan Street
    Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ROBERT WYPER (MOTORS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour ROBERT WYPER (MOTORS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 30 août 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2018

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 août 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Alasdair George Noble en tant qu'administrateur le 17 nov. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Gerard Donnachie en tant que directeur le 03 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2017

    12 pagesAA

    Cessation de la nomination de Gerard Donnachie en tant que secrétaire le 06 oct. 2017

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Alasdair George Noble en tant que secrétaire le 06 oct. 2017

    2 pagesAP03

    Déclaration de confirmation établie le 30 août 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2016

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 août 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mr Douglas Ireland Park en tant qu'administrateur le 01 nov. 2015

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 sept. 2015

    État du capital au 03 sept. 2015

    • Capital: GBP 296,875
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    10 pagesAA

    Cessation de la nomination de Douglas Ireland Park en tant que directeur le 23 juin 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 sept. 2013

    État du capital au 12 sept. 2013

    • Capital: GBP 296,875
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    9 pagesAA

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2012

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2011

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ROBERT WYPER (MOTORS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NOBLE, Alasdair George
    C/O Thomas Barrie & Co
    Atlantic Chambers
    G2 6QE 1a Cadogan Street
    Glasgow
    Secrétaire
    C/O Thomas Barrie & Co
    Atlantic Chambers
    G2 6QE 1a Cadogan Street
    Glasgow
    238723440001
    BRYCE, Alexander Stewart
    C/O Thomas Barrie & Co
    Atlantic Chambers
    G2 6QE 1a Cadogan Street
    Glasgow
    Administrateur
    C/O Thomas Barrie & Co
    Atlantic Chambers
    G2 6QE 1a Cadogan Street
    Glasgow
    United KingdomBritish150803460001
    CUMMING, William
    C/O Thomas Barrie & Co
    Atlantic Chambers
    G2 6QE 1a Cadogan Street
    Glasgow
    Administrateur
    C/O Thomas Barrie & Co
    Atlantic Chambers
    G2 6QE 1a Cadogan Street
    Glasgow
    United KingdomBritish112830750001
    MACKAY, Ian Barron
    C/O Thomas Barrie & Co
    Atlantic Chambers
    G2 6QE 1a Cadogan Street
    Glasgow
    Administrateur
    C/O Thomas Barrie & Co
    Atlantic Chambers
    G2 6QE 1a Cadogan Street
    Glasgow
    ScotlandBritish406430001
    NOBLE, Alasdair George
    C/O Thomas Barrie & Co
    Atlantic Chambers
    G2 6QE 1a Cadogan Street
    Glasgow
    Administrateur
    C/O Thomas Barrie & Co
    Atlantic Chambers
    G2 6QE 1a Cadogan Street
    Glasgow
    ScotlandBritish240301140001
    PARK, Douglas Ireland
    C/O Thomas Barrie & Co
    Atlantic Chambers
    G2 6QE 1a Cadogan Street
    Glasgow
    Administrateur
    C/O Thomas Barrie & Co
    Atlantic Chambers
    G2 6QE 1a Cadogan Street
    Glasgow
    SwitzerlandBritish202387330001
    PARK, Ross William
    C/O Thomas Barrie & Co
    Atlantic Chambers
    G2 6QE 1a Cadogan Street
    Glasgow
    Administrateur
    C/O Thomas Barrie & Co
    Atlantic Chambers
    G2 6QE 1a Cadogan Street
    Glasgow
    ScotlandBritish93072080001
    DONNACHIE, Gerard
    C/O Thomas Barrie & Co
    Atlantic Chambers
    G2 6QE 1a Cadogan Street
    Glasgow
    Secrétaire
    C/O Thomas Barrie & Co
    Atlantic Chambers
    G2 6QE 1a Cadogan Street
    Glasgow
    British602380003
    HARKNESS, John
    Aldowrie 14 Kay Park Terrace
    KA3 7AZ Kilmarnock
    Ayrshire
    Secrétaire
    Aldowrie 14 Kay Park Terrace
    KA3 7AZ Kilmarnock
    Ayrshire
    British44012000001
    TERRAS, Jacqueline Mary
    93 Dundonald Road
    KA1 1TQ Kilmarnock
    Ayrshire
    Secrétaire
    93 Dundonald Road
    KA1 1TQ Kilmarnock
    Ayrshire
    British4653970001
    BROWN, Steve
    8 Snead View
    ML1 5GL Motherwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    8 Snead View
    ML1 5GL Motherwell
    Lanarkshire
    British112830890001
    COLE, Ian Edward
    5 Meadowbank
    DG10 9LR Moffat
    Dumfries & Galloway
    Administrateur
    5 Meadowbank
    DG10 9LR Moffat
    Dumfries & Galloway
    British79462900002
    DONNACHIE, Gerard
    C/O Thomas Barrie & Co
    Atlantic Chambers
    G2 6QE 1a Cadogan Street
    Glasgow
    Administrateur
    C/O Thomas Barrie & Co
    Atlantic Chambers
    G2 6QE 1a Cadogan Street
    Glasgow
    United KingdomBritish602380003
    FERGUSON, Allan Robert Lymburn
    58 Main Road
    Fenwick
    KA3 6AL Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    58 Main Road
    Fenwick
    KA3 6AL Kilmarnock
    Ayrshire
    British4618160001
    GILES, Andrew
    14 Cutstraw Road
    KA3 5HX Stewarton
    Ayrshire
    Administrateur
    14 Cutstraw Road
    KA3 5HX Stewarton
    Ayrshire
    British35758120002
    HEATH, David
    39 Polwarth Street
    Hyndland
    G12 9UE Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    39 Polwarth Street
    Hyndland
    G12 9UE Glasgow
    Lanarkshire
    British64815190001
    MACPHAIL, Stuart
    22 Culzean Place
    Stenhousemuir
    FK5 4UD Larbert
    Stirlingshire
    Administrateur
    22 Culzean Place
    Stenhousemuir
    FK5 4UD Larbert
    Stirlingshire
    British52759320001
    MCDOWALL, Duncan William
    68 Balfour Court
    KA3 7TE Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    68 Balfour Court
    KA3 7TE Kilmarnock
    Ayrshire
    British1340810002
    MILLER, John
    13 Rogerhill Gait
    Blackwood
    ML11 9XR Lanark
    Lanarkshire
    Administrateur
    13 Rogerhill Gait
    Blackwood
    ML11 9XR Lanark
    Lanarkshire
    British45748630001
    PARK, Douglas Ireland
    C/O Thomas Barrie & Co
    Atlantic Chambers
    G2 6QE 1a Cadogan Street
    Glasgow
    Administrateur
    C/O Thomas Barrie & Co
    Atlantic Chambers
    G2 6QE 1a Cadogan Street
    Glasgow
    GibraltarBritish333600008
    RANSON, Gary
    1 Lerwick Place
    KA3 2HS Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    1 Lerwick Place
    KA3 2HS Kilmarnock
    Ayrshire
    British46266020001
    SANSUM, Bryan Ralph William
    61 Rowallan Drive
    KA3 1TU Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    61 Rowallan Drive
    KA3 1TU Kilmarnock
    Ayrshire
    British46265980001
    SIM, Iain Daniel
    32 Rugby Road
    KA1 2DQ Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    32 Rugby Road
    KA1 2DQ Kilmarnock
    Ayrshire
    ScotlandBritish85699870001
    TERRAS, Jacqueline Mary
    93 Dundonald Road
    KA1 1TQ Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    93 Dundonald Road
    KA1 1TQ Kilmarnock
    Ayrshire
    ScotlandBritish4653970001
    WYPER, Elizabeth Anne
    3 Glen Orrin Avenue
    KA2 0LR Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    3 Glen Orrin Avenue
    KA2 0LR Kilmarnock
    Ayrshire
    British6579310002
    WYPER, Robert Littlejohn
    70 London Road
    KA3 7DD Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    70 London Road
    KA3 7DD Kilmarnock
    Ayrshire
    ScotlandScottish6579320001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ROBERT WYPER (MOTORS) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Park's Of Hamilton (Holdings) Limited
    Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    14
    Scotland
    06 avr. 2016
    Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    14
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementUk Register Of Companies
    Numéro d'enregistrementSc066568
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    ROBERT WYPER (MOTORS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 22 avr. 1997
    Livré le 25 avr. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    100 heathfield road,ayr.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 avr. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 22 avr. 1997
    Livré le 25 avr. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    9/11 wellington street,kilmarnock.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 avr. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 22 avr. 1997
    Livré le 25 avr. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Corsehill mount road,irvine.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 avr. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 22 avr. 1997
    Livré le 25 avr. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    27/33 west langlands street,kilmarnock.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 avr. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    Bond & floating charge
    Créé le 18 avr. 1997
    Livré le 28 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nws Trust Limited
    Transactions
    • 28 avr. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 mai 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 23 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 08 janv. 1997
    Livré le 17 janv. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 janv. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 mai 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 juin 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 juin 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 11 nov. 1996
    Livré le 18 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.933 hectares of ground on north-east side of corsehill mount road,irvine,ayrshire.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 nov. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 07 nov. 1995
    Livré le 21 nov. 1995
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    2 acres on the south side of heathfield road, prestwick.
    Personnes ayant droit
    • Mobil Oil Company Limited
    Transactions
    • 21 nov. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 13 févr. 1995
    Livré le 23 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground extending to 2 acres on the south-east side of heathfield road, prestwick.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 févr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 20 janv. 1995
    Livré le 08 févr. 1995
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    9/11 wellington street, kilmarnock.
    Personnes ayant droit
    • Esso Petroleum Company Limited
    Transactions
    • 08 févr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 20 janv. 1995
    Livré le 31 janv. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Areas of ground at 9/11 wellington street, kilmarnock.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 31 janv. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 12 juil. 1991
    Livré le 18 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • N W S Bank PLC
    • N W S Bank PLC
    • The Company
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 18 janv. 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 févr. 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 26 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 10 mai 1991
    Livré le 31 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    West langland street, kilmarnock.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 31 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 24 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 20 févr. 1990
    Livré le 09 mars 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    9/11 wellington street, kilmarnock.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 mars 1990Enregistrement d'une charge
    • 24 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 20 févr. 1990
    Livré le 27 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £30,000 and all further sums due or to become due
    Brèves mentions
    9/11 wellington street, kilmarnock.
    Personnes ayant droit
    • Burmah Oil LTD
    Transactions
    • 27 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 13 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 16 oct. 1989
    Livré le 31 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 31 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0