AHR REALISATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAHR REALISATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC119878
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AHR REALISATIONS LIMITED ?

    • (5510) /

    Où se situe AHR REALISATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Erskine House
    68-73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AHR REALISATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AVIEMORE HIGHLAND RESORT LIMITED09 nov. 200109 nov. 2001
    AVIEMORE MOUNTAIN RESORT LIMITED17 déc. 199217 déc. 1992
    MARRSIDE LIMITED01 sept. 198901 sept. 1989

    Quels sont les derniers comptes de AHR REALISATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 sept. 2006

    Quels sont les derniers dépôts pour AHR REALISATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    14 pages2.20B(Scot)

    Avis de passage de l'administration à la dissolution

    1 pages2.26B(Scot)

    Proposition de l'administrateur

    186 pages2.16B(Scot)

    État des affaires avec formulaire 2.14B(Scot)

    3 pages2.15B(Scot)

    Certificat de changement de nom

    Company name changed aviemore highland resort LIMITED\certificate issued on 11/08/09
    3 pagesCERTNM

    État des affaires avec formulaire 2.13B(Scot)

    114 pages2.15B(Scot)

    Nomination d'un administrateur

    3 pages2.11B(Scot)

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    10 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    8 pages363a

    Comptes consolidés établis au 28 sept. 2006

    22 pagesAA

    legacy

    12 pages363a

    legacy

    10 pages363a

    Comptes consolidés établis au 29 sept. 2005

    19 pagesAA

    legacy

    1 pages244

    Qui sont les dirigeants de AHR REALISATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FRASER, Robert Gordon
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    Secrétaire
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    British120322350001
    MCGEE, Jeremiah
    East Terrace
    PH21 1JS Kingussie
    Kildonan
    Inverness Shire
    Administrateur
    East Terrace
    PH21 1JS Kingussie
    Kildonan
    Inverness Shire
    Irish138900330001
    GILLESPIE, Brendan
    56 Blairbeth Road
    Rutherglen
    G73 4JQ Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    56 Blairbeth Road
    Rutherglen
    G73 4JQ Glasgow
    Lanarkshire
    British65199400001
    GOULD, Frederick James
    Stoneygate The Hills
    Bradwell
    S33 9HZ Hope Valley
    Secrétaire
    Stoneygate The Hills
    Bradwell
    S33 9HZ Hope Valley
    British33226530001
    MAUD, Glenn
    Bents House Sugworth
    Bradfield Dale The Strines
    S6 6JA Sheffield
    Secrétaire
    Bents House Sugworth
    Bradfield Dale The Strines
    S6 6JA Sheffield
    British35518970002
    SMITH, David
    Firley
    17 Highlands Road Sear Green
    HP5 2XL Beaconfield
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Firley
    17 Highlands Road Sear Green
    HP5 2XL Beaconfield
    Buckinghamshire
    British74298510001
    BANKIER, Ian Patrick
    Flat 2/2, 168 Crow Road
    G11 7JU Glasgow
    Administrateur
    Flat 2/2, 168 Crow Road
    G11 7JU Glasgow
    ScotlandBritish103178050001
    BLOOM, Desmond Lawrence
    8 Hall Gate
    Hall Road
    NW8 9PG London
    Administrateur
    8 Hall Gate
    Hall Road
    NW8 9PG London
    British84564020001
    BROWNING, Patrick John
    26 Portland Road
    W11 4LG London
    Administrateur
    26 Portland Road
    W11 4LG London
    British8268410001
    BUSBY, James George William
    16 Fairyknowe Court
    Bothwell
    G71 8SZ Glasgow
    Administrateur
    16 Fairyknowe Court
    Bothwell
    G71 8SZ Glasgow
    United KingdomBritish584980007
    COLLINS, David
    122 Prince George Avenue
    N14 4TA London
    Administrateur
    122 Prince George Avenue
    N14 4TA London
    British8643430001
    CONRAD, Neville Simeon
    8 Kensington Palace Gardens
    W8 4QP London
    Administrateur
    8 Kensington Palace Gardens
    W8 4QP London
    British76640680003
    MACDONALD, Donald John
    Cardrona
    Glen Road
    FK15 0DT Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    Cardrona
    Glen Road
    FK15 0DT Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish557590001
    MAUD, Glenn
    Bents House Sugworth
    Bradfield Dale The Strines
    S6 6JA Sheffield
    Administrateur
    Bents House Sugworth
    Bradfield Dale The Strines
    S6 6JA Sheffield
    United KingdomBritish35518970002
    NEWETT, David Ian
    Cockshutt Farm
    Beauchief Abbey Drive Beauchief
    S8 7BB Sheffield
    Administrateur
    Cockshutt Farm
    Beauchief Abbey Drive Beauchief
    S8 7BB Sheffield
    British35554190001
    ROBERTSON, Ian
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish106197810002
    SULLIVAN, Sean Michael
    3 Fairwater Close
    WR11 1GF Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    3 Fairwater Close
    WR11 1GF Evesham
    Worcestershire
    British79118330001
    SUTHERLAND, David Fraser
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    Administrateur
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    ScotlandBritish1321720003
    TAYLOR, David Hunter
    Primrose Villa
    19 Glenbrook
    EH14 7JE Balerno
    Midlothian
    Administrateur
    Primrose Villa
    19 Glenbrook
    EH14 7JE Balerno
    Midlothian
    British70908350001

    AHR REALISATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 30 avr. 2004
    Livré le 30 avr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Two areas of ground lying to the west side of grampian road, aviemore extending to 150 feet and 0.7374 acres respectively.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 avr. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 29 avr. 2004
    Livré le 30 avr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land forming a visibility splay at grampian road, aviemore and the subjects lying to the west of grampian road, aviemore (title number INV6274).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 avr. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 15 avr. 2004
    Livré le 16 avr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The area of ground extending to 3651 square metres or thereby lying to the rear of the cairngorm hotel, aviemore--title number INV3598.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 avr. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 09 mai 2003
    Livré le 12 mai 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    517.37 square metres & 233.40 square metres at aviemore.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 mai 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 10 avr. 1997
    Livré le 17 avr. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Four seasons,grampian road,aviemore,invernessshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 avr. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 23 août 1994
    Livré le 13 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The waverley hotel,york place,perth including the properties formerly numbered 25 and 27 york place,perth.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 sept. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 02 avr. 1993
    Livré le 08 avr. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The aviemore centre, aviemore (see paper apart to document).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 avr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 02 avr. 1993
    Livré le 08 avr. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The red macgregor hotel, aviemore, inverness (see paper apart to document).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 avr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 30 mars 1993
    Livré le 08 avr. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 avr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 févr. 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    Standard security
    Créé le 11 août 1992
    Livré le 17 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    7 dwellinghouses in aviemore.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 août 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 févr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 05 août 1992
    Livré le 14 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Aviemore centre, aviemore, inverness.
    Personnes ayant droit
    • Scottish & Newcastle PLC
    Transactions
    • 14 août 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 juil. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 03 août 1992
    Livré le 05 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Scottish & Newcastle PLC
    Transactions
    • 05 août 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 déc. 1992Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 29 sept. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 14 juil. 1992
    Livré le 23 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The aviemore centre aviemore.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 juil. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 29 juin 1992
    Livré le 15 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 juil. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 déc. 1992Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 07 juil. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    AHR REALISATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 juin 2010Administration ended
    19 juin 2009Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John Bruce Cartwright
    Pricewaterhousecoopers Llp Erskine House
    68-73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp Erskine House
    68-73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    Graham Douglas Frost
    Erskine House
    68-73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    practitioner
    Erskine House
    68-73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0