CABLETEL SCOTLAND LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CABLETEL SCOTLAND LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC119938 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CABLETEL SCOTLAND LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1 South Gyle Crescent Lane EH12 9EG Edinburgh |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CABLETEL SCOTLAND LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour CABLETEL SCOTLAND LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 11 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Cessation de Virin Media Communications Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 nov. 2018 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Notification de Virgin Media Investment Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 nov. 2018 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 03 oct. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2017 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 03 oct. 2017 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2016 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 03 oct. 2016 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 16 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 29 déc. 2015
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 03 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 03 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Caroline Withers en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mine Ozkan Hifzi en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Gale en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Robert Dominic Dunn en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 03 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de CABLETEL SCOTLAND LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMES, Gillian Elizabeth | Secrétaire | Great Portland Street W1W 5QA London 160 London United Kingdom | 151008790001 | |||||||
| DUNN, Robert Dominic | Administrateur | South Gyle Crescent Lane EH12 9EG Edinburgh 1 | England | British | 179134020002 | |||||
| HIFZI, Mine Ozkan | Administrateur | South Gyle Crescent Lane EH12 9EG Edinburgh 1 | England | British | 182167230001 | |||||
| JAMES, Gillian Elizabeth | Secrétaire | 148 Selwyn Avenue Highams Park E4 9LS London | British | 72139660001 | ||||||
| LUBASCH, Richard Joel | Secrétaire | 4 Beech Tree Lane NEW YORK Brookville 11545 Usa | British | 81075820001 | ||||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Secrétaire | Ranelagh Avenue SW6 3PJ London 19 | British | 47785600002 | ||||||
| MORRISH, John Sutherland Cavers | Secrétaire | 5 Chesters Road Bearsden G61 4AQ Glasgow Lanarkshire | British | 3673640001 | ||||||
| VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107380002 | |||||||
| CAMPBELL, David Ross | Administrateur | Summerlea Summerlea Road KA23 9HP Seamill Ayrshire | British | 651850003 | ||||||
| CARTER, Stephen Andrew | Administrateur | 22 Melville Road Barnes SW13 9RJ London | United Kingdom | British | 59445920002 | |||||
| COLLINS, Christopher Andrew | Administrateur | Maple Leaf 27 The Paddocks CM8 2DR Witham Essex | British | 1269700001 | ||||||
| GALE, Robert Charles | Administrateur | Great Portland Street W1W 5QA London 160 London United Kingdom | England | British | 96956740001 | |||||
| GALE, Robert Charles | Administrateur | Station Road KT7 0NS Thames Ditton 42 Surrey | England | British | 96956740001 | |||||
| GREGG, John Francis | Administrateur | 411 Silvermoss Drive Vero Beach Florida 32963 America | American | 75381740001 | ||||||
| HEIDARY, Hamid Reza | Administrateur | Fairways West Hill Golf Course Bagshot Road GU22 0QZ Worplesdon Hill Surrey | American | 48966390001 | ||||||
| JAFFE, Brenard William | Administrateur | New Mercury House 26 Red Lion Square London | British | 3673630001 | ||||||
| KELHAM, David William | Administrateur | Chastilian Gough Road GU51 4LJ Fleet Hampshire | England | British | 87146390001 | |||||
| KELLY, David Michael, Dr | Administrateur | 50 Aytoun Road Pollokshields G41 5HE Glasgow Lanarkshire | Great Britain | British | 60588290001 | |||||
| KNAPP, Barclay | Administrateur | 59 Battle Road Princeton 08540 New Jersey 08540 Usa | American | 41358150002 | ||||||
| KNAPP, James Barclay | Administrateur | 54 Hodge Road Princeton New Jersey 08540 Usa | Us Citizen | 79688880001 | ||||||
| MACGREGOR, Ian Kinloch | Administrateur | Castleton House PA31 8RU Lochgilphead Argyll | British | 1414360003 | ||||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Administrateur | Great Portland Street W1W 5QA London 160 London United Kingdom | United Kingdom | British | 47785600002 | |||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Administrateur | Ranelagh Avenue SW6 3PJ London 19 | United Kingdom | British | 47785600002 | |||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Administrateur | Ranelagh Avenue SW6 3PJ London 19 | United Kingdom | British | 47785600002 | |||||
| MCKELLAR, Ronald Alexander | Administrateur | Halstead Stratfield Saye RG7 2EJ Reading Berkshire | British | 7345780001 | ||||||
| MORRISH, John Sutherland Cavers | Administrateur | 5 Chesters Road Bearsden G61 4AQ Glasgow Lanarkshire | British | 3673640001 | ||||||
| RICHARDSON, G M J | Administrateur | Liguanea 66 Braywick Road Maidenhead Berks | British | 3673600001 | ||||||
| RICHTER, Bret | Administrateur | 245 East 63rd Street Apartment 20h 10021 New York New York United States | American | 86830760001 | ||||||
| ROBERTS, Gareth Nigel Christopher | Administrateur | 20 Aspen Lodge Abbots Walk W8 5UN London | British | 145824690001 | ||||||
| ROSS, Stuart | Administrateur | 15 Mckay Road SW20 0HT London | England | British | 20168110001 | |||||
| SCHUBERT, Scott Elliott | Administrateur | 9 William Street House William Street SW1X 9HH London | American | 89618040001 | ||||||
| STEWART, Alexander Donald | Administrateur | Ardvorlich FK19 8QE Lochearnhead Perthshire | United Kingdom | British | 51250001 | |||||
| TILLBROOK, Joanne Christine | Administrateur | South Gyle Crescent Lane EH12 9EG Edinburgh 1 Scotland | United Kingdom | British | 164134250001 | |||||
| TILLBROOK, Joanne Christine | Administrateur | South Gyle Crescent Lane EH12 9EG Edinburgh 1 Scotland | United Kingdom | British | 164134250001 | |||||
| WILLNER, Michael S | Administrateur | 33 Kings Court Fort Lee FOREIGN New Jersey 07024 Usa | American | 28953000001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CABLETEL SCOTLAND LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virgin Media Investment Holdings Limited | 28 nov. 2018 | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Virin Media Communications Limited | 06 avr. 2016 | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
CABLETEL SCOTLAND LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Composite debenture | Créé le 29 juin 2010 Livré le 09 juil. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Confirmation deed | Créé le 15 avr. 2010 Livré le 30 avr. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirms all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Confirmation deed | Créé le 15 avr. 2010 Livré le 30 avr. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirms all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 19 janv. 2010 Livré le 08 févr. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite debenture | Créé le 19 janv. 2010 Livré le 02 févr. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite debenture | Créé le 19 janv. 2010 Livré le 28 janv. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 19 janv. 2010 Livré le 28 janv. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 16 juin 2006 Livré le 04 juil. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Floating charge | Créé le 16 juin 2006 Livré le 04 juil. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Floating charge | Créé le 03 mars 2006 Livré le 22 mars 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 03 mars 2006 Livré le 22 mars 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Floating charge | Créé le 13 avr. 2004 Livré le 30 avr. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due under any or all of the finance documents | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over assets - see mortgage document for full details. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 27 sept. 2001 Livré le 03 oct. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All obligations as contained in the finance documents | |
Brèves mentions Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 21 févr. 2001 Livré le 06 mars 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All obligations pursuant to the finance documents | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over assets..SE ch microfiche for full details. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 17 oct. 1997 Livré le 04 nov. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignation in security | Créé le 20 avr. 1990 Livré le 04 mai 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The whole right, title and interest in and to call for and receive payment of the sum of £2,700,000 or any part thereof remaining uncalled on the 3,000,000 "b" convertible ordinary shares of £1 each of the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0