EDI (INDUSTRIAL) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | EDI (INDUSTRIAL) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC119939 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe EDI (INDUSTRIAL) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Waverley Court 4 East Market Street EH8 8BG Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de EDI (INDUSTRIAL) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour EDI (INDUSTRIAL) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Modification des détails de The Edi Group Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 juin 2018 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 janv. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Nomination de Cllr Lezley Marion Cameron en tant qu'administrateur le 11 juil. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Cllr Iain Whyte en tant qu'administrateur le 11 juil. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Eric Weir Adair en tant que directeur le 30 juin 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Cllr Katherine Rosa Campbell en tant qu'administrateur le 11 juil. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 7 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 3 Cockburn Street Edinburgh EH1 1QB Scotland à Waverley Court 4 East Market Street Edinburgh EH8 8BG le 19 juin 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 janv. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 janv. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 7 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 7/9 North St. David Street Edinburgh EH2 1AW à 3 Cockburn Street Edinburgh EH1 1QB le 24 juil. 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 10 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 10 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 7 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Dolphin House 4 Hunter Square Edinburgh EH1 1QW* le 08 avr. 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 10 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 7 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Tom Buchanan en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de EDI (INDUSTRIAL) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMERON, Lezley Marion, Cllr | Administrateur | 4 East Market Street EH8 8BG Edinburgh Waverley Court Scotland | Scotland | British | 77460160001 | |||||
| CAMPBELL, Katherine Rosa | Administrateur | 4 East Market Street EH8 8BG Edinburgh Waverley Court Scotland | United Kingdom | British | 233686000001 | |||||
| WHYTE, Iain, Cllr | Administrateur | 4 East Market Street EH8 8BG Edinburgh Waverley Court Scotland | Scotland | British | 148139080002 | |||||
| BLYTH, William | Secrétaire | Carradale 516 Lanark Road West EH14 7DH Balerno Midlothian | British | 514950001 | ||||||
| MCGOWAN, Carol Ann | Secrétaire | 374 Leith Walk EH7 4PE Edinburgh Midlothian | British | 112664200001 | ||||||
| WILSON, Mary | Secrétaire | 3 Belgrave Road EH12 6NG Edinburgh | British | 42188180001 | ||||||
| ADAIR, Eric Weir | Administrateur | 4 East Market Street EH8 8BG Edinburgh Waverley Court Scotland | Scotland | British | 116185430001 | |||||
| AITCHISON, Thomas Nisbet | Administrateur | 27 Dudley Terrace EH6 4QQ Edinburgh | British | 43674840001 | ||||||
| ANDERSON, Donald Craig | Administrateur | 39 The Spinney EH17 7LE Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 48629740001 | |||||
| ATKINSON, Elspeth, Dr | Administrateur | The Rectory 203 Gilmore Place EH3 9PN Edinburgh | British | 51045490001 | ||||||
| BARRETT, John | Administrateur | 3 Traquair Park West EH12 7AN Edinburgh Midlothian | British | 728540001 | ||||||
| BEGG, David, Councillor | Administrateur | 29/9 Castle Terrace EH1 2EL Edinburgh | British | 48777780002 | ||||||
| BLYTH, William | Administrateur | Carradale 516 Lanark Road West EH14 7DH Balerno Midlothian | British | 514950001 | ||||||
| BUCHANAN, Tom | Administrateur | Dolphin House 4 Hunter Square EH1 1QW Edinburgh | United Kingdom | British | 123330960001 | |||||
| CAMERON, Lezley Marion, Cllr | Administrateur | 12/5 Mayfield Terrace EH9 1SA Edinburgh | Scotland | British | 77460160001 | |||||
| DALGETY, Susan | Administrateur | 16 Temple Park Crescent EH11 1HT Edinburgh | British | 103240003 | ||||||
| DI CIACCA, John Mark | Administrateur | Main Road KY11 1HA North Queensferry The Red Post Fife | United Kingdom | British | 77111830002 | |||||
| DREVER, Peng Geik | Administrateur | 13 Northumberland Street EH3 6LL Edinburgh Midlothian | Malaysian | 69597360001 | ||||||
| GEDDES, Keith Taylor | Administrateur | 9 Willowbrae Avenue EH8 7HB Edinburgh Midlothian | British | 975490001 | ||||||
| GILCHRIST, James | Administrateur | 21 Heriot Row EH3 6EN Edinburgh Midlothian | British | 318630002 | ||||||
| GILMORE, Sheila | Administrateur | 16 St Catherines Place EH9 1NU Edinburgh Midlothian Scotland | Uk | British | 27232470001 | |||||
| GILMORE, Sheila | Administrateur | 16 St Catherines Place EH9 1NU Edinburgh Midlothian Scotland | Uk | British | 27232470001 | |||||
| GORRIE, Donald Cameron Easterbrook | Administrateur | 9 Garscube Terrace EH12 6BW Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 76140001 | |||||
| HINDS, Lesley Adelaide | Administrateur | 4 Easter Drylaw Place EH4 2QD Edinburgh Lothian | Scotland | British | 3480180001 | |||||
| HUNTER, Colin Ian | Administrateur | Stonelaws Farm EH40 3DX East Linton East Lothian | Scotland | British | 37329910003 | |||||
| KENNEDY, Sheila | Administrateur | 30 House O'Hill Road EH4 2AN Edinburgh | British | 35269940001 | ||||||
| KENNEDY, Sheila | Administrateur | 30 House O'Hill Road EH4 2AN Edinburgh | British | 35269940001 | ||||||
| KEREVAN, George | Administrateur | Brunstane House South Wing Brunstane Road South EH15 2NQ Edinburgh | Scotland | British | 660740002 | |||||
| LAZAROWICZ, Marek Jerzy | Administrateur | 97 Marchmont Road EH9 1HB Edinburgh Lothian | British | 6335060002 | ||||||
| LOWENBERG, Paul George | Administrateur | 37 Salisbury Road EH16 5AA Edinburgh Midlothian | American | 70889900001 | ||||||
| MACKAY, Angus John | Administrateur | 84 Liberton Brae EH16 6LB Edinburgh | Scotland | British | 48624810001 | |||||
| MACKINTOSH, Hugh Frederick Dundas | Administrateur | 204 Dalkeith Road EH16 5DT Edinburgh Midlothian | British | 71329550001 | ||||||
| MARSHALL, Robert Alexander | Administrateur | Flat 1 Silverknowes Road 3 Silverknowes Road EH4 5NX Edinburgh Midlothian | British | 648950001 | ||||||
| PERRY, Ian | Administrateur | Lilyhill Terrace EH8 7DR Edinburgh 49 | Scotland | British | 127893650001 | |||||
| PERRY, Ian | Administrateur | Lilyhill Terrace EH8 7DR Edinburgh 49 | Scotland | British | 127893650001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EDI (INDUSTRIAL) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Edi Group Limited | 01 juin 2016 | East Market Street EH8 8BG EH8 8BG Edinburgh 4 Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
EDI (INDUSTRIAL) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Créé le 26 nov. 2008 Livré le 03 déc. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Unit 10B kings haugh, peffermill industrial estate, peffermill road, edinburgh. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 05 févr. 2008 Livré le 14 févr. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Generally knowns as peffermill industrial estate, edinburgh. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 05 févr. 2008 Livré le 14 févr. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Subjects generally known as 7,9,9A,9B,9C,10,11,12,12A,13-15, 16-22, 23 & 24 south gyle crescent, edinburgh. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 29 janv. 2008 Livré le 01 févr. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignation of rents | Créé le 02 juin 2005 Livré le 10 juin 2005 | En cours | Montant garanti All sums due under or in connection with the finance documents | |
Brèves mentions The company's whole right, title, benefit and interest whether at the charge date or in the future to the rental income pursuant to each of the scheduled leases of the property at peffermill industrial estate, edinburgh. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignation of rents | Créé le 02 juin 2005 Livré le 10 juin 2005 | En cours | Montant garanti All sums due under or in connection with the finance documents | |
Brèves mentions The company's whole right, title, benefit and interest whether at the charge date or in the future in and to the rental income in relation to the lease of the property at south gyle crescent, edinburgh. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 01 juin 2005 Livré le 10 juin 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due under or in connection with the finance documents | |
Brèves mentions All those subjects at south gyle crescent, edinburgh. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 01 juin 2005 Livré le 10 juin 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due under or in connection with the finance documents | |
Brèves mentions Those subjects at peffermill industrial estate, edinburgh. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 26 mai 2005 Livré le 10 juin 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due under or in connection with the finance documents | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0