EDI (INDUSTRIAL) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEDI (INDUSTRIAL) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC119939
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EDI (INDUSTRIAL) LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction
    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières
    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe EDI (INDUSTRIAL) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Waverley Court
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EDI (INDUSTRIAL) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ENTERPRISE EDINBURGH SERVICES LIMITED10 janv. 199010 janv. 1990
    PACIFIC SHELF 279 LIMITED04 sept. 198904 sept. 1989

    Quels sont les derniers comptes de EDI (INDUSTRIAL) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour EDI (INDUSTRIAL) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Modification des détails de The Edi Group Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 juin 2018

    2 pagesPSC05

    Déclaration de confirmation établie le 10 janv. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Cllr Lezley Marion Cameron en tant qu'administrateur le 11 juil. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Cllr Iain Whyte en tant qu'administrateur le 11 juil. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Eric Weir Adair en tant que directeur le 30 juin 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Cllr Katherine Rosa Campbell en tant qu'administrateur le 11 juil. 2018

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    7 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 3 Cockburn Street Edinburgh EH1 1QB Scotland à Waverley Court 4 East Market Street Edinburgh EH8 8BG le 19 juin 2018

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 10 janv. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    7 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 7/9 North St. David Street Edinburgh EH2 1AW à 3 Cockburn Street Edinburgh EH1 1QB le 24 juil. 2016

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 janv. 2016

    État du capital au 19 janv. 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 janv. 2015

    État du capital au 12 janv. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    7 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * Dolphin House 4 Hunter Square Edinburgh EH1 1QW* le 08 avr. 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 janv. 2014

    État du capital au 14 janv. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Tom Buchanan en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de EDI (INDUSTRIAL) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CAMERON, Lezley Marion, Cllr
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    Administrateur
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    ScotlandBritish77460160001
    CAMPBELL, Katherine Rosa
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    Administrateur
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    United KingdomBritish233686000001
    WHYTE, Iain, Cllr
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    Administrateur
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    ScotlandBritish148139080002
    BLYTH, William
    Carradale 516 Lanark Road West
    EH14 7DH Balerno
    Midlothian
    Secrétaire
    Carradale 516 Lanark Road West
    EH14 7DH Balerno
    Midlothian
    British514950001
    MCGOWAN, Carol Ann
    374 Leith Walk
    EH7 4PE Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    374 Leith Walk
    EH7 4PE Edinburgh
    Midlothian
    British112664200001
    WILSON, Mary
    3 Belgrave Road
    EH12 6NG Edinburgh
    Secrétaire
    3 Belgrave Road
    EH12 6NG Edinburgh
    British42188180001
    ADAIR, Eric Weir
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    Administrateur
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    ScotlandBritish116185430001
    AITCHISON, Thomas Nisbet
    27 Dudley Terrace
    EH6 4QQ Edinburgh
    Administrateur
    27 Dudley Terrace
    EH6 4QQ Edinburgh
    British43674840001
    ANDERSON, Donald Craig
    39 The Spinney
    EH17 7LE Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    39 The Spinney
    EH17 7LE Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish48629740001
    ATKINSON, Elspeth, Dr
    The Rectory 203 Gilmore Place
    EH3 9PN Edinburgh
    Administrateur
    The Rectory 203 Gilmore Place
    EH3 9PN Edinburgh
    British51045490001
    BARRETT, John
    3 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    3 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    British728540001
    BEGG, David, Councillor
    29/9 Castle Terrace
    EH1 2EL Edinburgh
    Administrateur
    29/9 Castle Terrace
    EH1 2EL Edinburgh
    British48777780002
    BLYTH, William
    Carradale 516 Lanark Road West
    EH14 7DH Balerno
    Midlothian
    Administrateur
    Carradale 516 Lanark Road West
    EH14 7DH Balerno
    Midlothian
    British514950001
    BUCHANAN, Tom
    Dolphin House
    4 Hunter Square
    EH1 1QW Edinburgh
    Administrateur
    Dolphin House
    4 Hunter Square
    EH1 1QW Edinburgh
    United KingdomBritish123330960001
    CAMERON, Lezley Marion, Cllr
    12/5 Mayfield Terrace
    EH9 1SA Edinburgh
    Administrateur
    12/5 Mayfield Terrace
    EH9 1SA Edinburgh
    ScotlandBritish77460160001
    DALGETY, Susan
    16 Temple Park Crescent
    EH11 1HT Edinburgh
    Administrateur
    16 Temple Park Crescent
    EH11 1HT Edinburgh
    British103240003
    DI CIACCA, John Mark
    Main Road
    KY11 1HA North Queensferry
    The Red Post
    Fife
    Administrateur
    Main Road
    KY11 1HA North Queensferry
    The Red Post
    Fife
    United KingdomBritish77111830002
    DREVER, Peng Geik
    13 Northumberland Street
    EH3 6LL Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    13 Northumberland Street
    EH3 6LL Edinburgh
    Midlothian
    Malaysian69597360001
    GEDDES, Keith Taylor
    9 Willowbrae Avenue
    EH8 7HB Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    9 Willowbrae Avenue
    EH8 7HB Edinburgh
    Midlothian
    British975490001
    GILCHRIST, James
    21 Heriot Row
    EH3 6EN Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    21 Heriot Row
    EH3 6EN Edinburgh
    Midlothian
    British318630002
    GILMORE, Sheila
    16 St Catherines Place
    EH9 1NU Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Administrateur
    16 St Catherines Place
    EH9 1NU Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    UkBritish27232470001
    GILMORE, Sheila
    16 St Catherines Place
    EH9 1NU Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Administrateur
    16 St Catherines Place
    EH9 1NU Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    UkBritish27232470001
    GORRIE, Donald Cameron Easterbrook
    9 Garscube Terrace
    EH12 6BW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    9 Garscube Terrace
    EH12 6BW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish76140001
    HINDS, Lesley Adelaide
    4 Easter Drylaw Place
    EH4 2QD Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    4 Easter Drylaw Place
    EH4 2QD Edinburgh
    Lothian
    ScotlandBritish3480180001
    HUNTER, Colin Ian
    Stonelaws Farm
    EH40 3DX East Linton
    East Lothian
    Administrateur
    Stonelaws Farm
    EH40 3DX East Linton
    East Lothian
    ScotlandBritish37329910003
    KENNEDY, Sheila
    30 House O'Hill Road
    EH4 2AN Edinburgh
    Administrateur
    30 House O'Hill Road
    EH4 2AN Edinburgh
    British35269940001
    KENNEDY, Sheila
    30 House O'Hill Road
    EH4 2AN Edinburgh
    Administrateur
    30 House O'Hill Road
    EH4 2AN Edinburgh
    British35269940001
    KEREVAN, George
    Brunstane House South Wing
    Brunstane Road South
    EH15 2NQ Edinburgh
    Administrateur
    Brunstane House South Wing
    Brunstane Road South
    EH15 2NQ Edinburgh
    ScotlandBritish660740002
    LAZAROWICZ, Marek Jerzy
    97 Marchmont Road
    EH9 1HB Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    97 Marchmont Road
    EH9 1HB Edinburgh
    Lothian
    British6335060002
    LOWENBERG, Paul George
    37 Salisbury Road
    EH16 5AA Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    37 Salisbury Road
    EH16 5AA Edinburgh
    Midlothian
    American70889900001
    MACKAY, Angus John
    84 Liberton Brae
    EH16 6LB Edinburgh
    Administrateur
    84 Liberton Brae
    EH16 6LB Edinburgh
    ScotlandBritish48624810001
    MACKINTOSH, Hugh Frederick Dundas
    204 Dalkeith Road
    EH16 5DT Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    204 Dalkeith Road
    EH16 5DT Edinburgh
    Midlothian
    British71329550001
    MARSHALL, Robert Alexander
    Flat 1 Silverknowes Road
    3 Silverknowes Road
    EH4 5NX Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Flat 1 Silverknowes Road
    3 Silverknowes Road
    EH4 5NX Edinburgh
    Midlothian
    British648950001
    PERRY, Ian
    Lilyhill Terrace
    EH8 7DR Edinburgh
    49
    Administrateur
    Lilyhill Terrace
    EH8 7DR Edinburgh
    49
    ScotlandBritish127893650001
    PERRY, Ian
    Lilyhill Terrace
    EH8 7DR Edinburgh
    49
    Administrateur
    Lilyhill Terrace
    EH8 7DR Edinburgh
    49
    ScotlandBritish127893650001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EDI (INDUSTRIAL) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    East Market Street
    EH8 8BG
    EH8 8BG Edinburgh
    4
    Scotland
    01 juin 2016
    East Market Street
    EH8 8BG
    EH8 8BG Edinburgh
    4
    Scotland
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleScottish Law
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc110956
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    EDI (INDUSTRIAL) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 26 nov. 2008
    Livré le 03 déc. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Unit 10B kings haugh, peffermill industrial estate, peffermill road, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Scotland PLC
    Transactions
    • 03 déc. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 05 févr. 2008
    Livré le 14 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Generally knowns as peffermill industrial estate, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Scotland PLC
    Transactions
    • 14 févr. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 05 févr. 2008
    Livré le 14 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects generally known as 7,9,9A,9B,9C,10,11,12,12A,13-15, 16-22, 23 & 24 south gyle crescent, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Scotland PLC
    Transactions
    • 14 févr. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Bond & floating charge
    Créé le 29 janv. 2008
    Livré le 01 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Scotland PLC
    Transactions
    • 01 févr. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Assignation of rents
    Créé le 02 juin 2005
    Livré le 10 juin 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under or in connection with the finance documents
    Brèves mentions
    The company's whole right, title, benefit and interest whether at the charge date or in the future to the rental income pursuant to each of the scheduled leases of the property at peffermill industrial estate, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch
    Transactions
    • 10 juin 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Assignation of rents
    Créé le 02 juin 2005
    Livré le 10 juin 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under or in connection with the finance documents
    Brèves mentions
    The company's whole right, title, benefit and interest whether at the charge date or in the future in and to the rental income in relation to the lease of the property at south gyle crescent, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch
    Transactions
    • 10 juin 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 01 juin 2005
    Livré le 10 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under or in connection with the finance documents
    Brèves mentions
    All those subjects at south gyle crescent, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch
    Transactions
    • 10 juin 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 01 juin 2005
    Livré le 10 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under or in connection with the finance documents
    Brèves mentions
    Those subjects at peffermill industrial estate, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch
    Transactions
    • 10 juin 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Floating charge
    Créé le 26 mai 2005
    Livré le 10 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under or in connection with the finance documents
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch
    Transactions
    • 10 juin 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0