CARE SUPPORT SCOTLAND LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCARE SUPPORT SCOTLAND LTD
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social
    Numéro de société SC120135
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CARE SUPPORT SCOTLAND LTD ?

    • Activités de travail social sans hébergement pour les personnes âgées et handicapées (88100) / Activités de santé humaine et d'action sociale
    • Autres activités de travail social sans hébergement n.c.a. (88990) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe CARE SUPPORT SCOTLAND LTD ?

    Adresse du siège social
    7 West Adam Street
    EH8 9SX Edinburgh
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CARE SUPPORT SCOTLAND LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WITH YOU LIMITED27 mars 201827 mars 2018
    PLACES FOR PEOPLE SCOTLAND - CARE AND SUPPORT LIMITED21 avr. 200621 avr. 2006
    EDINVAR COMMUNITY CARE LIMITED21 juil. 199721 juil. 1997
    THE SOUTHSIDE CARE PROJECT LIMITED14 sept. 198914 sept. 1989

    Quels sont les derniers comptes de CARE SUPPORT SCOTLAND LTD ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2026
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CARE SUPPORT SCOTLAND LTD ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au01 sept. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation15 sept. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au01 sept. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour CARE SUPPORT SCOTLAND LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de Lauren Hunter en tant que directeur le 08 janv. 2026

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2025

    39 pagesAA

    Cessation de la nomination de Ellen Tomlinson en tant que directeur le 23 déc. 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Kirsteen Jackson en tant que secrétaire le 03 nov. 2025

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 01 sept. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Valerie Alison Macgregor en tant que directeur le 19 sept. 2025

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2024

    41 pagesAA

    Nomination de Mr David Alistair Haig en tant qu'administrateur le 09 déc. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Helen Joan Law en tant que secrétaire le 01 oct. 2024

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs Kirsteen Jackson en tant que secrétaire le 01 oct. 2024

    2 pagesAP03

    Nomination de Mrs Valerie Alison Macgregor en tant qu'administrateur le 25 sept. 2024

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 01 sept. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed with you LIMITED\certificate issued on 30/07/24
    3 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Nomination de Miss Lauren Hunter en tant qu'administrateur le 29 mai 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ailsa Mary Garland en tant que directeur le 29 mai 2024

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 1 Craigmillar Castle Road Craigmillar Castle Road Edinburgh EH16 4BX Scotland à 7 West Adam Street Edinburgh EH8 9SX le 07 févr. 2024

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Sharron Elsdon en tant que directeur le 07 nov. 2023

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées du secrétaire Joan Law le 05 déc. 2023

    1 pagesCH03

    Comptes annuels établis au 31 mars 2023

    40 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 sept. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Hays Business Centre 4 Hay Avenue Edinburgh EH16 4AQ Scotland à 1 Craigmillar Castle Road Craigmillar Castle Road Edinburgh EH16 4BX le 02 août 2023

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Derek Wallace en tant que directeur le 04 juin 2023

    1 pagesTM01

    Nomination de Joan Law en tant que secrétaire le 17 mai 2023

    2 pagesAP03

    Nomination de Ms Jenifer Stirton en tant qu'administrateur le 01 mars 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Ellen Tomlinson en tant qu'administrateur le 01 mars 2023

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de CARE SUPPORT SCOTLAND LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ARBUTHNOTT, Julie
    West Adam Street
    EH8 9SX Edinburgh
    7
    Scotland
    Administrateur
    West Adam Street
    EH8 9SX Edinburgh
    7
    Scotland
    ScotlandScottish306262340001
    HAIG, David Alistair
    West Adam Street
    EH8 9SX Edinburgh
    7
    Scotland
    Administrateur
    West Adam Street
    EH8 9SX Edinburgh
    7
    Scotland
    ScotlandBritish330170390001
    PRIOR, Jane Elizabeth, Dr
    West Adam Street
    EH8 9SX Edinburgh
    7
    Scotland
    Administrateur
    West Adam Street
    EH8 9SX Edinburgh
    7
    Scotland
    United KingdomBritish92010350001
    STIRTON, Jenifer
    West Adam Street
    EH8 9SX Edinburgh
    7
    Scotland
    Administrateur
    West Adam Street
    EH8 9SX Edinburgh
    7
    Scotland
    ScotlandBritish306341330001
    BURLEY, Robin
    Eskhill House 15 Inveresk Village
    EH21 7TD Musselburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    Eskhill House 15 Inveresk Village
    EH21 7TD Musselburgh
    Midlothian
    British31966230001
    FORSYTH, Helen Lucy
    The Owl House
    Blanerne
    TD11 3PZ Duns
    Berwickshire
    Secrétaire
    The Owl House
    Blanerne
    TD11 3PZ Duns
    Berwickshire
    British76574860001
    JACKSON, Kirsteen
    West Adam Street
    EH8 9SX Edinburgh
    7
    Scotland
    Secrétaire
    West Adam Street
    EH8 9SX Edinburgh
    7
    Scotland
    327760640001
    JENNINGS, Richard
    Hay Avenue
    EH16 4RW Edinburgh
    1
    Scotland
    Secrétaire
    Hay Avenue
    EH16 4RW Edinburgh
    1
    Scotland
    221660910001
    LAW, Helen Joan
    Craigmillar Castle Road
    EH16 4BX Edinburgh
    1 Craigmillar Castle Road
    Scotland
    Secrétaire
    Craigmillar Castle Road
    EH16 4BX Edinburgh
    1 Craigmillar Castle Road
    Scotland
    309122400002
    MURRAY, Rhona
    4 Hay Avenue
    EH16 4AQ Edinburgh
    Hays Business Centre
    Scotland
    Secrétaire
    4 Hay Avenue
    EH16 4AQ Edinburgh
    Hays Business Centre
    Scotland
    244014090001
    MURRAY, Rhona
    2 Forth Terrace
    Dalmeny Station
    EH30 9JT South Queensferry
    Edinburgh
    Secrétaire
    2 Forth Terrace
    Dalmeny Station
    EH30 9JT South Queensferry
    Edinburgh
    British101147490001
    STEELE, Alister
    Coltbridge Avenue
    EH12 6AH Edinburgh
    38
    Scotland
    Secrétaire
    Coltbridge Avenue
    EH12 6AH Edinburgh
    38
    Scotland
    200551720001
    TAYLOR, Christopher Frank
    King Park House
    Poldrate
    EH41 4DA Haddington
    East Lothian
    Secrétaire
    King Park House
    Poldrate
    EH41 4DA Haddington
    East Lothian
    British45800260003
    THOMSON, Elizabeth
    79 Henderson Row
    EH3 5BE Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    79 Henderson Row
    EH3 5BE Edinburgh
    Midlothian
    British759910002
    AITKEN, Robert
    7 Hillpark Green
    EH4 7TB Edinburgh
    Administrateur
    7 Hillpark Green
    EH4 7TB Edinburgh
    Northern IrelandBritish89248530001
    ANDERSON, Nigel
    8 Drumdryan Street
    EH3 9LA Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    8 Drumdryan Street
    EH3 9LA Edinburgh
    Midlothian
    British60120420001
    BARCLAY, Irene
    133 Nigel Rise
    Dedridge
    EH54 6LX Livingston
    West Lothian
    Scotland
    Administrateur
    133 Nigel Rise
    Dedridge
    EH54 6LX Livingston
    West Lothian
    Scotland
    British50499160002
    BOWMAN, Rowena Mary
    106 Raeburn Place
    EH4 1HH Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    106 Raeburn Place
    EH4 1HH Edinburgh
    Midlothian
    British759920001
    BROWN, Jane
    Whytbank Row
    Clovenfords
    TD1 3NE Galashiels
    13
    Selkirkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Whytbank Row
    Clovenfords
    TD1 3NE Galashiels
    13
    Selkirkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish125184790002
    CHRISTIE, Therese
    49 Pleasance
    EH8 9TN Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    49 Pleasance
    EH8 9TN Edinburgh
    Lothian
    British60120260001
    CHRISTIE, Therese
    49 Pleasance
    EH8 9TN Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    49 Pleasance
    EH8 9TN Edinburgh
    Lothian
    British60120260001
    CLARK, Moira Elizabeth
    18 Learmonth Gardens
    EH4 1HB Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    18 Learmonth Gardens
    EH4 1HB Edinburgh
    Midlothian
    British777340002
    COOPER, Stewart Douglas Johnstone
    9 Blackwood Green
    KY11 8QG Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    9 Blackwood Green
    KY11 8QG Dunfermline
    Fife
    United KingdomBritish85655900001
    COSENS, Sorrel Emma
    Hope Lane
    EH15 3AW Edinburgh
    63
    Scotland
    Administrateur
    Hope Lane
    EH15 3AW Edinburgh
    63
    Scotland
    ScotlandBritish204177720002
    CUMMING, Richie
    Strawfrank Road
    Carstairs Junction
    ML11 8RE Lanark
    64
    Scotland
    Administrateur
    Strawfrank Road
    Carstairs Junction
    ML11 8RE Lanark
    64
    Scotland
    ScotlandBritish245321720001
    DICK, Connie
    98 Beech Place
    EH54 6RE Livingston
    West Lothian
    Scotland
    Administrateur
    98 Beech Place
    EH54 6RE Livingston
    West Lothian
    Scotland
    British50499280001
    DUNBAR, Gordon John
    4 Hay Avenue
    EH16 4AQ Edinburgh
    Hays Business Centre
    Scotland
    Administrateur
    4 Hay Avenue
    EH16 4AQ Edinburgh
    Hays Business Centre
    Scotland
    ScotlandBritish252471880001
    DUNCAN, Mike
    79 Talisman Rise
    Dedridge
    EH54 6PN Livingston
    West Lothian
    Scotland
    Administrateur
    79 Talisman Rise
    Dedridge
    EH54 6PN Livingston
    West Lothian
    Scotland
    British50498100001
    ELSDON, Sharron
    Craigmillar Castle Road
    EH16 4BX Edinburgh
    1 Craigmillar Castle Road
    Scotland
    Administrateur
    Craigmillar Castle Road
    EH16 4BX Edinburgh
    1 Craigmillar Castle Road
    Scotland
    ScotlandBritish306218930001
    FINDLAY, Norma
    32 Stoneyhill Place
    EH21 6TN Musselburgh
    Administrateur
    32 Stoneyhill Place
    EH21 6TN Musselburgh
    British79499010002
    FLOWER, Samantha
    Hay Avenue
    EH16 4AQ Edinburgh
    4
    Scotland
    Administrateur
    Hay Avenue
    EH16 4AQ Edinburgh
    4
    Scotland
    ScotlandBritish260652060001
    FORD, Sandy
    7 Macnair Avenue
    EH39 4QY North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    7 Macnair Avenue
    EH39 4QY North Berwick
    East Lothian
    British49777150001
    FRASER, Louise Margaret
    Ferry Road
    EH5 3NP Edinburgh
    312
    Scotland
    Administrateur
    Ferry Road
    EH5 3NP Edinburgh
    312
    Scotland
    ScotlandBritish117786960001
    FREIR, Valerie Elizabeth
    Space
    11 Harewood Road
    EH16 4NT Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Space
    11 Harewood Road
    EH16 4NT Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish173586760001
    GAFFNEY, Francine Anne
    26 Promenade
    Portobello
    EH15 1HH Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Administrateur
    26 Promenade
    Portobello
    EH15 1HH Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    British27240000001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CARE SUPPORT SCOTLAND LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Places For People Group Limited
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    06 avr. 2016
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    Oui
    Forme juridiqueCompany Limited By Guarantee
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleCompany'S Act 2000
    Lieu d'enregistrementRegistered As A Company Limited By Guarantee
    Numéro d'enregistrement3777027
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour CARE SUPPORT SCOTLAND LTD ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    21 mars 2018La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0