CASTLE PROPERTIES (SCARBOROUGH) LIMITED

CASTLE PROPERTIES (SCARBOROUGH) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCASTLE PROPERTIES (SCARBOROUGH) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC121297
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CASTLE PROPERTIES (SCARBOROUGH) LIMITED ?

    • (9305) /

    Où se situe CASTLE PROPERTIES (SCARBOROUGH) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    90 St. Vincent Street
    G2 5UB Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CASTLE PROPERTIES (SCARBOROUGH) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PANALT LIMITED14 nov. 198914 nov. 1989

    Quels sont les derniers comptes de CASTLE PROPERTIES (SCARBOROUGH) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour CASTLE PROPERTIES (SCARBOROUGH) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 25 nov. 2010

    LRESSP

    Changement d'adresse du siège social de 93 George Street Edinburgh EH2 3ES le 06 déc. 2010

    2 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2010

    6 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 4a Melville Street Edinburgh EH3 7NS le 15 mars 2010

    2 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 janv. 2010

    État du capital au 08 janv. 2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Esplanade Director Limited le 20 déc. 2009

    2 pagesCH02

    Modification des coordonnées du secrétaire Esplanade Secretarial Services Limited le 20 déc. 2009

    2 pagesCH04

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2009

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ivan Anthony Goldberg le 01 oct. 2009

    3 pagesCH01

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    3 pages288a

    Comptes établis au 29 févr. 2008

    6 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 28 févr. 2007

    5 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 28 févr. 2006

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CASTLE PROPERTIES (SCARBOROUGH) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ESPLANADE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement6133270
    123430250001
    GOLDBERG, Ivan Anthony
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United KingdomBritish133676040001
    ESPLANADE DIRECTOR LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement6133267
    123430390001
    ASH, Christine Ann
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    Secrétaire
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    British67480001
    COOPER, Hilary Joan
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    Secrétaire
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    British51307940002
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Secrétaire
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    British1267050001
    FRASER, Leslie Murray Fraser
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    Secrétaire
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    British53477320001
    HARKIN, Mark James
    66 Cantieslaw Drive
    East Kilbride
    G74 3AQ Glasgow
    Secrétaire
    66 Cantieslaw Drive
    East Kilbride
    G74 3AQ Glasgow
    British42293490003
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    British56953000002
    MCCABE, Sandra
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    Secrétaire
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    British920260005
    TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    Secrétaire
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    90707230001
    W H STENTIFORD & CO
    70-74 Cannon Street
    EC4N 6AE London
    Secrétaire
    70-74 Cannon Street
    EC4N 6AE London
    4247350001
    ASH, Christine Ann
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    British67480001
    BARKLEY, John
    29 Castleton Drive
    Newton Mearns
    G77 5LE Glasgow
    Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    29 Castleton Drive
    Newton Mearns
    G77 5LE Glasgow
    Lanarkshire
    Scotland
    British18955940001
    BRADLEY, Pauline Anne
    6 Devonshire Terrace
    G12 0XF Glasgow
    Administrateur
    6 Devonshire Terrace
    G12 0XF Glasgow
    British34265760001
    BURNLEY, John Lewis
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    Administrateur
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    EnglandBritish35543830001
    COOPER, Hilary Joan
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    British51307940002
    COOPER, Hilary Joan
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    British51307940002
    FORD, Kenneth Charles
    43 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    Administrateur
    43 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    EnglandBritish52710005
    LOCKHART, David Alfred Stevenson
    5 Carlton Terrace
    EH7 5DD Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    5 Carlton Terrace
    EH7 5DD Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish35520610001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    TAYLOR, Peter
    Seymour House
    High Street
    GL55 6AG Chipping Campden
    Gloucestershire
    Administrateur
    Seymour House
    High Street
    GL55 6AG Chipping Campden
    Gloucestershire
    EnglandBritish109810150001
    THOMS, Graham Storrie
    11 Eastwoodmains Road
    Giffnock
    G46 6QB Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    11 Eastwoodmains Road
    Giffnock
    G46 6QB Glasgow
    Lanarkshire
    British559690001
    TRAPP, John Fraser
    36 Bruton Street
    W1X 1DD London
    Administrateur
    36 Bruton Street
    W1X 1DD London
    British31235900001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001

    CASTLE PROPERTIES (SCARBOROUGH) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 20 sept. 1996
    Livré le 08 oct. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold property known as 103 portland street,manchester,greater manchester.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 oct. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 05 mars 1996
    Livré le 12 mars 1996
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.299 hectares at pitreavie business park,dunfermline.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 mars 1996Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 23 janv. 1996
    Livré le 31 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by the company and another
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 40-54 percy street, rotherham, regsitered under title number syk 331321 and the department store being 15-21 (odd) doncaster gate, rotherham, registered under title number syk 331322, fixed charges over all builgings, goodwill, plant, etc., and a floating charge on all plant, machinery, etc....... see ch microfiche for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 janv. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Floating charge
    Créé le 19 sept. 1995
    Livré le 02 oct. 1995
    En cours
    Montant garanti
    £375,000
    Brèves mentions
    1) legal charge over the department store being 15 to 21 (odd) doncaster gate, rotherham and the car park being 40-54 percy street, rotherham 2) floating charge over all unattached plant, machinery, chattels and goods relating to the legal charge.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Uniquegrid Limited
    Transactions
    • 02 oct. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 01 sept. 1995
    Livré le 19 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage on the carriage house, 86-88 grosvenor road and land to the east of st johns road, tunbridge wells, registered under title numbers K649270 and K666506, and other fixed charges and a floating charge....... See ch microfiche for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 sept. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Legal charge
    Créé le 23 déc. 1994
    Livré le 29 déc. 1994
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    84/85 buckingham gate, westminster, registered under title number ngl 468992.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 déc. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 20 mars 1992
    Livré le 27 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Car parking spaces 15,16 & 17 grindlay street court, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 mars 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 avr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 28 févr. 1992
    Livré le 04 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    4/6 & 6A bridge street,congletch. CH393882 & CH313883.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 mars 1992Enregistrement d'une charge
    • 11 avr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 21 janv. 1992
    Livré le 24 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 janv. 1992Enregistrement d'une charge
    • 09 oct. 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 18 avr. 1990
    Livré le 25 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Former buildings 1 castle terrace edinburgh 11/17 lothian road edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 14 avr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • 15 avr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 18 avr. 1990
    Livré le 24 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1 castle terrace edinburgh 11/17 lothian road edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Tarmac Construction LTD
    Transactions
    • 24 avr. 1990Enregistrement d'une charge

    CASTLE PROPERTIES (SCARBOROUGH) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    06 mai 2012Dissolved on
    25 nov. 2010Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0