ITEC PACKAGING (CHESTER-LE-STREET) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ITEC PACKAGING (CHESTER-LE-STREET) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | En administration |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC121847 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ITEC PACKAGING (CHESTER-LE-STREET) LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O FRP ADVISORY TRADING LIMITED Apex 3 95 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ITEC PACKAGING (CHESTER-LE-STREET) LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2022 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2023 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2021 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour ITEC PACKAGING (CHESTER-LE-STREET) LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 11 déc. 2023 |
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 25 déc. 2023 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 11 déc. 2022 |
| En retard | Oui |
Quels sont les derniers dépôts pour ITEC PACKAGING (CHESTER-LE-STREET) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapport d'avancement de l'administrateur | 38 pages | AM10(Scot) | ||||||||||
Avis de prolongation de la période d'administration | 4 pages | AM19(Scot) | ||||||||||
Rapport d'avancement de l'administrateur | 35 pages | AM10(Scot) | ||||||||||
Avis de prolongation de la période d'administration | 4 pages | AM19(Scot) | ||||||||||
Rapport d'avancement de l'administrateur | 34 pages | AM10(Scot) | ||||||||||
Rapport d'avancement de l'administrateur | 37 pages | AM10(Scot) | ||||||||||
Avis de prolongation de la période d'administration | 4 pages | AM19(Scot) | ||||||||||
Rapport d'avancement de l'administrateur | 47 pages | AM10(Scot) | ||||||||||
Approbation des propositions de l'administrateur | 4 pages | AM06(Scot) | ||||||||||
Avis de proposition de l'administrateur | 81 pages | AM03(Scot) | ||||||||||
Déclaration des affaires | 20 pages | AM02(Scot) | ||||||||||
Déclaration des affaires AM02SOASCOT | 20 pages | AM02(Scot) | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp 2 Semple Street Edinburgh EH3 8BL United Kingdom à Apex 3 95 Haymarket Terrace Edinburgh EH12 5HD le 19 avr. 2023 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un administrateur | 6 pages | AM01(Scot) | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Dean Forster en tant que directeur le 09 janv. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Andrew John Limmer en tant qu'administrateur le 11 janv. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 déc. 2022 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Desmond Walton le 17 nov. 2022 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen Naylor le 17 nov. 2022 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Neil David Gostelow le 17 nov. 2022 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Dean Forster le 17 nov. 2022 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Mr Nicholas Hill en tant qu'administrateur le 26 oct. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed paccor uk LIMITED\certificate issued on 24/10/22 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 34 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge SC1218470027 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ITEC PACKAGING (CHESTER-LE-STREET) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOSTELOW, Neil David | Administrateur | 33 Cavendish Square W1G 0PW London 14th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 299646120001 | |||||
| HILL, Nicholas | Administrateur | Oakham Business Park Mansfield NG18 5BU Nottinghamshire Hamilton Way United Kingdom | United Kingdom | British | 299451130001 | |||||
| LIMMER, Andrew John | Administrateur | 33 Cavendish Square W1G 0PW London 14th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 287897980001 | |||||
| NAYLOR, Stephen | Administrateur | 33 Cavendish Square W1G 0PW London 14th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 169001590002 | |||||
| WALTON, Michael Desmond | Administrateur | 33 Cavendish Square W1G 0PW London 14th Floor United Kingdom | England | British | 111259450005 | |||||
| WELDEN, Michael Anthony | Administrateur | 95 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh Apex 3 | Wales | British | 214153360001 | |||||
| ALLEN, Kenneth Dale | Secrétaire | 97 Eaton Terrace SW1W 8TW London | American | 42924090001 | ||||||
| BATEY, Kevin William | Secrétaire | 37a Cornmoor Road Whickham NE16 4PU Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 76066220002 | ||||||
| CECIL, Reed Hallum | Secrétaire | Hinton House Ablington Bibury GL7 5NY Cirencester Gloucestershire | Us | 35539800001 | ||||||
| JEFFERSON, Paul Roger | Secrétaire | Montlougue TN12 9BQ 81800 Grazac France | British | 6882060002 | ||||||
| KERR, George Leslie | Secrétaire | 70/6 Slateford Road EH11 1QX Edinburgh Midlothian Scotland | British | 35505550001 | ||||||
| LUCHERINI, Roberto | Secrétaire | 47 Hillsden Road NE25 9XF Whitley Bay Tyne & Wear | British | 11579490001 | ||||||
| ZERHUSEN, David Edward | Secrétaire | 18 Hampstead Way Hampstead Garden Suburb NW11 7LS London | American | 53681230001 | ||||||
| ALLEN, Kenneth Dale | Administrateur | 97 Eaton Terrace SW1W 8TW London | American | 42924090001 | ||||||
| BARTON, Graham | Administrateur | 13 Albyn Terrace AB10 1YP Aberdeen C/O Bond Dickinson Llp United Kingdom | England | British | 82660880001 | |||||
| BATEY, Kevin William | Administrateur | 37a Cornmoor Road Whickham NE16 4PU Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 76066220002 | |||||
| BOCKELER, Eberhard | Administrateur | Borchlingweg 42 D200 52 Hamburg Germany | German | 1316270001 | ||||||
| BRUSH, David Paul | Administrateur | 1043 Mcglinnin Ct Lake Forest Illinois Il60045-1553 United States | American | 66863300002 | ||||||
| CECIL, Reed Hallum | Administrateur | Hinton House Ablington Bibury GL7 5NY Cirencester Gloucestershire | Us | 35539800001 | ||||||
| EBERLE, Frank | Administrateur | Zuidepark 8 1433 Kudelstaart FOREIGN Netherlands | German | 108867720001 | ||||||
| FORSTER, Michael Dean | Administrateur | 33 Cavendish Square W1G 0PW London 14th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 157345930002 | |||||
| FORTUNE, Patrick John | Administrateur | 222 Old Mill Road Lake Forest FOREIGN Illinois Usa | British | 15066400001 | ||||||
| GREEN, Cyril Joseph | Administrateur | 15 Latchford Road Gayton CH60 3RN Wirral Merseyside | United Kingdom | British | 76066290001 | |||||
| GRISWOLD, Paul John | Administrateur | 11 Pembroke 60045 Lake Forest Illinois Usa | American | 42381080001 | ||||||
| HAYMON, Monte | Administrateur | 104 Marlborough Street Boston Ma 02116 FOREIGN Usa | American | 60132370002 | ||||||
| HIEKKARANTA, Timo | Administrateur | 2 Semple Street EH3 8BL Edinburgh C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp United Kingdom | Finland | Finnish | 292411780001 | |||||
| HOLLYHEAD, Andrew Richard | Administrateur | Level 6 124 - 125 Princes Street EH2 4AD Edinburgh C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp United Kingdom | Germany | British | 264840220001 | |||||
| HUSTON, Steven | Administrateur | 2209 West Erie Street 60612 Chicago Illinois Usa | Us | 115933990001 | ||||||
| JEFFERSON, Paul Roger | Administrateur | Montlougue TN12 9BQ 81800 Grazac France | British | 6882060002 | ||||||
| JOHNSON, Graham Leslie | Administrateur | 28 Devonshire Close W1N 1LG London | British | 61431400001 | ||||||
| JONES, Keith Ashley | Administrateur | Level 6 124 - 125 Princes Street EH2 4AD Edinburgh C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp United Kingdom | United Kingdom | British | 239237770002 | |||||
| LEWIS, Peter | Administrateur | Dalton Hall Dalton DL11 7GU Richmond North Yorkshire | British | 61513940003 | ||||||
| LEWIS, Peter | Administrateur | The Beeches West Layton DL11 7PS Richmond North Yorkshire | British | 61513940002 | ||||||
| LORENZ, Nicolas Werner | Administrateur | 13 Albyn Terrace AB10 1YP Aberdeen C/O Bond Dickinson Llp United Kingdom | Germany | German | 200947490001 | |||||
| MCVICKER, Lawrence Arthur | Administrateur | 865 Sunrise Road FOREIGN Green Oaks Illinois Usa | Us | 5555900001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ITEC PACKAGING (CHESTER-LE-STREET) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breal Capital (Pac) Limited | 22 sept. 2022 | 33 Cavendish Square W1G 0PW London 14th Floor England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Paccor International Holdings S.A.R.L | 13 nov. 2020 | Boulevard Friedrich Wilhelm Raiffeisen L-2411 Luxemburg 15 Luxembourg | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Daisy Uk Holdco Limited | 06 avr. 2016 | Commercial Gate NG18 1EJ Mansfield 3-5 Nottinghamshire United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Marc Leder | 06 avr. 2016 | Town Center Circle Suite 600 FL 33486 Boca Raton 5200 Florida United States | Oui | ||||||||||
Nationalité: American Pays de résidence: United States | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Rodger Krouse | 06 avr. 2016 | Town Centre Circle Suite 600 FL 33486 Boca Raton 5200 Florida United States | Oui | ||||||||||
Nationalité: American Pays de résidence: United States | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour ITEC PACKAGING (CHESTER-LE-STREET) LIMITED ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 20 sept. 2022 | 22 sept. 2022 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
ITEC PACKAGING (CHESTER-LE-STREET) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 22 sept. 2022 Livré le 07 oct. 2022 | En cours | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| A registered charge | Créé le 22 sept. 2022 Livré le 05 oct. 2022 | En cours | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| A registered charge | Créé le 22 sept. 2022 Livré le 30 sept. 2022 | En cours | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 28 oct. 2020 Livré le 04 nov. 2020 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 27 nov. 2018 Livré le 10 déc. 2018 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 27 nov. 2018 Livré le 10 déc. 2018 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 31 juil. 2018 Livré le 07 août 2018 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 31 juil. 2018 Livré le 02 août 2018 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 30 sept. 2016 Livré le 11 oct. 2016 | Totalement satisfaite | ||
Brève description (1) by way of legal mortgage each of (I) the leasehold property in county durham known as units 1, 2, 5, 6 and 7, tanfield lea south estate, alderman wood road, stanley, co. Durham, DH9 9XF with title number DU331210; (ii) the leasehold property in mid glamorgan known as unit 9, sir alfred owen way, pontgwindy industrial estate, caerphilly, wales, CF83 3HU with title number WA833842; (iii) the leasehold property in mid glamorgan known as factory no. 1, pontygwindy industrial estate, caerphilly, wales, CF3 3HU with title number WA785633; and (iv) the leasehold property in mid glamorgan known as factory no. 2, pontygwindy industrial estate, caephilly, wales, cfu 3HU with title number WA781654;. (2) by way of equitable mortgage all freehold and leasehold properties and other real property both present and future of the company, including all buildings and other structures from time to time erected thereon and all fixtures (trade or otherwise) from time to time thereon or therein, other than the properties specified in (1) above.. (3) by way of fixed charge, all the company’s patents (including applications, improvements, prolongations, extensions and rights to apply therefor), designs (whether registered or unregistered), copyrights, design rights, trademarks and service marks (whether registered or unregistered), utility models, trade and business names, know-how, formulae, inventions, confidential information, trade secrets and computer software programs and systems (including the benefit of any licenses, sub-licenses or consents relating to any part of the above) and all fees, royalties or other rights derived therefrom or incidental thereto in any part of the world. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| A registered charge | Créé le 29 sept. 2016 Livré le 11 oct. 2016 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| A registered charge | Créé le 29 sept. 2016 Livré le 11 oct. 2016 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| A registered charge | Créé le 18 août 2016 Livré le 23 août 2016 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Units 1, 2, 5, 6 and 7, tanfield lea south estate, alderman wood road, stanley, co. Durham. (Please refer to schedule 2 of the security document). La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| A registered charge | Créé le 14 janv. 2014 Livré le 21 janv. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description 5-8 young square brucefield industrial park livingston MID142651. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 14 janv. 2014 Livré le 21 janv. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description 4 young square brucefield industrial park livingston MID142648. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 14 janv. 2014 Livré le 21 janv. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description 3 young square brucefield industrial park livingston MID137815. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 08 nov. 2013 Livré le 20 nov. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description All freehold, heritable and leasehold property from time to time owned by the chargor. See form for further details. Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| A registered charge | Créé le 08 nov. 2013 Livré le 18 nov. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description See form. Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| A registered charge | Créé le 07 nov. 2013 Livré le 20 nov. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| A registered charge | Créé le 07 nov. 2013 Livré le 18 nov. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| A registered charge | Créé le 07 nov. 2013 Livré le 18 nov. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| A registered charge | Créé le 15 mai 2013 Livré le 21 mai 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description 5-8 young square brucefield industrial park livingston MID142651. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 15 mai 2013 Livré le 21 mai 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description 4 young square brucefield industrial park livingston MID142648. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 15 mai 2013 Livré le 21 mai 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description 3 young square brucefield industrial park livingston MID137185. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 03 mai 2013 Livré le 15 mai 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Units 1,2,5,6 and 7 tanfield lea south estate alderman wood road stanley co durham DU331210. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 04 sept. 2012 Livré le 25 sept. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions (1) unit 9 sir alfred owen way pontygwindy industrial estate caerphilly wales WA833842: (2) factory no 1 pontygwindy industrial estate caerphilly wales WA785633 and (3) factory no 2 pontygwindy industrial estate caerphilly wales WA781654. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
ITEC PACKAGING (CHESTER-LE-STREET) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In administration |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0