DUNEDIN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

DUNEDIN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDUNEDIN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC123669
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DUNEDIN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe DUNEDIN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2nd Floor,
    43 Melville Street
    EH3 7JF Edinburgh
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DUNEDIN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LAS LEASING LIMITED25 avr. 199025 avr. 1990
    GOALTEAM LIMITED12 mars 199012 mars 1990

    Quels sont les derniers comptes de DUNEDIN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour DUNEDIN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01
    S2NC2MP6

    Changement d'adresse du siège social de 1a Glenfinlas Street Edinburgh EH3 6AQ le 12 juil. 2010

    1 pagesAD01
    XUYLVLMC

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 mars 2010

    État du capital au 26 mars 2010

    • Capital: GBP 1,831,000
    SH01
    X8EBYIMW

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2008

    11 pagesAA
    SA3WNH38

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    16 pagesAA
    SK8IM9VS

    legacy

    1 pages287
    X2D468LF

    legacy

    4 pages363a
    XYGQO874

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    15 pagesAA
    SYYGFZO6

    legacy

    4 pages363a
    XXVKMZB5

    legacy

    1 pages288c
    XXVKPZB8

    legacy

    2 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    12 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2004

    12 pagesAA

    legacy

    3 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2003

    13 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2002

    13 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    8 pages363s

    Qui sont les dirigeants de DUNEDIN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FULLERTON, Albert Smyth
    1 South Lauder Road
    EH9 2LL Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    1 South Lauder Road
    EH9 2LL Edinburgh
    Midlothian
    BritishAccountant76362700002
    BARRY, Roun Brendan
    Saracens
    Saunders Lane
    GU22 0NU Woking
    Surrey
    Administrateur
    Saracens
    Saunders Lane
    GU22 0NU Woking
    Surrey
    EnglandIrishSurveyor26177120002
    FULLERTON, Albert Smyth
    1 South Lauder Road
    EH9 2LL Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    1 South Lauder Road
    EH9 2LL Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishAccountant76362700002
    GIBSON, Scott
    Woodhall Road
    Colinton
    EH13 0DT Edinburgh
    15
    Scotland
    Administrateur
    Woodhall Road
    Colinton
    EH13 0DT Edinburgh
    15
    Scotland
    United KingdomBritishSurveyor140893250001
    BARRY, Roun Brendan
    Saracens
    Saunders Lane
    GU22 0NU Woking
    Surrey
    Secrétaire
    Saracens
    Saunders Lane
    GU22 0NU Woking
    Surrey
    IrishSurveyor26177120002
    BARRY, Roun Brendan
    31 Horsell Park Close
    GU21 4LZ Woking
    Surrey
    Secrétaire
    31 Horsell Park Close
    GU21 4LZ Woking
    Surrey
    British26177120001
    CAMPBELL, Hew
    44 Castleknowe Gardens
    Kirkton Park
    ML8 5UX Carluke
    Scotland
    Secrétaire
    44 Castleknowe Gardens
    Kirkton Park
    ML8 5UX Carluke
    Scotland
    BritishDeputy Secretary1416100007
    MILLS, Alan Ewing
    Sheriffs Park
    EH49 7SR Linlithgow
    87
    West Lothian
    Secrétaire
    Sheriffs Park
    EH49 7SR Linlithgow
    87
    West Lothian
    British1268780001
    PATIENCE, Andrew Stephen
    8 Kinnear Road
    EH3 5PE Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    8 Kinnear Road
    EH3 5PE Edinburgh
    Midlothian
    British1386620001
    SHEPHERD, Neil Morton
    35 Kaimes Road
    EH12 6JT Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    35 Kaimes Road
    EH12 6JT Edinburgh
    Midlothian
    British1063630001
    WARD, Anne
    1a South Hamilton Road
    EH39 4NJ North Berwick
    East Lothian
    Secrétaire
    1a South Hamilton Road
    EH39 4NJ North Berwick
    East Lothian
    British47639170001
    BAARA-GOETTSCH, Johanna Baukje
    Mathenesselaan 3
    2343 HA Oegstgeest
    Netherlands
    Administrateur
    Mathenesselaan 3
    2343 HA Oegstgeest
    Netherlands
    DutchManaging Director36159850002
    BADON GHIJBEN, Willem
    Jacob Mulderweg 18
    2597 Bs Den Haag
    The Netherlands
    Administrateur
    Jacob Mulderweg 18
    2597 Bs Den Haag
    The Netherlands
    DutchGeneral Manager42720850001
    BARRY, Roun Brendan
    31 Horsell Park Close
    GU21 4LZ Woking
    Surrey
    Administrateur
    31 Horsell Park Close
    GU21 4LZ Woking
    Surrey
    BritishGeneral Manager26177120001
    BEATTIE, Robert Henry
    10 Swanston Green
    EH10 7EW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    10 Swanston Green
    EH10 7EW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishBank Official27224590001
    BUCHANAN, Richard Robertson Trail
    Lynwood
    6 Essex Road
    EH4 6LG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Lynwood
    6 Essex Road
    EH4 6LG Edinburgh
    Midlothian
    BritishChief Exec32224420001
    BURNET, George Wardlaw
    Rose Court Inveresk Village
    EH21 7TD Musselburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Rose Court Inveresk Village
    EH21 7TD Musselburgh
    Midlothian
    BritishWriter To The Signet46268800001
    CAMPBELL, Hew
    44 Castleknowe Gardens
    Kirkton Park
    ML8 5UX Carluke
    Scotland
    Administrateur
    44 Castleknowe Gardens
    Kirkton Park
    ML8 5UX Carluke
    Scotland
    BritishDeputy Secretary1416100007
    CARTLEDGE, David Edmund
    Raines Lodge
    Greenway
    CM13 2NR Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Raines Lodge
    Greenway
    CM13 2NR Brentwood
    Essex
    BritishBank Official38897330001
    DE BOCK, David Jacques Andre
    Beysterveld 107
    1083 KB Amsterdam
    Administrateur
    Beysterveld 107
    1083 KB Amsterdam
    BritishManaging Director38537570001
    FORREST, Michael Alexander
    23 Barnton Avenue
    EH4 6AJ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    23 Barnton Avenue
    EH4 6AJ Edinburgh
    Midlothian
    Great BritainBritishInsurace Coy Manager53460001
    LOMAS, Ian Paul
    Caledon Road
    HP9 2BX Beaconsfield
    21
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Caledon Road
    HP9 2BX Beaconsfield
    21
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishSurveyor94970360001
    MERCER, Alexander Wallace
    Flat 3, Carlekemp Priory
    Abbotsford Road
    EH39 5DA North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    Flat 3, Carlekemp Priory
    Abbotsford Road
    EH39 5DA North Berwick
    East Lothian
    BritishCompany Director64889260001
    PAUL, Orr Macqueen
    9 Braid Farm Road
    EH10 6LG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    9 Braid Farm Road
    EH10 6LG Edinburgh
    Midlothian
    BritishInsurance Company Manager1063980001
    SACH, Derek Stephen
    Warren Lodge
    32 Leigh Hill Road
    KT11 2HZ Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Warren Lodge
    32 Leigh Hill Road
    KT11 2HZ Cobham
    Surrey
    BritishBanker646390001
    SHEAVILLS, Ernest Michael
    Coombe House, 8 Westgarth Avenue
    Colinton
    EH13 0BD Edinburgh
    Administrateur
    Coombe House, 8 Westgarth Avenue
    Colinton
    EH13 0BD Edinburgh
    BritishBank Official34817880001
    SHEPHERD, Neil Morton
    35 Kaimes Road
    EH12 6JT Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    35 Kaimes Road
    EH12 6JT Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishChartered Accountant1063630001
    VAN DEN BERG, Herman Christiaan
    Eizenlaan 53
    3871 BL Hoevelaken
    The Netherlands
    Administrateur
    Eizenlaan 53
    3871 BL Hoevelaken
    The Netherlands
    DutchManaging Director50095730001
    WHITEHEAD, Grahame Taylor
    Dunira 19 Whim Road
    EH31 2BD Gullane
    East Lothian
    Administrateur
    Dunira 19 Whim Road
    EH31 2BD Gullane
    East Lothian
    BritishBank Official1363570002
    WINCHESTER, Colin
    Fairfield 26 Gamekeepers Road
    EH4 6LU Edinburgh
    Administrateur
    Fairfield 26 Gamekeepers Road
    EH4 6LU Edinburgh
    BritishChartered Accountant53067480001

    DUNEDIN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 05 juin 1996
    Livré le 19 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Quality street,davidsons mains,edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 juin 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 05 juin 1996
    Livré le 13 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    5 finnieston quay,glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 juin 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 05 juin 1996
    Livré le 13 juin 1996
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    58-70 dobbies loan,glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 juin 1996Enregistrement d'une charge (410)
    Bond & floating charge
    Créé le 31 mai 1996
    Livré le 04 juin 1996
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 juin 1996Enregistrement d'une charge (410)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0