FIFE NURSING SERVICES LIMITED

FIFE NURSING SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFIFE NURSING SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC125362
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FIFE NURSING SERVICES LIMITED ?

    • Autres activités liées à la santé humaine (86900) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe FIFE NURSING SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    First Floor, Suite 2, Clydesedale House 300 Springhill Parkway
    Glasgow Business Park
    G69 6GA Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FIFE NURSING SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FOUR SEASONS HEALTH CARE (SERVICES) LIMITED31 mai 199031 mai 1990

    Quels sont les derniers comptes de FIFE NURSING SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour FIFE NURSING SERVICES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour FIFE NURSING SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    État du capital après une attribution d'actions au 07 oct. 2015

    • Capital: GBP 188,790.94
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    11 pagesAA

    État du capital au 07 oct. 2015

    • Capital: GBP 67.94
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juin 2015

    État du capital au 15 juin 2015

    • Capital: GBP 6,794
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ian Richard Smith le 19 févr. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Benjamin Robert Taberner le 18 févr. 2015

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Dominic Jude Kay en tant que directeur le 28 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    11 pagesAA

    Cessation de la nomination de Dominic Kay en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs Abigail Mattison en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 juin 2014

    État du capital au 03 juin 2014

    • Capital: GBP 6,794
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Maureen Claire Royston le 22 mai 2014

    2 pagesCH01

    Nomination de Maureen Claire Royston en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Peter Calveley en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Ian Richard Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    12 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de FIFE NURSING SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MATTISON, Abigail
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    188567810001
    ROYSTON, Maureen Claire, Dr
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    Administrateur
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    United KingdomBritish184190020002
    SMITH, Ian Richard
    300 Springhill Parkway
    Glasgow Business Park
    G69 6GA Glasgow
    First Floor, Suite 2, Clydesedale House
    Administrateur
    300 Springhill Parkway
    Glasgow Business Park
    G69 6GA Glasgow
    First Floor, Suite 2, Clydesedale House
    United KingdomBritish181082310001
    TABERNER, Benjamin Robert
    300 Springhill Parkway
    Glasgow Business Park
    G69 6GA Glasgow
    First Floor, Suite 2, Clydesedale House
    Administrateur
    300 Springhill Parkway
    Glasgow Business Park
    G69 6GA Glasgow
    First Floor, Suite 2, Clydesedale House
    United KingdomBritish150511890001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    British38256680007
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Secrétaire
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    British145920530001
    GIBSON & SPEARS DOW & SON
    9 East Fergus Place
    KY1 1XU Kirkcaldy
    Fife
    Secrétaire
    9 East Fergus Place
    KY1 1XU Kirkcaldy
    Fife
    185470001
    ANSTEAD, Hamilton Douglas
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    British107751890001
    CALVELEY, Peter, Dr
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    Administrateur
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    United KingdomBritish131468590001
    COBBAN, Raonaid Mary
    122 Gilmore Place
    EH3 9PL Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    122 Gilmore Place
    EH3 9PL Edinburgh
    Midlothian
    British782230001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    British38256680007
    DOCHERTY, Claire
    23 Balwearie Road
    KY2 5LT Kirkcaldy
    Fife
    Scotland
    Administrateur
    23 Balwearie Road
    KY2 5LT Kirkcaldy
    Fife
    Scotland
    British39515980004
    DOCHERTY, Claire
    10 Strathkinnes Road
    KY2 5PU Kirkcaldy
    Fife
    Administrateur
    10 Strathkinnes Road
    KY2 5PU Kirkcaldy
    Fife
    British39515980003
    FINDLAY, Lorna Ann
    7 Bennochy Avenue
    KY2 5QE Kirkcaldy
    Fife
    Administrateur
    7 Bennochy Avenue
    KY2 5QE Kirkcaldy
    Fife
    British19728250002
    GORDON, Margaret Anne
    75 St Stephen Street
    EH3 5AG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    75 St Stephen Street
    EH3 5AG Edinburgh
    Midlothian
    British1245560001
    HEYWOOD, Anthony George
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    Administrateur
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    EnglandBritish131288260001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Administrateur
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish145920530001
    KILGOUR, Robert Dow
    26 Beveridge Road
    KY1 1UY Kirkcaldy
    Fife
    Administrateur
    26 Beveridge Road
    KY1 1UY Kirkcaldy
    Fife
    British494960001
    MITCHELL, Nicholas John
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Great BritainBritish145102120001
    TODD, Grant Alexander
    9 Albert Road
    FK1 5LS Falkirk
    Administrateur
    9 Albert Road
    FK1 5LS Falkirk
    British54109500001

    FIFE NURSING SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security deed
    Créé le 08 déc. 2009
    Livré le 22 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse
    Transactions
    • 22 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 25 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Floating charge
    Créé le 19 oct. 2006
    Livré le 07 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse
    Transactions
    • 07 nov. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Floating charge
    Créé le 09 janv. 2006
    Livré le 26 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage all the freehold and leasehold property (if any) other than any excluded leases and any excluded properties. Including fixed and floating charges. See form 410 paper apart for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 janv. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 09 janv. 2006
    Livré le 26 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 janv. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 01 sept. 1994
    Livré le 13 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 sept. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 12 août 1993
    Livré le 26 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 août 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0