NEW EDINBURGH LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNEW EDINBURGH LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC126384
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NEW EDINBURGH LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe NEW EDINBURGH LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Lomond House
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NEW EDINBURGH LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PACIFIC SHELF 356 LIMITED19 juil. 199019 juil. 1990

    Quels sont les derniers comptes de NEW EDINBURGH LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour NEW EDINBURGH LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour NEW EDINBURGH LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de passage de l'administration à la dissolution

    20 pages2.26B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    20 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    18 pages2.20B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    1 pages2.22B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    20 pages2.20B(Scot)

    Avis d'insuffisance d'actifs pour la distribution aux créanciers non garantis autres qu'en vertu de l'article S176A(2)(A)

    1 pages2.32B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    19 pages2.20B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    2 pages2.22B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    20 pages2.20B(Scot)

    Proposition réputée de l'administrateur

    1 pages2.16BZ(Scot)

    Proposition de l'administrateur

    41 pages2.16B(Scot)

    État des affaires avec formulaire 2.13B(SCOT)/2.14B(SCOT)

    19 pages2.15B(Scot)

    Nomination d'un administrateur

    3 pages2.11B(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de Miller House 2 Lochside View Edinburgh Park Edinburgh EH12 9DH le 17 juil. 2012

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Pamela June Smyth en tant que secrétaire le 16 mai 2012

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Keith Manson Miller en tant que directeur le 23 avr. 2012

    2 pagesTM01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Modification des coordonnées de l'administrateur Pamela Grant le 28 sept. 2011

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 sept. 2011

    État du capital au 09 sept. 2011

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Nomination de Euan James Edward Haggerty en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Modification des coordonnées du secrétaire Pamela June Smyth le 11 févr. 2011

    1 pagesCH03

    Cessation de la nomination de Donald Borland en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de NEW EDINBURGH LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ADAIR, Eric Weir
    Grierson Square
    EH5 2AR Edinburgh
    8
    Administrateur
    Grierson Square
    EH5 2AR Edinburgh
    8
    ScotlandBritishFinance Director116185430001
    GRANT, Pamela
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    Administrateur
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    ScotlandBritishCompany Director114541590001
    HAGGERTY, Euan James Edward
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    Administrateur
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    United KingdomBritishNone162679260001
    MILLER, Philip Hartley
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    Administrateur
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    ScotlandBritishChartered Surveyor28512070005
    SUTHERLAND, Andrew
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    Administrateur
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    United KingdomBritishDirector Of Property Develop66368290001
    WATTON, Peter Graham
    242 Guardwell Crescent
    EH17 7SJ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    242 Guardwell Crescent
    EH17 7SJ Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishChartered Sureyor109295850001
    BLYTH, William
    Carradale 516 Lanark Road West
    EH14 7DH Balerno
    Midlothian
    Secrétaire
    Carradale 516 Lanark Road West
    EH14 7DH Balerno
    Midlothian
    British514950001
    DAVIDSON, Karen
    24 Castle Street
    EH2 3HT Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    24 Castle Street
    EH2 3HT Edinburgh
    Midlothian
    British738750001
    MCGOWAN, Carol Ann
    374 Leith Walk
    EH7 4PE Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    374 Leith Walk
    EH7 4PE Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor112664200001
    SMYTH, Pamela June
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Secrétaire
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    BritishCompany Secretary65057960002
    WILSON, Mary
    3 Belgrave Road
    EH12 6NG Edinburgh
    Secrétaire
    3 Belgrave Road
    EH12 6NG Edinburgh
    British42188180001
    ANDERSON, Donald Craig
    39 The Spinney
    EH17 7LE Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    39 The Spinney
    EH17 7LE Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishElected Member/Mlso48629740001
    BORLAND, Donald William
    408 Ferry Road
    EH5 2AD Edinburgh
    Administrateur
    408 Ferry Road
    EH5 2AD Edinburgh
    United KingdomBritishAccountant66010670002
    CAMERON, Lezley Marion
    7/6 Roseburn Maltings
    EH12 5LY Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    7/6 Roseburn Maltings
    EH12 5LY Edinburgh
    Midlothian
    BritishSelf Employed77460160002
    COCKBURN, Andrew Scott
    24 Castle Street
    EH2 3HT Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    24 Castle Street
    EH2 3HT Edinburgh
    Midlothian
    British36549700001
    DEANS, Thomas Malcolm
    69 Hillview Road
    EH12 8QH Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    69 Hillview Road
    EH12 8QH Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishSurveyor848410001
    DI CIACCA, John Mark
    Jaytu
    Main Road
    KY11 1HA North Queensferry
    Fife
    Administrateur
    Jaytu
    Main Road
    KY11 1HA North Queensferry
    Fife
    United KingdomBritishProperty Director77111830002
    HUNTER, Colin Ian
    Stonelaws Farm
    EH40 3DX East Linton
    East Lothian
    Administrateur
    Stonelaws Farm
    EH40 3DX East Linton
    East Lothian
    ScotlandBritishDirector37329910003
    JACKSON, Julie Mansfield
    31 Inverleith Gardens
    EH3 5PR Edinburgh
    Administrateur
    31 Inverleith Gardens
    EH3 5PR Edinburgh
    United KingdomBritishSolicitor94193070001
    KENNEDY, Sheila
    30 House O'Hill Road
    EH4 2AN Edinburgh
    Administrateur
    30 House O'Hill Road
    EH4 2AN Edinburgh
    BritishTeacher35269940001
    KEREVAN, George
    Brunstane House South Wing
    Brunstane Road South
    EH15 2NQ Edinburgh
    Administrateur
    Brunstane House South Wing
    Brunstane Road South
    EH15 2NQ Edinburgh
    ScotlandBritish660740002
    MACKENZIE, Gordon Ferguson
    53 Kirkhill Road
    EH16 5DE Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    53 Kirkhill Road
    EH16 5DE Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishLocal Government Officer122810520001
    MILLER, Keith Manson
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    Administrateur
    Miller House
    2 Lochside View
    EH12 9DH Edinburgh Park
    Edinburgh
    ScotlandBritishCompany Director546650002
    MILLOY, David Thomas
    1 Thorn Avenue
    Thorntonhall
    G74 5AT Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    1 Thorn Avenue
    Thorntonhall
    G74 5AT Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritishDirector76474600001
    PASKE, John
    Malgre Tout
    Plaistow Road
    Ilford
    West Sussex
    Administrateur
    Malgre Tout
    Plaistow Road
    Ilford
    West Sussex
    BritishDirector11819760001
    PERRY, Ian
    Lilyhill Terrace
    EH8 7DR Edinburgh
    49
    Administrateur
    Lilyhill Terrace
    EH8 7DR Edinburgh
    49
    ScotlandBritishCouncillor127893650001
    ROBINSON, David
    118 Meadowspot
    EH10 5UY Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    118 Meadowspot
    EH10 5UY Edinburgh
    Lothian
    ScotlandUnited KingdomChartered Surveyor50541770001
    ROSS, William
    3 Mayburn Avenue
    EH20 9HA Loanhead
    Midlothian
    Administrateur
    3 Mayburn Avenue
    EH20 9HA Loanhead
    Midlothian
    British763580003
    SUTHERLAND, Andrew
    87 Whitehouse Road
    EH4 6PB Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    87 Whitehouse Road
    EH4 6PB Edinburgh
    Lothian
    United KingdomBritishProperty Company Director66368290001
    SUTHERLAND, Duncan
    Whitefold Farmhouse
    Four Acre Lane
    PR3 2TD Thornley
    Lancashire
    Administrateur
    Whitefold Farmhouse
    Four Acre Lane
    PR3 2TD Thornley
    Lancashire
    EnglandBritishPlanning/Property Development78226760001
    WALL, Ian James, Prof
    85 Warrender Park Road
    EH9 1EW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    85 Warrender Park Road
    EH9 1EW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishDirector430300001
    WOOD, Marlene
    15 Ormidale Terrace
    EH12 6DY Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    15 Ormidale Terrace
    EH12 6DY Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishChartered Accountant31152030002
    YOUNG, Donald Stewart Farquhar
    11 Craiglockhart Terrace
    EH14 1AJ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    11 Craiglockhart Terrace
    EH14 1AJ Edinburgh
    Midlothian
    BritishDirector1319870001

    NEW EDINBURGH LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 07 sept. 2006
    Livré le 21 sept. 2006
    En cours
    Montant garanti
    Obligations ad factum praestandum
    Brèves mentions
    Area of ground extending to one hectare and fifty eight decimal or one-thousandth parts of an hectare (1.058) or thereby at hermiston gait, south gyle, edinburgh in the county of midlothian.
    Personnes ayant droit
    • Ebh Limited
    Transactions
    • 21 sept. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Assignation
    Créé le 27 août 1992
    Livré le 01 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    £54,000 and all other sums due or to become due by pentland estates limited and the benefit of scottish equitable's guarantee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 sept. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 25 août 1992
    Livré le 08 sept. 1992
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground lying to the south of the gogar roundabout and the edinburgh to glasgow road (A8) being the westmost of those three areas of ground extending in total to 34 acres and one decimal as relative to the disposition by robert allison in favour of wimpey homes holdings limited recorded in grs on 05/07/85.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 sept. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 21 août 1992
    Livré le 28 août 1992
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 août 1992Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 03 avr. 1992
    Livré le 14 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,000,000
    Brèves mentions
    Area of ground extending to 20.125 acreas lying to the south of south gyle broadway, south gyle, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Pentland Estates Limited
    Transactions
    • 14 avr. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    NEW EDINBURGH LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 juil. 2012Administration started
    25 nov. 2014Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John Charles Reid
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    practitioner
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2DB Edinburgh
    Neville Barry Khan
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Matthew James Cowlishaw
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    practitioner
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0