MACDONALD REID SCOTT HOLDINGS LIMITED

MACDONALD REID SCOTT HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMACDONALD REID SCOTT HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC127073
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MACDONALD REID SCOTT HOLDINGS LIMITED ?

    • (6603) /

    Où se situe MACDONALD REID SCOTT HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    150 St. Vincent Street
    G2 5ND Glasgow
    Scotland
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MACDONALD REID SCOTT HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MACDONALD REID SCOTT INSURANCE BROKERS LIMITED26 août 199626 août 1996
    MACDONALD REID LIMITED02 nov. 199002 nov. 1990
    COMLAW NO. 228 LIMITED06 sept. 199006 sept. 1990

    Quels sont les derniers comptes de MACDONALD REID SCOTT HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour MACDONALD REID SCOTT HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Nomination de Mr Andrew Stewart Hunter en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Darryl Clark en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 août 2010

    État du capital au 18 août 2010

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Graham Hoy Reid le 31 juil. 2010

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Iain George Douglas Scott le 31 juil. 2010

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy Duncan Philip le 31 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Charles Homer le 31 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Peter Geoffrey Cullum le 31 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Ian William James Patrick le 31 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de 23 Eagle Street Glasgow G4 9XA le 17 août 2010

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    5 pagesAA

    Nomination de Mr Darryl Clark en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Timothy Craton en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    7 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages225

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 avr. 2008

    6 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    1 pages225

    Qui sont les dirigeants de MACDONALD REID SCOTT HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HUNTER, Andrew Stewart
    St. Vincent Street
    G2 5ND Glasgow
    150
    Scotland
    Scotland
    Secrétaire
    St. Vincent Street
    G2 5ND Glasgow
    150
    Scotland
    Scotland
    156622600001
    CULLUM, Peter Geoffrey
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector59873490009
    HOMER, Andrew Charles
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector13483140003
    PATRICK, Ian William James
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector75028400004
    PHILIP, Timothy Duncan
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector99066410001
    REID, Graham Hoy
    St. Vincent Street
    G2 5ND Glasgow
    150
    Scotland
    United Kingdom
    Administrateur
    St. Vincent Street
    G2 5ND Glasgow
    150
    Scotland
    United Kingdom
    ScotlandScottishDirector1316200004
    SCOTT, Iain George Douglas
    St. Vincent Street
    G2 5ND Glasgow
    150
    Scotland
    United Kingdom
    Administrateur
    St. Vincent Street
    G2 5ND Glasgow
    150
    Scotland
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector35699870003
    BRUCE, Graeme Murray
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    Secrétaire désigné
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    British900002440001
    CLARK, Darryl
    St. Vincent Street
    G2 5ND Glasgow
    150
    Scotland
    Scotland
    Secrétaire
    St. Vincent Street
    G2 5ND Glasgow
    150
    Scotland
    Scotland
    153023450001
    CRATON, Timothy Charles
    Downings
    Quarry Close
    RH8 9HG Oxted
    Surrey
    Secrétaire
    Downings
    Quarry Close
    RH8 9HG Oxted
    Surrey
    BritishCompany Secretary76055420004
    MACDONALD, Ronald John
    Garden House
    Balfron
    G63 0LL Glasgow
    Strathclyde
    Secrétaire
    Garden House
    Balfron
    G63 0LL Glasgow
    Strathclyde
    British27186300001
    REDDI, John
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    Secrétaire
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    BritishCompany Secretary6180280001
    REID, Robert J
    39 Roselea Drive
    Milngavie
    G62 8HE Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    39 Roselea Drive
    Milngavie
    G62 8HE Glasgow
    Lanarkshire
    British873000001
    BRUCE, Graeme Murray
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    Administrateur désigné
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    British900002440001
    GALBRAITH, Eric Roger
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    Administrateur désigné
    Madeleine Smith House
    6/7 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    British900002450001
    MACDONALD, Ronald John
    Garden House
    Balfron
    G63 0LL Glasgow
    Strathclyde
    Administrateur
    Garden House
    Balfron
    G63 0LL Glasgow
    Strathclyde
    ScotlandBritishDirector27186300001
    REID, Julia
    39 Roselea Drive
    Milngavie
    G62 8HE Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    39 Roselea Drive
    Milngavie
    G62 8HE Glasgow
    Lanarkshire
    BritishDirector57404460001
    REID, Robert J
    39 Roselea Drive
    Milngavie
    G62 8HE Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    39 Roselea Drive
    Milngavie
    G62 8HE Glasgow
    Lanarkshire
    BritishDirector873000001

    MACDONALD REID SCOTT HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 02 sept. 1998
    Livré le 11 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Trustees of Airdrie Savings Bank
    Transactions
    • 11 sept. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 23 oct. 1996
    Livré le 01 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 nov. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0