PINNACLE CELLULAR LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPINNACLE CELLULAR LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC127133
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PINNACLE CELLULAR LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe PINNACLE CELLULAR LIMITED ?

    Adresse du siège social
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de PINNACLE CELLULAR LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2023

    Quels sont les derniers dépôts pour PINNACLE CELLULAR LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2023

    5 pagesAA

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Modification des détails de Pinnacle Cellular Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 juil. 2023

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de Edinburgh House 4 North St. Andrew Street Edinburgh EH2 1HJ United Kingdom à 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ le 04 juil. 2023

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Janine Butler en tant que directeur le 23 nov. 2022

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021

    5 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de David Nigel Evans en tant que directeur le 23 févr. 2021

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Janine Butler en tant qu'administrateur le 23 févr. 2021

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 14 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2019

    4 pagesAA

    legacy

    256 pagesPARENT_ACC

    legacy

    2 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Changement d'adresse du siège social de Leven House 10 Lochside Place Edinburgh Park Edinburgh Scotland EH12 9RG à Edinburgh House 4 North St. Andrew Street Edinburgh EH2 1HJ le 14 mai 2019

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Andrew Michael Yorston en tant qu'administrateur le 02 avr. 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Michael Anthony Henry Olivier en tant qu'administrateur le 02 avr. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Diane Josephine Mcintyre en tant que directeur le 16 mars 2019

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de PINNACLE CELLULAR LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement2357692
    75473330004
    OLIVIER, Michael Anthony Henry
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    Administrateur
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    United KingdomBritish257268230001
    YORSTON, Andrew Michael
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    Administrateur
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    United KingdomBritish257275320001
    COULL, Gillian Margaret
    62 Alloway Crescent
    FK4 1EZ Bonnybridge
    Stirlingshire
    Secrétaire
    62 Alloway Crescent
    FK4 1EZ Bonnybridge
    Stirlingshire
    British30641050001
    COULL, Graham
    3 Coney Park
    Kings Park
    FK7 9LU Stirling
    Stirlingshire
    Secrétaire
    3 Coney Park
    Kings Park
    FK7 9LU Stirling
    Stirlingshire
    British76740000001
    DAWE-LANE, Patrick John Beachim
    Marsh Lane
    Rowde
    SN10 1RE Devizes
    Upper Foxhangers Farm
    Wiltshire
    England
    Secrétaire
    Marsh Lane
    Rowde
    SN10 1RE Devizes
    Upper Foxhangers Farm
    Wiltshire
    England
    Other130771170001
    EMETULU, Lola
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British88619360002
    JEFFERSON, Karen
    8 Bailey Close
    SN9 5HU Pewsey
    Wiltshire
    Secrétaire
    8 Bailey Close
    SN9 5HU Pewsey
    Wiltshire
    British79393480001
    MACLEOD, David
    12 Glebe Road
    Newton Mearns
    G77 6DU Glasgow
    Secrétaire
    12 Glebe Road
    Newton Mearns
    G77 6DU Glasgow
    British32696310001
    REID, Brian
    5 Logie Mill
    Beaverbank Office Park
    EH7 4HH Edinburgh
    Secrétaire désigné
    5 Logie Mill
    Beaverbank Office Park
    EH7 4HH Edinburgh
    British900007130001
    SCOTT, Stephen Roy
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    British25660590003
    WHEELER, David
    Carn Mairg
    Wallacestone Brae
    FK2 0DH Brightons
    Stirlingshire
    Secrétaire
    Carn Mairg
    Wallacestone Brae
    FK2 0DH Brightons
    Stirlingshire
    British102737470001
    ALLAN, William
    Shernfold Meadows
    Wadhurst Road
    TN3 9EH Frant
    East Sussex
    Administrateur
    Shernfold Meadows
    Wadhurst Road
    TN3 9EH Frant
    East Sussex
    UkBritish111131550001
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    7 Lochside Avenue
    Edinburgh Park
    EH12 9DJ Edinburgh
    Lochside House
    Scotland
    Scotland
    British123612980001
    BARR, Duncan David Whyte
    95 Wheatlands Avenue
    FK4 1PJ Bonnybridge
    Stirlingshire
    Administrateur
    95 Wheatlands Avenue
    FK4 1PJ Bonnybridge
    Stirlingshire
    British37411850001
    BREWER, Stephen
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    British79186090002
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Administrateur
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    British83126790001
    BUTLER, Janine
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    Administrateur
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    EnglandBritish277534960001
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British99525280001
    COULL, Graham
    3 Coney Park
    Kings Park
    FK7 9LU Stirling
    Stirlingshire
    Administrateur
    3 Coney Park
    Kings Park
    FK7 9LU Stirling
    Stirlingshire
    British76740000001
    EVANS, David Nigel
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    Administrateur
    4 North St. Andrew Street
    EH2 1HJ Edinburgh
    Edinburgh House
    United Kingdom
    United KingdomBritish134975040001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish158146620001
    GOW, John Warrender
    32 Cammo Gardens
    Barnton
    EH4 8EQ Edinburgh
    Administrateur
    32 Cammo Gardens
    Barnton
    EH4 8EQ Edinburgh
    British55207220001
    GRAY, Ian
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    Administrateur
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    United KingdomBritish50246030004
    HALFORD, Andrew Nigel
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    British33951180005
    HERROD, Harry Alan
    Dakar, 40 Camelon Road
    FK1 5SH Falkirk
    Administrateur
    Dakar, 40 Camelon Road
    FK1 5SH Falkirk
    British93998280001
    HILLS, Kenneth Cumming
    49 Spottiswoode Street
    EH9 1DQ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    49 Spottiswoode Street
    EH9 1DQ Edinburgh
    Midlothian
    British65152940001
    KEY, Matthew David
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British62981720001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Administrateur
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritish24471140001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    MATTHEWS, Roderick Alfred
    Aros House
    Rhu
    G84 8NJ Helensburgh
    Dunbartonshire
    Administrateur
    Aros House
    Rhu
    G84 8NJ Helensburgh
    Dunbartonshire
    British74872510003
    MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    10 Lochside Place
    Edinburgh Park
    EH12 9RG Edinburgh
    Leven House
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish173703620001
    MCNEILL, Ronald
    4/6 New Bells Court
    Maritime Street
    EH6 6RY Edinburgh
    Administrateur
    4/6 New Bells Court
    Maritime Street
    EH6 6RY Edinburgh
    British205550003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PINNACLE CELLULAR LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom (Scotland)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc123629
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    PINNACLE CELLULAR LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 27 févr. 1996
    Livré le 04 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 mars 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 oct. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 23 nov. 1995
    Livré le 29 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Shop premises, 27 union street, dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 nov. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 oct. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 23 nov. 1995
    Livré le 29 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Shop premises, 35 and 37A high street, ayr.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 nov. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 oct. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 14 avr. 1994
    Livré le 26 avr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Shop 12 leven street, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 avr. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 06 avr. 1991
    Livré le 19 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transactions
    • 19 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 11 avr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0