HAITONG & COMPANY (UK) LIMITED

HAITONG & COMPANY (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHAITONG & COMPANY (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC127487
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HAITONG & COMPANY (UK) LIMITED ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe HAITONG & COMPANY (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5 Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HAITONG & COMPANY (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EXECUTION NOBLE & COMPANY LIMITED08 févr. 201008 févr. 2010
    NOBLE & COMPANY LIMITED03 janv. 199103 janv. 1991
    NOBLE EQUITIES LIMITED24 sept. 199024 sept. 1990

    Quels sont les derniers comptes de HAITONG & COMPANY (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour HAITONG & COMPANY (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2015

    9 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Jennie Bell en tant que secrétaire le 16 mai 2016

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Luis Miguel Pina Luna Vaz en tant que directeur le 20 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    23 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 sept. 2015

    État du capital au 28 sept. 2015

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed execution noble & company LIMITED\certificate issued on 07/09/15
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name07 sept. 2015

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Cessation de la nomination de Tara Cemlyn-Jones en tant que directeur le 07 nov. 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 oct. 2014

    État du capital au 07 oct. 2014

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Dipesh Chimanbhai Patel en tant que directeur le 17 sept. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nicholas Jeremy Bruce Paulson-Ellis en tant que directeur le 07 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    24 pagesAA

    Nomination de Mr Pedro Costa en tant qu'administrateur le 17 juin 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Nicholas Jeremy Bruce Paulson-Ellis en tant qu'administrateur le 17 juin 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Tara Cemlyn-Jones en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 oct. 2013

    État du capital au 11 oct. 2013

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Nomination de Mr Nicholas Jeremy Bruce Paulson-Ellis en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    10 janv. 2014Under Section 1095 of the Companies Act 2006, details of the director’s notification of appointment have been removed as this was invalid or ineffective.

    Nomination de Mr John Victor Millar en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    10 janv. 2014Under Section 1095 of the Companies Act 2006, details of the director’s notification of appointment have been removed as this was invalid or ineffective.

    Nomination de Mr Pedro Alexandre Martins Costa en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    10 janv. 2014Under Section 1095 of the Companies Act 2006, details of the director’s notification of appointment have been removed as this was invalid or ineffective.

    Cessation de la nomination de Tara Cemlyn-Jones en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nicholas Finegold en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Charles Ashton en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de HAITONG & COMPANY (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COSTA, Pedro
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    5
    Scotland
    Administrateur
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    5
    Scotland
    EnglandPortuguese189698240001
    DE ARAUJO, Joao Paulo Pessoa
    Paternoster Square
    EC4M 7AL London
    10
    England
    Administrateur
    Paternoster Square
    EC4M 7AL London
    10
    England
    EnglandPortuguese159572800001
    BELL, Jennie
    Paternoster Square
    EC4M 7AL London
    10
    England
    Secrétaire
    Paternoster Square
    EC4M 7AL London
    10
    England
    180190100001
    GUTHRIE, Samantha
    Paternoster Square
    EC4M 7AL London
    10
    United Kingdom
    Secrétaire
    Paternoster Square
    EC4M 7AL London
    10
    United Kingdom
    172672510001
    HIBBITT, Ashli
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    5
    Scotland
    Secrétaire
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    5
    Scotland
    179642040001
    OWENS, Jennifer
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    5
    Scotland
    Secrétaire
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    5
    Scotland
    148669470001
    ROBERTSON, James
    Bruaich The Spinney
    EH17 7LD Edinburgh
    Secrétaire
    Bruaich The Spinney
    EH17 7LD Edinburgh
    British50502860001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secrétaire désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    NCM FINANCE LIMITED
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Secrétaire
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    86014010003
    NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Secrétaire
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    94907480001
    ASHTON, Charles James
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    5
    Scotland
    Administrateur
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    5
    Scotland
    United KingdomBritish139012420002
    BARKER, John
    12 Cheyne Gardens
    SW3 5QT London
    Administrateur
    12 Cheyne Gardens
    SW3 5QT London
    United KingdomBritish76737740002
    BAYLEY, Graeme Charles Roger
    Stocklands
    20a Woodside Road
    TN13 3HE Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Stocklands
    20a Woodside Road
    TN13 3HE Sevenoaks
    Kent
    British102323490001
    BROMHEAD, James Claude
    Hill End
    Monk Sherborne
    RG26 5HB Tadley
    Hampshire
    Administrateur
    Hill End
    Monk Sherborne
    RG26 5HB Tadley
    Hampshire
    EnglandBritish39786240002
    CAMPBELL, Mary Theresa
    13 Campbell Avenue
    Murrayfield
    EH12 6DP Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    13 Campbell Avenue
    Murrayfield
    EH12 6DP Edinburgh
    Midlothian
    British1322300001
    CEMLYN-JONES, Tara
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    5
    Scotland
    Administrateur
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    5
    Scotland
    WalesIrish186754820001
    CEMLYN-JONES, Tara
    Paternoster Square
    EC4M 7AL London
    10
    England
    Administrateur
    Paternoster Square
    EC4M 7AL London
    10
    England
    PortugalIrish159583540001
    CHAPLIN, Robert Henry Moffett
    23 Moray Place
    EH3 6DA Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    23 Moray Place
    EH3 6DA Edinburgh
    Lothian
    United KingdomBritish63131640001
    CHRISTIE, Rory
    56 South Trinity Road
    EH5 3NX Edinburgh
    Scotland
    Administrateur
    56 South Trinity Road
    EH5 3NX Edinburgh
    Scotland
    United KingdomBritish59134900001
    CLIBBORN, Patrick Booth
    Stream Farm
    Golford Road
    TN17 3NT Cranbrook
    Kent
    Administrateur
    Stream Farm
    Golford Road
    TN17 3NT Cranbrook
    Kent
    British65161450002
    DEVINE, Damien
    Paternoster Square
    EC4M 7AL London
    10
    England
    Administrateur
    Paternoster Square
    EC4M 7AL London
    10
    England
    EnglandBritish72832350001
    DEVINE, Damien
    Paternoster Square
    EC4M 7AL London
    10
    England
    Administrateur
    Paternoster Square
    EC4M 7AL London
    10
    England
    EnglandBritish72832350001
    FINEGOLD, Nicholas Mark
    Paternoster Square
    EC4M 7AL London
    10
    England
    Administrateur
    Paternoster Square
    EC4M 7AL London
    10
    England
    United KingdomBritish74031980002
    FROGGATT, Peter Mark
    White Rose Cottage
    Broomfield Park
    SL5 0JS Sunningdale
    Administrateur
    White Rose Cottage
    Broomfield Park
    SL5 0JS Sunningdale
    British112513130001
    GRANT, Adam Douglas Mortimer
    27 Warwicks Bench
    GU1 3TF Guildford
    Surrey
    Administrateur
    27 Warwicks Bench
    GU1 3TF Guildford
    Surrey
    EnglandBritish147687150001
    GREGORY, John Howard
    Fern House
    Whitchurch Road Cublington
    LU7 0LP Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Administrateur
    Fern House
    Whitchurch Road Cublington
    LU7 0LP Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    EnglandBritish49215480001
    HALL, Frank Matthew Sunderland
    Hillside
    Barrack Hill
    HP18 0DU Nether Winchendon
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Hillside
    Barrack Hill
    HP18 0DU Nether Winchendon
    Buckinghamshire
    EnglandAustralian97103350001
    HOMER, Peter Norman
    West Royd 53 John Street
    G84 9LY Helensburgh
    Dunbartonshire
    Administrateur
    West Royd 53 John Street
    G84 9LY Helensburgh
    Dunbartonshire
    British496850001
    JESSOP, Alan Dixon
    73 Cricketers Lane
    Brentwood
    CM13 3QB Essex
    Administrateur
    73 Cricketers Lane
    Brentwood
    CM13 3QB Essex
    British67849380002
    KARWOSKI, Jane Catherine
    16 Great Stuart Street
    EH3 7TN Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    16 Great Stuart Street
    EH3 7TN Edinburgh
    Midlothian
    American54275930001
    KIMBER, Timothy Roy Henry
    Newton Hall
    Whittington
    LA6 2NZ Carnforth
    Lancashire
    Administrateur
    Newton Hall
    Whittington
    LA6 2NZ Carnforth
    Lancashire
    EnglandBritish173030002
    LLEWELLYN-LLOYD, Edward John
    76 George Street
    Edinburgh
    EH2 3BU
    Administrateur
    76 George Street
    Edinburgh
    EH2 3BU
    EnglandBritish8369250002
    LUNA VAZ, Luis Miguel Pina
    Paternoster Square
    EC4M 7AL London
    10
    England
    Administrateur
    Paternoster Square
    EC4M 7AL London
    10
    England
    EnglandPortuguese159580950001
    MACPHERSON, Angus Robert
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    5
    Scotland
    Administrateur
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    5
    Scotland
    ScotlandBritish117526370001
    MATHEWSON, David Carr
    7 Barnton Park
    EH4 6JF Edinburgh
    Administrateur
    7 Barnton Park
    EH4 6JF Edinburgh
    ScotlandBritish380090002

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0